EC INSURANCE COMPANY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | EC INSURANCE COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01266206 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de EC INSURANCE COMPANY LIMITED?
- Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra EC INSURANCE COMPANY LIMITED?
| Dirección de la sede social | 20 Fenchurch Street EC3M 3AZ London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EC INSURANCE COMPANY LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ELECTRICAL CONTRACTORS' INSURANCE COMPANY LIMITED | 30 jun 1976 | 30 jun 1976 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de EC INSURANCE COMPANY LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para EC INSURANCE COMPANY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 jul 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 31 p áginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 jul 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Estado de capital el 16 dic 2020
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Cese del nombramiento de John William James Spencer como director el 30 nov 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew John Davies como director el 30 nov 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Anne Whitaker como director el 30 nov 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 07 ago 2020
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Christopher Barrett como director el 31 jul 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 39 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Wilson como director el 31 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 jul 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew John Bailey como secretario el 01 jul 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Lara Simone Teesdale como secretario el 01 jul 2019 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 39 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de EC INSURANCE COMPANY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEESDALE, Lara Simone | Secretario | Fenchurch Street EC3M 3AZ London 20 United Kingdom | 260051420001 | |||||||||||
| FORREST SMITH, Richard David | Director | Fenchurch Street EC3M 3AZ London 20 United Kingdom | England | British | 102435300002 | |||||||||
| GALJAARD, Neil Edward | Director | Fenchurch Street EC3M 3AZ London 20 United Kingdom | England | British | 204442520001 | |||||||||
| BAILEY, Andrew John | Secretario | Fenchurch Street EC3M 3AZ London 20 United Kingdom | 240711450001 | |||||||||||
| BOORMAN, John Edward | Secretario | 5 Birchwood Avenue DA14 4JY Sidcup Kent | British | 15508940001 | ||||||||||
| BROMLEY, Diane | Secretario | 24-26 South Park TN13 1DU Sevenoaks Eca Court Kent England | 198910410001 | |||||||||||
| BURNLEY, Martyn James | Secretario | 14 Rectory Road BR3 1HW Beckenham 12 Kent United Kingdom | British | 27337290001 | ||||||||||
| HUDSON, Roger William | Secretario | Esca House 32-34 Palace Crt W2 4HY Bayswater London | 158258790001 | |||||||||||
| CS SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 55 King Street M2 4LQ Manchester Fifth Floor England |
| 110006210003 | ||||||||||
| ELEMENTAL COSEC LIMITED | Secretario corporativo | Old Gloucester Street WC1N 3AX London 27 England |
| 197411090001 | ||||||||||
| ELEMENTAL COSEC LIMITED | Secretario corporativo | Old Gloucester Street WC1N 3AX London 27 England |
| 197411090001 | ||||||||||
| ABLETT, Timothy Andrew, The Estate Of Mr | Director | Esca House 32-34 Palace Crt W2 4HY Bayswater London | England | British | 65924000005 | |||||||||
| ADAMSON, William Richard | Director | 62 The Drive TN9 2LR Tonbridge Kent | United Kingdom | British | 58631570003 | |||||||||
| BARRETT, Simon Christopher | Director | Fenchurch Street EC3M 3AZ London 20 United Kingdom | United Kingdom | British | 265262510001 | |||||||||
| BELDHAM, David Thomas Anthony | Director | Esca House 32-34 Palace Crt W2 4HY Bayswater London | United Kingdom | British | 72444750001 | |||||||||
| BRATT, Stephen John | Director | 24-26 South Park TN13 1DU Sevenoaks Eca Court Kent England | United Kingdom | British | 157959100001 | |||||||||
| BROMLEY, Diane Elizabeth, Ma | Director | 24-26 South Park TN13 1DU Sevenoaks Eca Court Kent England | England | British | 149175470001 | |||||||||
| BROOKS, Stephen Thomas | Director | 24-26 South Park TN13 1DU Sevenoaks Eca Court Kent England | England | British | 43905590001 | |||||||||
| BROWN, Roger Stewart | Director | Somersbury 6 Stoneyfields GU9 8DX Farnham Surrey | United Kingdom | British | 31524860001 | |||||||||
| BURNLEY, Martyn James | Director | 24-26 South Park TN13 1DU Sevenoaks Eca Court Kent England | England | British | 155149100001 | |||||||||
| COCKERILL, Desmond Frank | Director | 54 Angel Hill SM1 3EW Sutton Surrey | United Kingdom | British | 1674730001 | |||||||||
| CRILLEY, Mark Stewart | Director | Esca House 32-34 Palace Crt W2 4HY Bayswater London | England | British | 64359420001 | |||||||||
| CROSBY, Ian Paul | Director | 56 Baldwins Hill IG10 1SF Loughton Essex | United Kingdom | British | 20521820001 | |||||||||
| DAVIES, Andrew John | Director | Fenchurch Street EC3M 3AZ London 20 United Kingdom | United Kingdom | British | 240686570001 | |||||||||
| DAWSON, Peter | Director | Whitfield 138 Whalley Road Wilpshire BB1 9LJ Blackburn | British | 77394370001 | ||||||||||
| FEARN, Garry Michael | Director | 24-26 South Park TN13 1DU Sevenoaks Eca Court Kent England | England | British | 50970000002 | |||||||||
| FORD, Arthur Bryan | Director | Deer Leap Southwell Road Oxton NG25 0RJ Nottingham | United Kingdom | British | 35677080001 | |||||||||
| GIFFEN, George | Director | Delaport Lodge Lamer Lane Wheathampstead AL4 8RQ St Albans Hertfordshire | British | 9652340003 | ||||||||||
| GUIRY, Paul Philip | Director | Fenchurch Street EC3M 3AZ London 20 United Kingdom | England | Irish | 202435410001 | |||||||||
| HALL, Robert Michael | Director | 55 Vastern Road RG1 8BU Reading Berkshire | British | 62702340002 | ||||||||||
| HANNAN, John Stephen | Director | 16 Hatchlands RH12 5JX Horsham West Sussex | United Kingdom | British | 102435400001 | |||||||||
| HOPE, Alistair Robert | Director | 16 Downs Cote Drive Westbury On Trym BS9 3TP Bristol Avon | England | British | 23445410001 | |||||||||
| HUMPHREYS, Peter David | Director | 38 Sargison Road RH16 1HX Haywards Heath West Sussex | United Kingdom | British | 102435480002 | |||||||||
| HURSTHOUSE, Trevoe George | Director | Lingwood Lane Woodborough NG14 6DX Nottingham The Old Vicarage Nottinghamshire | United Kingdom | British | 138919350001 | |||||||||
| JENNINGS, George William Bryan | Director | 52 Grove Park Terrace Chiswick W4 3QE London | British | 15508950001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de EC INSURANCE COMPANY LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markel Capital Holdings Limited | 28 nov 2017 | Fenchurch Street EC3M 3AZ London 20 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Ec Insurance Holdings Limited | 06 abr 2016 | South Park TN13 1DU Sevenoaks 24-25 Kent England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene EC INSURANCE COMPANY LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Memorandum of deposit and charge and escrow agreement | Creado el 11 mar 1994 Entregado el 12 mar 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the deed supplemental to risk excess of loss reinsurance agreement dated 11TH march 1994 | |
Breve descripción The bearer and reg: UK government debt securities as are deposited with the escrow agent pursuant to the provisions of the charge all other rights securities moneys and property in respect of the securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0