FARM GAS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | FARM GAS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01272438 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de FARM GAS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra FARM GAS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Lancaster House Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Cambridgeshire United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de FARM GAS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para FARM GAS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2021 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2020 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Awg Corporate Services Limited como secretario el 22 feb 2021 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Elizabeth Ann Horlock Clarke como secretario el 22 feb 2021 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Wayne Paul Young como director el 15 feb 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Jonathan David Forster el 30 jun 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2019 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 jul 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 jul 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 jul 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Ang Group Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 jul 2016 con actualizaciones | 24 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Claire Tytherleigh Russell como director el 28 jul 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Elizabeth Ann Horlock Clarke como director el 28 jul 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Lancaster House Lancaster Way Ermine Business Park Huntingdon Cambridgeshire PE29 6YJ a Lancaster House Lancaster Way Ermine Business Park Huntingdon Cambridgeshire PE29 6XU el 29 sept 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 07 jul 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de FARM GAS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG CORPORATE SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire United Kingdom |
| 270129230001 | ||||||||||
| FORSTER, Jonathan David | Director | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire United Kingdom | United Kingdom | British | 101812460002 | |||||||||
| RUSSELL, Claire Tytherleigh | Director | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire United Kingdom | England | British | 105433380001 | |||||||||
| YOUNG, Wayne Paul | Director | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire United Kingdom | United Kingdom | British | 264531200001 | |||||||||
| CLARKE, Elizabeth Ann Horlock | Secretario | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6YJ Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire United Kingdom | 198438490001 | |||||||||||
| FOX, Jacqueline Elizabeth | Secretario | Little Dormers 3 Wicken Road CB11 3QD Newport Essex | British | 35460890004 | ||||||||||
| GILLEN, Seamus Joseph | Secretario | 20 Mountway EN6 1EP Potters Bar Hertfordshire | British | 66174560001 | ||||||||||
| SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George | Secretario | Red Tiles 62 Park Road GU22 7DB Woking Surrey | British | 143104990001 | ||||||||||
| TURNER, David Charles | Secretario | 13 Thorndales St Johns Avenue CM14 5DE Brentwood Essex | Other | 84007940001 | ||||||||||
| ANDERSON, Mark Stephen | Director | Ambury Road PE29 3NZ Huntingdon Anglian House Cambs United Kingdom | England | British | 122463830003 | |||||||||
| CHESSHIRE, Michael James | Director | The Firs Steventon SY8 4BN Ludlow Salop | British | 33851510001 | ||||||||||
| CLARKE, Elizabeth Ann Horlock | Director | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6YJ Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire United Kingdom | United Kingdom | British | 195497270001 | |||||||||
| CROOM-JOHNSON, William Slade | Director | Highfield Horderley SY7 8HP Craven Arms Salop | British/Canadian | 47156150001 | ||||||||||
| DICKINSON, Roger Martin | Director | 36 Glapthorn Road PE8 4JQ Oundle Peterborough | British | 91579530001 | ||||||||||
| FIRTH, Patrick | Director | The Cottage High Street PE28 0AB Ellington Huntingdon Cambs | British | 85034900001 | ||||||||||
| GILLEN, Seamus Joseph | Director | 20 Mountway EN6 1EP Potters Bar Hertfordshire | England | British | 66174560001 | |||||||||
| HORLOCK, Elizabeth Ann | Director | 9 Ermine Court PE29 7SD Huntingdon Cambs | British | 110831950001 | ||||||||||
| LATHAM, David Charles Frederick | Director | Thicket Lodge Thicket Road Houghton PE17 2DB Huntingdon Cambridgeshire | British | 61429350001 | ||||||||||
| MALONEY, Robert John | Director | 33 Long Furlong CV22 5QT Rugby Warwickshire | British | 107772920001 | ||||||||||
| MANTLE, Jeremy | Director | West Wing Seifton Court Barns Seifton SY1 1DG Ludlow Shropshire | British | 52996050001 | ||||||||||
| NICOLL, Peter | Director | Westerlee Hawks Hill Guildford Road KT22 9DP Leatherhead Surrey | England | British | 17510150002 | |||||||||
| NIELD, Andrew Simon | Director | Ruhpolding Mill Lane Hemingford Grey PE18 9DQ Huntingdon Cambridgeshire | British | 69491180002 | ||||||||||
| NIELD, Andrew Simon | Director | Ruhpolding Mill Lane Hemingford Grey PE18 9DQ Huntingdon Cambridgeshire | British | 69491180002 | ||||||||||
| PEDDIE, James Barrie | Director | The Square House Tunnel Hill WR8 0QL Upton-On-Severn Worcester | British | 9761100001 | ||||||||||
| ROWLANDS, Harry Spencer | Director | 5 Unwin Crescent DY8 3UY Stourbridge West Midlands | England | British | 68150590001 | |||||||||
| RUSSELL, Claire Tytherleigh | Director | Southfields Brick House End, Berden CM23 1AZ Bishop's Stortford Herts | England | British | 105433380001 | |||||||||
| SAUNDERS, Malcolm Richard | Director | The Gullet Cottage Adforton SY7 0NQ Leintwardine Shropshire | British | 37427530001 | ||||||||||
| SUDBURY, Roger Graham | Director | 32 Park Lane CM23 3NH Bishops Stortford Hertfordshire | British | 82545120001 | ||||||||||
| TURNER, David Charles | Director | 13 Thorndales St Johns Avenue CM14 5DE Brentwood Essex | Other | 84007940001 | ||||||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Director | Ambury Road PE29 3NZ Huntingdon Anglian House Cambs United Kingdom | England | British | 135181230001 | |||||||||
| WARRACK, Anne Victoria Mary | Director | Ambury Road PE29 3NZ Huntingdon Anglian House Cambs United Kingdom | United Kingdom | British | 123157220001 | |||||||||
| WIJKMARK, Carl Goran | Director | Styrmansvagen 1 133 00 Saltsjobaden Sweden | Swedish | 34984690001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de FARM GAS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Awg Group Limited | 06 abr 2016 | Lancaster Way PE29 6XU Huntingdon Lancaster House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene FARM GAS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of charge | Creado el 10 ago 1987 Entregado el 11 ago 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £40,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descripción F/H units 1 & 2 love lane industrial estate, bishops castle, shropshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 04 mar 1987 Entregado el 24 mar 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Units 1 and 2 love lane industrial estate bishop castle shropshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 24 abr 1984 Entregado el 03 may 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0