ACRE EXPLORATION LIMITED

ACRE EXPLORATION LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaACRE EXPLORATION LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01272557
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ACRE EXPLORATION LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra ACRE EXPLORATION LIMITED?

    Dirección de la sede social
    100 Thames Valley Park Drive
    Reading
    RG6 1PT Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ACRE EXPLORATION LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DYAS EXPLORATION (U.K.) LIMITED09 sept 198609 sept 1986
    WESTAR EXPLORATION (U.K.) LIMITED21 jun 198321 jun 1983
    BCRIC EXPLORATION (U.K.) LIMITED26 ene 198226 ene 1982
    KAISER EXPLORATION (U.K.) LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    ASHBRAE FINANCE(U.K.)LIMITED10 ago 197610 ago 1976

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ACRE EXPLORATION LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para ACRE EXPLORATION LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ACRE EXPLORATION LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 11 sept 2014

    • Capital: GBP 1.00
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Daniela Hanuskova como secretario el 25 abr 2014

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Janette Buckley Miranda como secretario el 25 abr 2014

    2 páginasAP03

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Graham Hall como director el 02 ene 2014

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Chloe Silvana Barry como director el 13 ene 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Carol Elizabeth Bolton como director el 19 dic 2013

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Rebecca Louise Dunn como director el 13 ene 2014

    2 páginasAP01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2012

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2011

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Carol Susan Inman como secretario el 27 jul 2012

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Daniela Hanuskova como secretario el 27 jul 2012

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Rebecca Louise Dunn como secretario el 27 jul 2012

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de un director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Alan William Mcculloch como secretario el 27 abr 2012

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2010

    6 páginasAA

    Nombramiento de Rebecca Louise Dunn como secretario

    2 páginasAP03

    ¿Quiénes son los directivos de ACRE EXPLORATION LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MIRANDA, Janette Buckley
    Thames Valley Park Drive
    RG6 1PT Reading
    100
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Thames Valley Park Drive
    RG6 1PT Reading
    100
    Berkshire
    United Kingdom
    187431060001
    BARRY, Chloe Silvana
    100 Thames Valley Park Drive
    Reading
    RG6 1PT Berkshire
    Director
    100 Thames Valley Park Drive
    Reading
    RG6 1PT Berkshire
    United KingdomBritish92460210004
    DUNN, Rebecca Louise
    Thames Valley Park Drive
    RG6 1PT Reading
    100
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Thames Valley Park Drive
    RG6 1PT Reading
    100
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish148511710002
    DUNN, Rebecca Louise
    Thames Valley Park Drive
    RG6 1PT Reading
    100
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Thames Valley Park Drive
    RG6 1PT Reading
    100
    Berkshire
    United Kingdom
    162087970001
    GRIFFIN, John Edward Henry
    155 Cannon Lane
    HA5 1HU Pinner
    Middlesex
    Secretario
    155 Cannon Lane
    HA5 1HU Pinner
    Middlesex
    British4516200001
    GRIFFIN, John Edward Henry
    155 Cannon Lane
    HA5 1HU Pinner
    Middlesex
    Secretario
    155 Cannon Lane
    HA5 1HU Pinner
    Middlesex
    British4516200001
    HANUSKOVA, Daniela
    Thames Valley Park Drive
    RG6 1PT Reading
    100
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Thames Valley Park Drive
    RG6 1PT Reading
    100
    Berkshire
    United Kingdom
    170972180001
    HUGHES, Graham Paul
    Amoretto 70 Frithwood Lane
    CM12 9PW Billericay
    Essex
    Secretario
    Amoretto 70 Frithwood Lane
    CM12 9PW Billericay
    Essex
    British52315640001
    INMAN, Carol Susan
    100 Thames Valley Park Drive
    Reading
    RG6 1PT Berkshire
    Secretario
    100 Thames Valley Park Drive
    Reading
    RG6 1PT Berkshire
    British56112870003
    MCCULLOCH, Alan William
    100 Thames Valley Park Drive
    Reading
    RG6 1PT Berkshire
    Secretario
    100 Thames Valley Park Drive
    Reading
    RG6 1PT Berkshire
    British170986900001
    MOORE, Paul Anthony
    1 Holmlea Road
    Datchet
    SL3 9HG Slough
    Berkshire
    Secretario
    1 Holmlea Road
    Datchet
    SL3 9HG Slough
    Berkshire
    British84405770002
    SADLER, John Michael
    32 Tewkesbury Avenue
    HA5 5LH Pinner
    Middlesex
    Secretario
    32 Tewkesbury Avenue
    HA5 5LH Pinner
    Middlesex
    British1780560001
    BOLTON, Carol Elizabeth
    100 Thames Valley Park Drive
    Reading
    RG6 1PT Berkshire
    Director
    100 Thames Valley Park Drive
    Reading
    RG6 1PT Berkshire
    United KingdomBritish72801700001
    CHELLINGSWORTH, David Robert
    2 Selbourne Close
    New Haw
    KT15 3RG Addlestone
    Surrey
    Director
    2 Selbourne Close
    New Haw
    KT15 3RG Addlestone
    Surrey
    British68908410002
    GREGORY, Jack Lee
    4918 Westerham
    Fulshear
    Texas 77441
    Usa
    Director
    4918 Westerham
    Fulshear
    Texas 77441
    Usa
    American33544410003
    HALL, Graham
    100 Thames Valley Park Drive
    Reading
    RG6 1PT Berkshire
    Director
    100 Thames Valley Park Drive
    Reading
    RG6 1PT Berkshire
    United KingdomBritish93569090001
    HATTON, David Frederick
    33 Goldenacres
    Springfield
    CM1 5YT Chelmsford
    Essex
    Director
    33 Goldenacres
    Springfield
    CM1 5YT Chelmsford
    Essex
    British14442710001
    LEHMANN, Peter Julian, Dr
    28 Birchwood Road
    SW17 9BQ London
    Director
    28 Birchwood Road
    SW17 9BQ London
    British4493650001
    SCANTLEBURY, John Martin
    113 Rydes Hill Road
    GU2 9TY Guildford
    Surrey
    Director
    113 Rydes Hill Road
    GU2 9TY Guildford
    Surrey
    British36308550001
    SENIOR, Paul Michael
    1 Norrington Cottages
    Walkers Farm Lane
    CM6 1RX White Roding
    Essex
    Director
    1 Norrington Cottages
    Walkers Farm Lane
    CM6 1RX White Roding
    Essex
    British37034540001
    SHARMAN, Susan Jane
    5 Bray Gardens
    Pyrford
    GU22 8RX Woking
    Surrey
    Director
    5 Bray Gardens
    Pyrford
    GU22 8RX Woking
    Surrey
    British50254450001

    ¿Tiene ACRE EXPLORATION LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture as amended by a deed dated 2/7/85
    Creado el 10 jul 1985
    Entregado el 10 jul 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    By way of a fixed charge the company's percentage interest in the assigned interest (see doc M15 fo further details).
    Personas con derecho
    • Bow Valley Exploration (U.K) Limited
    Transacciones
    • 10 jul 1985Registro de una carga
    Scottish assignation dated 27/3/79 as corroborated by a corroborative assignation dated 2/7/85
    Creado el 10 jul 1985
    Entregado el 10 jul 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The company's wholse wright, title and interest of the assigned interest (see doc M14 for further details).
    Personas con derecho
    • Bow Valley Exploration (U.K) Limited.
    Transacciones
    • 10 jul 1985Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 08 oct 1982
    Entregado el 12 oct 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or any of the other companies named thereon to the chargees pursuant tothe financing documents as defined in the deed
    Breve descripción
    All the companies right, title and interest in the bcric interest, agreements, monies and all f/h & l/h property. More particularly describe by doc M13.
    Personas con derecho
    • Chemical Bank Interenational Limitedas Trustees
    Transacciones
    • 12 oct 1982Registro de una carga
    Scottish assignation
    Creado el 08 oct 1982
    Entregado el 12 oct 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees pursuant to the financing documents as defiend in the deed.
    Breve descripción
    All right, title & interest of the company in various licences, contracts, agreements, franchises etc as described in the schedule attached to doc m.
    Personas con derecho
    • Chemical B Bank International Limitedas Trustee
    Transacciones
    • 12 oct 1982Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0