THALES COMMUNICATIONS LIMITED

THALES COMMUNICATIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHALES COMMUNICATIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01272585
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THALES COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra THALES COMMUNICATIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    350 Longwater Avenue
    Green Park
    RG2 6GF Reading
    Berkshire
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THALES COMMUNICATIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    REDIFON MEL LIMITED30 jun 199530 jun 1995
    REDIFON LIMITED01 ene 199501 ene 1995
    REDIFON SPT LIMITED11 oct 199111 oct 1991
    SPT INTERNATIONAL LIMITED31 dic 198131 dic 1981
    SOUND POWERED INTERNATIONAL LIMITED11 ago 197611 ago 1976

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THALES COMMUNICATIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THALES COMMUNICATIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginasLIQ13

    Cambio de datos del director Mr Michael William Peter Seabrook el 02 ago 2017

    2 páginasCH01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Notification de Thales Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 jun 2017

    2 páginasPSC02

    Cessation de Thales One Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 jun 2017

    1 páginasPSC07

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 27 jun 2017

    LRESSP

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 21 jun 2017

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Cancellation of share premium account 20/06/2017
    RES13

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    5 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de 2 Dashwood Lang Road the Bourne Business Park Addlestone Weybridge Surrey KT15 2NX a 350 Longwater Avenue Green Park Reading Berkshire RG2 6GF el 09 may 2017

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Suzanne Jayne Stratton como director el 10 abr 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ewen Angus Mccrorie como director el 10 abr 2017

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 17 ago 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    5 páginasAA

    Nombramiento de Suzanne Jayne Stratton como director el 01 sept 2015

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Peter John Rowley como director el 31 ago 2015

    2 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 oct 2015

    Estado de capital el 06 oct 2015

    • Capital: GBP 9,500,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    9 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 oct 2014

    Estado de capital el 24 oct 2014

    • Capital: GBP 9,500,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    11 páginasAA

    Nombramiento de Peter John Rowley como director

    3 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de THALES COMMUNICATIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SEABROOK, Michael William Peter
    Longwater Avenue
    Green Park
    RG2 6GF Reading
    350
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Longwater Avenue
    Green Park
    RG2 6GF Reading
    350
    Berkshire
    United Kingdom
    British70900110002
    MCCRORIE, Ewen Angus
    Longwater Avenue
    Green Park
    RG2 6GF Reading
    350
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Longwater Avenue
    Green Park
    RG2 6GF Reading
    350
    Berkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritishFinance Director93611530001
    SEABROOK, Michael William Peter
    Longwater Avenue
    Green Park
    RG2 6GF Reading
    350
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Longwater Avenue
    Green Park
    RG2 6GF Reading
    350
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary70900110004
    HAAGEN, Jean Yves Bernard Francois
    Greenbanks
    Pewley Point Pewley Hill
    GU1 3SP Guildford
    Surrey
    Secretario
    Greenbanks
    Pewley Point Pewley Hill
    GU1 3SP Guildford
    Surrey
    French72580730001
    MOFFATT, William Paul
    Poplar Point
    The Village
    RG40 4JN Finchampstead
    Berkshire
    Secretario
    Poplar Point
    The Village
    RG40 4JN Finchampstead
    Berkshire
    British100550340002
    PARMENTER, Martin David, Mr.
    Cherrywood
    4 Keymer Gardens
    RH15 0AF Burgess Hill
    West Sussex
    Secretario
    Cherrywood
    4 Keymer Gardens
    RH15 0AF Burgess Hill
    West Sussex
    British14344050002
    PARMENTER, Martin David, Mr.
    Cherrywood
    4 Keymer Gardens
    RH15 0AF Burgess Hill
    West Sussex
    Secretario
    Cherrywood
    4 Keymer Gardens
    RH15 0AF Burgess Hill
    West Sussex
    British14344050002
    PORTER, Leonard
    110 Potters Lane
    RH15 9JN Burgess Hill
    West Sussex
    Secretario
    110 Potters Lane
    RH15 9JN Burgess Hill
    West Sussex
    British64130110001
    WADDELL, Susan Elizabeth
    3 Grange Close
    Three Bridges
    RH10 1SN Crawley
    West Sussex
    Secretario
    3 Grange Close
    Three Bridges
    RH10 1SN Crawley
    West Sussex
    British41379440001
    HAMMOND, Lawrence
    2 Dashwood Lang Road
    The Bourne Business Park
    KT15 2NX Addlestone Weybridge
    Surrey
    Director
    2 Dashwood Lang Road
    The Bourne Business Park
    KT15 2NX Addlestone Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director127063220001
    HIGGINS, John Michael
    Everyndens 109 High Street
    RH16 2HR Lindfield
    West Sussex
    Director
    Everyndens 109 High Street
    RH16 2HR Lindfield
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Director78393750001
    HORNE, David Robert Geoffrey
    The Timbers
    Coronation Road Littlewick Green
    SL6 3RA Maidenhead
    Berkshire
    Director
    The Timbers
    Coronation Road Littlewick Green
    SL6 3RA Maidenhead
    Berkshire
    BritainBritishAccountant31020910002
    MCNAMEE, Ian George
    8 Perryhill Cottages
    TN7 4JP Hartfield
    East Sussex
    Director
    8 Perryhill Cottages
    TN7 4JP Hartfield
    East Sussex
    BritishCompany Director43013110001
    MOFFATT, William Paul
    Poplar Point
    The Village
    RG40 4JN Finchampstead
    Berkshire
    Director
    Poplar Point
    The Village
    RG40 4JN Finchampstead
    Berkshire
    EnglandBritishSolicitor100550340002
    PARMENTER, Martin David, Mr.
    Cherrywood
    4 Keymer Gardens
    RH15 0AF Burgess Hill
    West Sussex
    Director
    Cherrywood
    4 Keymer Gardens
    RH15 0AF Burgess Hill
    West Sussex
    EnglandBritishChartered Accountant14344050002
    PORTER, Leonard
    110 Potters Lane
    RH15 9JN Burgess Hill
    West Sussex
    Director
    110 Potters Lane
    RH15 9JN Burgess Hill
    West Sussex
    BritishCompany Director64130110001
    PURVIS, Melvyn Arthur
    Blendworth 38 Rookwood Park
    RH12 1UB Horsham
    West Sussex
    Director
    Blendworth 38 Rookwood Park
    RH12 1UB Horsham
    West Sussex
    BritishDirector78833490001
    ROBERTS, Simon
    2 Dashwood Lang Road
    The Bourne Business Park
    KT15 2NX Addlestone Weybridge
    Surrey
    Director
    2 Dashwood Lang Road
    The Bourne Business Park
    KT15 2NX Addlestone Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director43241480001
    ROWLEY, Peter John
    2 Dashwood Lang Road
    The Bourne Business Park
    KT15 2NX Addlestone Weybridge
    Surrey
    Director
    2 Dashwood Lang Road
    The Bourne Business Park
    KT15 2NX Addlestone Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director108936930001
    STRATTON, Suzanne Jayne
    2 Dashwood Lang Road
    The Bourne Business Park
    KT15 2NX Addlestone Weybridge
    Surrey
    Director
    2 Dashwood Lang Road
    The Bourne Business Park
    KT15 2NX Addlestone Weybridge
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director201569480001
    VAUGHAN, Mark Andrew
    6 Ranelagh Crescent
    SL5 8LW Ascot
    Berkshire
    Director
    6 Ranelagh Crescent
    SL5 8LW Ascot
    Berkshire
    BritishChartered Management Accountan68864490001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de THALES COMMUNICATIONS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Thales Uk Limited
    Longwater Avenue
    RG2 6GF Reading
    350
    England
    20 jun 2017
    Longwater Avenue
    RG2 6GF Reading
    350
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalEnglish - Companies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House - Uk
    Número de registro868273
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Thales One Limited
    Dashwood Lang Road, Bourne Business Park
    KT15 2NX Addlestone
    2
    England
    06 abr 2016
    Dashwood Lang Road, Bourne Business Park
    KT15 2NX Addlestone
    2
    England
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalEnglish - Companies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House - Uk
    Número de registro2230719
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene THALES COMMUNICATIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage debenture
    Creado el 30 mar 1994
    Entregado el 06 abr 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the stockholders (as defined therein) on any account whatsoever and all monies due or to become due from the company to the chargee for itself and as agent for the stockholders under the terms of a guarantee of even date (as defined therein)
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 abr 1994Registro de un cargo (395)
    • 24 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 27 sept 1991
    Entregado el 10 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to the stockholders (as defined) on any account whatsoever and all moneys due or to become due from the company to natwest investment bank limited for itself as agent and for the stockholders under the terms of a guarantee dated 27TH september 1991 this entry was amended this 19TH day of february 1992 P.jones authorised officer
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transacciones
    • 10 oct 1991Registro de un cargo (395)
    • 09 abr 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 27 sept 1991
    Entregado el 10 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to the stockholders (as defined) on any account whatsoever and all moneys due or to become due from the company to natwest investment bank limited for itself as agent and for the stockholders under the terms of a guarantee dated 27TH september 1991 this entry was amended this 19TH day of february 1992 P.jones authorised officer
    Breve descripción
    See doc 395 for full details. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transacciones
    • 10 oct 1991Registro de un cargo (395)
    • 24 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 27 sept 1991
    Entregado el 09 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (See doc M173 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 09 oct 1991Registro de una carga
    • 28 dic 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 16 ago 1991
    Entregado el 23 ago 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 23 ago 1991Registro de una carga
    • 28 dic 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 16 ago 1991
    Entregado el 23 ago 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land and property at woodrolfe rd. Tollesbury, essex together with all buildings and fixtures thereon. Assigns the goodwill of the business (ifany).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 23 ago 1991Registro de una carga
    • 14 ene 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 25 mar 1991
    Entregado el 29 mar 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or holmes quest holdings limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    F/H property k/a being land at tollesbury, essex.
    Personas con derecho
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 29 mar 1991Registro de una carga
    • 16 oct 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 05 ene 1990
    Entregado el 15 ene 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Includingg trade & tenants fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 15 ene 1990Registro de una carga
    • 02 oct 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 02 oct 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of off set
    Creado el 05 ene 1990
    Entregado el 15 ene 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from holmequest holdings limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    The balances at credit of any accounts held by the chargee in the name of the company.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 15 ene 1990Registro de una carga
    • 16 oct 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 30 jul 1984
    Entregado el 10 ago 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 ago 1984Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 31 dic 1982
    Entregado el 18 ene 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land & buildings on the south side of woodrolfe road tolesbury essex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Coutts & Company
    Transacciones
    • 18 ene 1983Registro de una carga
    Mortgage debenture
    Creado el 19 abr 1982
    Entregado el 22 abr 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future includingg goodwill, bookdebts & uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Coutts & Company
    Transacciones
    • 22 abr 1982Registro de una carga

    ¿Tiene THALES COMMUNICATIONS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    27 jun 2017Inicio de la liquidación
    16 feb 2018Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0