FIRST OIL UK HOLDINGS LIMITED

FIRST OIL UK HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaFIRST OIL UK HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01282732
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de FIRST OIL UK HOLDINGS LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra FIRST OIL UK HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FIRST OIL UK HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TUSKAR UK HOLDINGS LIMITED15 nov 199515 nov 1995
    SHENANDOAH UK HOLDINGS LIMITED06 jun 198806 jun 1988
    HIGHLAND U.K. HOLDINGS LTD17 jul 198617 jul 1986
    LOCHIEL HOLDINGS LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    DEGLA LIMITED21 oct 197621 oct 1976

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de FIRST OIL UK HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para FIRST OIL UK HOLDINGS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para FIRST OIL UK HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Steven Richard George como director el 05 jun 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 30 abr 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 may 2015

    Estado de capital el 27 may 2015

    • Capital: GBP 802
    SH01

    Nombramiento de Mr Steven David Bowyer como director el 20 abr 2015

    AP01

    legacy

    PARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT1

    legacy

    3 páginasGUARANTEE1

    Déclaration annuelle établie au 30 abr 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital21 may 2014

    Estado de capital el 21 may 2014

    • Capital: GBP 802
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 abr 2013

    3 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01
    capital

    Resoluciones

    Other company business 16/05/2013
    RES13

    Registro de la carga 012827320006

    13 páginasMR01

    Déclaration annuelle établie au 30 abr 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Registro de la carga 012827320005

    42 páginasMR01

    Nombramiento de Mr Steven Richard George como director

    2 páginasAP01

    legacy

    3 páginasMG02

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 abr 2012

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 abr 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 abr 2011

    3 páginasAA

    legacy

    13 páginasMG01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Facility agreement 05/10/2011
    RES13
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    legacy

    18 páginasMG01

    legacy

    13 páginasMG01

    Déclaration annuelle établie au 30 abr 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Stephen Grant como secretario

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de FIRST OIL UK HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BOWYER, Steven David
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    Director
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    United KingdomBritishManaging Director128424830001
    SUTTIE, Ian Alexander, Mr.
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    Director
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    ScotlandBritishCompany Director52794240001
    CARROLL, Stephen
    6 Merrion Crescent
    Booterstown
    County Dublin
    Ireland
    Secretario
    6 Merrion Crescent
    Booterstown
    County Dublin
    Ireland
    Irish36244540001
    GEORGE, Steven Richard
    96 Margaret Place
    AB10 7GB Aberdeen
    Secretario
    96 Margaret Place
    AB10 7GB Aberdeen
    OtherChartered Accountant126930530001
    GRANT, Stephen
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    Secretario
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    BritishChartered Accountant139292040001
    MAHONY, Patrick Gerald
    103 Rath Farnham Wood
    IRISH Dublin 14
    Ireland
    Secretario
    103 Rath Farnham Wood
    IRISH Dublin 14
    Ireland
    Irish173542290001
    MEARNS, Steven Macdonald
    26 Concraig Park
    Kingswells
    AB15 8DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secretario
    26 Concraig Park
    Kingswells
    AB15 8DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    British115242820001
    PAULL & WILLIAMSONS
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Secretario corporativo
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    24280001
    BOARDMAN, Angela
    180 Anderson Drive
    AB15 6DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    Director
    180 Anderson Drive
    AB15 6DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishChartered Accountant70821770001
    BROWN, Emmet Kevin
    45 Lower Dodder Road
    IRISH Rathfarnham
    Dublin 14
    Ireland
    Director
    45 Lower Dodder Road
    IRISH Rathfarnham
    Dublin 14
    Ireland
    IrelandIrishGeologist126870510001
    CARROLL, Stephen
    6 Merrion Crescent
    Booterstown
    County Dublin
    Ireland
    Director
    6 Merrion Crescent
    Booterstown
    County Dublin
    Ireland
    IrishAccountant36244540001
    FORBES, Graham Andrew
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    Director
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    ScotlandBritishChartered Accountant83876980001
    GEORGE, Steven Richard
    Queens Terrace
    AB10 1XL Aberdeen
    1
    Scotland
    Director
    Queens Terrace
    AB10 1XL Aberdeen
    1
    Scotland
    ScotlandBritishChartered Accountant161491510001
    GRANT, Donald Alexander
    Brentwood, 16 North Deeside Road
    Bieldside
    AB15 9AB Aberdeen
    Director
    Brentwood, 16 North Deeside Road
    Bieldside
    AB15 9AB Aberdeen
    ScotlandBritishCompany Director60152030001
    JONES, Thomas Axel
    20 Craigmarn Road
    Portlethen
    AB12 4QR Aberdeen
    Aberdeenshire
    Director
    20 Craigmarn Road
    Portlethen
    AB12 4QR Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishCompany Director63516810001
    LANDER, John Hugh Russell
    Camelot
    26 The Island
    KT7 0SH Thames Ditton
    Surrey
    Director
    Camelot
    26 The Island
    KT7 0SH Thames Ditton
    Surrey
    EnglandBritishManaging Director1126370003
    MAHONY, Patrick Gerald
    103 Rath Farnham Wood
    IRISH Dublin 14
    Ireland
    Director
    103 Rath Farnham Wood
    IRISH Dublin 14
    Ireland
    IrelandIrishChartered Accountant173542290001
    MCGREGOR, Duncan Alexander
    New Town Lodge Stud
    IRISH Kildare
    Ireland
    Director
    New Town Lodge Stud
    IRISH Kildare
    Ireland
    BritishConsultant17181720001
    STANLEY, James
    5 Blenheim Avenue
    St Saviour
    CHANNEL Jersey
    Channel Islands
    Director
    5 Blenheim Avenue
    St Saviour
    CHANNEL Jersey
    Channel Islands
    Irish2334710001
    TRAYNOR, Frank Joseph
    34 Rathdown Park
    IRISH Terenure
    Dublin
    Ireland
    Director
    34 Rathdown Park
    IRISH Terenure
    Dublin
    Ireland
    IrishEngineer36244370001

    ¿Tiene FIRST OIL UK HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 17 jul 2013
    Entregado el 25 jul 2013
    Pendiente
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Ian Alexander Suttie
    Transacciones
    • 25 jul 2013Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 16 may 2013
    Entregado el 22 may 2013
    Pendiente
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Bnp Paribas in Its Capacity as Security Trustee for Itself and on Behalf of the Finance Parties
    Transacciones
    • 22 may 2013Registro de una carga (MR01)
    Deed of amendment to debenture
    Creado el 23 nov 2011
    Entregado el 01 dic 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Ian Alexander Suttie
    Transacciones
    • 01 dic 2011Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 05 oct 2011
    Entregado el 21 oct 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Ian Alexander Suttie
    Transacciones
    • 21 oct 2011Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 05 oct 2011
    Entregado el 21 oct 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bnp Paribas
    Transacciones
    • 21 oct 2011Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 19 oct 2004
    Entregado el 02 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Trustee Foritself and for and on Behalf of the Finance Parties)
    Transacciones
    • 02 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 05 mar 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0