QUASAR INTERNATIONAL COMMUNICATIONS LIMITED

QUASAR INTERNATIONAL COMMUNICATIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaQUASAR INTERNATIONAL COMMUNICATIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01289207
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de QUASAR INTERNATIONAL COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra QUASAR INTERNATIONAL COMMUNICATIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    John Carpenter House
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de QUASAR INTERNATIONAL COMMUNICATIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SPL ASSOCIATES LIMITED11 nov 198511 nov 1985
    SPP BOOKS LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    RUBYHART LIMITED03 dic 197603 dic 1976

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de QUASAR INTERNATIONAL COMMUNICATIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para QUASAR INTERNATIONAL COMMUNICATIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    5 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 ago 2012

    Estado de capital el 01 ago 2012

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cese del nombramiento de Stephen John Bradley como director el 27 feb 2012

    1 páginasTM01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Nombramiento de Mr Stephen John Bradley como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Robert Marcus como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Robert Marcus como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Stephen John Bradley como secretario

    1 páginasAP03

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Michael Thomas Danson el 31 jul 2011

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Simon John Pyper el 31 jul 2011

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    6 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    Nombramiento de Mr Robert Marcus como secretario

    1 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Robert John Marcus como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kenneth Appiah como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Kenneth Appiah como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008

    6 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de QUASAR INTERNATIONAL COMMUNICATIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRADLEY, Stephen John
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    United Kingdom
    Secretario
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    United Kingdom
    162178300001
    DANSON, Michael Thomas
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    United Kingdom
    Director
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    United Kingdom
    EnglandEnglish153950570001
    PYPER, Simon John
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    United Kingdom
    Director
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    United Kingdom
    EnglandBritish153726090002
    APPIAH, Kenneth
    7 Steventon Road
    Shepherds Bush
    W12 0SX London
    Secretario
    7 Steventon Road
    Shepherds Bush
    W12 0SX London
    British91575310001
    MARCUS, Robert
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    United Kingdom
    Secretario
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    United Kingdom
    150560180001
    SADLER, Keith John
    12 Parrys Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TT Bristol
    Avon
    Secretario
    12 Parrys Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TT Bristol
    Avon
    British73173100006
    SMITH, Nigel William
    Hermitage Dairy
    Whitwell
    PO38 2PD Ventnor
    Isle Of Wight
    Secretario
    Hermitage Dairy
    Whitwell
    PO38 2PD Ventnor
    Isle Of Wight
    British3494580003
    THORNTON, Oliver Luke
    Via Gioberti 26
    Valrontasca
    Vigliano D'Asti 14040
    Italy
    Secretario
    Via Gioberti 26
    Valrontasca
    Vigliano D'Asti 14040
    Italy
    British83584850002
    WATSON, Derek Stephen
    2 Pattison Road
    NW2 2HH London
    Secretario
    2 Pattison Road
    NW2 2HH London
    British65278090001
    APPIAH, Kenneth
    7 Steventon Road
    Shepherds Bush
    W12 0SX London
    Director
    7 Steventon Road
    Shepherds Bush
    W12 0SX London
    EnglandBritish91575310001
    BRADLEY, Stephen John
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    United Kingdom
    Director
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    United Kingdom
    EnglandBritish186484450001
    COUGHLAN, Daniel Michael
    Pippins
    15 Pinewood Green
    SL0 0QL Iver Heath
    Buckinghamshire
    Director
    Pippins
    15 Pinewood Green
    SL0 0QL Iver Heath
    Buckinghamshire
    British10808160001
    DAVIDSON, Stephen James
    Hughenden Close
    Denner Hill
    HP16 0JJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    Director
    Hughenden Close
    Denner Hill
    HP16 0JJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish92784240001
    GARMAN, Laurence Simon
    12 St Johns Grove
    TW9 2SP Richmond
    Surrey
    Director
    12 St Johns Grove
    TW9 2SP Richmond
    Surrey
    British17106230001
    HAINES, Christopher John Minton
    Cheshunts
    Boxted
    CO4 5SY Colchester
    Essex
    Director
    Cheshunts
    Boxted
    CO4 5SY Colchester
    Essex
    British18221380001
    JORDAN, Robert Stephen
    The Dell Hawks Hill Close
    Fetcham
    KT22 9DL Leatherhead
    Surrey
    Director
    The Dell Hawks Hill Close
    Fetcham
    KT22 9DL Leatherhead
    Surrey
    British55868860001
    KESSELER, Simone Elizabeth
    21 Hollingbourne Road
    SE24 9NB London
    Director
    21 Hollingbourne Road
    SE24 9NB London
    British73306960001
    MARCUS, Robert John
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    United Kingdom
    Director
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    United Kingdom
    United KingdomBritish259496160001
    NICHOLSON, Steven Peter
    9 Lime Avenue
    Blackmore End
    AL4 8LQ Wheathampstead
    Hertfordshire
    Director
    9 Lime Avenue
    Blackmore End
    AL4 8LQ Wheathampstead
    Hertfordshire
    British94372600001
    PRESTON, Michael David
    8 Oakhill Park Mews
    NW3 7LH London
    Director
    8 Oakhill Park Mews
    NW3 7LH London
    UsaBritish60846250001
    SADLER, Keith John
    3 Clifton High Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TU Bristol
    Director
    3 Clifton High Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TU Bristol
    EnglandBritish73173100007
    SUMMERS, Robert Michael
    6 Woodtree Close
    Hendon
    NW4 1HQ London
    Director
    6 Woodtree Close
    Hendon
    NW4 1HQ London
    EnglandBritish17363480001
    WATSON, Derek Stephen
    2 Pattison Road
    NW2 2HH London
    Director
    2 Pattison Road
    NW2 2HH London
    United KingdomBritish65278090001
    WILTON, Frank
    13 Sansom Street
    SE5 7RD Camberwell
    London
    Director
    13 Sansom Street
    SE5 7RD Camberwell
    London
    British113182670001
    WRIGHT, Lionel Henry
    115 Cranston Park Avenue
    RM14 3XJ Upminster
    Essex
    Director
    115 Cranston Park Avenue
    RM14 3XJ Upminster
    Essex
    British17363500002

    ¿Tiene QUASAR INTERNATIONAL COMMUNICATIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A deed of amendment to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 14 september 1993
    Creado el 20 ene 2005
    Entregado el 28 ene 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 28 ene 2005Registro de un cargo (395)
    • 19 oct 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 14TH september 1993
    Creado el 09 dic 2003
    Entregado el 20 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 20 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 19 oct 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture deed
    Creado el 17 mar 1998
    Entregado el 01 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 01 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 19 oct 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creado el 28 sept 1987
    Entregado el 08 oct 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or sterling publications LTD to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 oct 1987Registro de una carga
    • 26 ago 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0