HAMMOND-HOPKINS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | HAMMOND-HOPKINS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01294035 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HAMMOND-HOPKINS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra HAMMOND-HOPKINS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HAMMOND-HOPKINS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HAMMOND-HOPKINS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Nombramiento de Hanns Martin Lipp como director el 21 dic 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Thorsten Beer como director el 21 dic 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 jul 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2014 au 31 mar 2015 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 jul 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mrs Wendy Margaret Hall como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Shepherd como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 jul 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Thorsten Beer como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Willetts como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Nichola Louise Legg como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jennifer Brierley como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 jul 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr William Shepherd como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Smerdon como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de HAMMOND-HOPKINS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGG, Nichola Louise | Secretario | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | 163214890001 | |||||||
| HALL, Wendy Margaret | Director | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | England | British | 172979860001 | |||||
| LIPP, Hanns Martin | Director | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | United Kingdom | German | 220582440001 | |||||
| BRADLEY, Roger Watson | Secretario | 30 Moorhead Terrace Nab Wood BD18 4LB Shipley West Yorkshire | British | 104475190001 | ||||||
| BRIERLEY, Jennifer Anne | Secretario | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | British | 118563210001 | ||||||
| DAVIES, John Richard Bridge | Secretario | Amberley 5 Primrose Hill Waste Lane CW6 0PE Kelsall Cheshire | British | 51554100001 | ||||||
| HEATON, Janet Ruth | Secretario | 7 Hunters Row Portland Street LE9 1TQ Cosby Leicestershire | British | 81228260001 | ||||||
| MURPHY, Francis Joseph | Secretario | Oakmere Murieston Road WA15 9SU Hale Cheshire | British | 32866430003 | ||||||
| SMERDON, Peter | Secretario | 40 Stoneton Crescent Balsall Common CV7 7QG Coventry Warwickshire | British | 16898700002 | ||||||
| STEWART, Brian | Secretario | 12 Fulwell Park Avenue TW2 5HQ Twickenham Middlesex | British | 980530001 | ||||||
| BEER, Thorsten | Director | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | United Kingdom | German | 172030260001 | |||||
| BIRMINGHAM, Terence John | Director | Tall Trees Ferry Road DN19 7BA Barrow Upon Humber South Humberside | British | 8572180001 | ||||||
| ENGLAND, Philip Nicholas | Director | 5 Park Avenue Peper Harrow Park GU8 6BA Godalming Surrey | British | 43835770003 | ||||||
| FOSTER, Charles Henry | Director | Walkington House Townend Road Walkington HU17 8SY Beverley North Humberside | British | 41225420001 | ||||||
| GREENHALGH, Gary | Director | Washdyke Farm Lincoln Road NG32 3HY Fulbeck Lincolnshire | United Kingdom | British | 1192810001 | |||||
| HOOD, John | Director | 27 Medina House, Diglis Dock Road WR5 3DD Worcester | British | 39644740002 | ||||||
| KERSHAW, Graham Anthony | Director | Selsley House Westhorpe LE16 9UL Sibbertoft Leicestershire | United Kingdom | British | 8991780003 | |||||
| KING, Richard William | Director | 2 Long Garden Mews Long Garden Walk GU9 7HX Farnham Surrey | British | 38834940003 | ||||||
| MAJOR, Michael Evelyn | Director | 1 Frobisher Gardens GU1 2NT Guildford Surrey | British | 31230890001 | ||||||
| MCLINTOCK, Clive Holt | Director | 1 Blackhall Place Blackhall Lane TN15 0HT Sevenoaks Kent | British | 66692740001 | ||||||
| MEISTER, Stefan Mario | Director | Rosengartenstrasse 19 70184 Stuttgart Germany | Swiss | 43550520003 | ||||||
| MISCHKE, Gerhard Viktor | Director | Whitehill Farmhouse Alderminster CV37 8BW Stratford Upon Avon Warwickshire | Germany | 62107000001 | ||||||
| ORME, Allan Cameron | Director | Cornerstones Lime Walk Dibden Purlieu SO4 5RB Southampton Hampshire | British | 1271730001 | ||||||
| SHEPHERD, William | Director | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Great Britain | British | 162873980001 | |||||
| SMERDON, Peter | Director | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 16898700002 | |||||
| STEWART, Brian | Director | 12 Fulwell Park Avenue TW2 5HQ Twickenham Middlesex | England | British | 980530001 | |||||
| TAYLOR, David Leslie | Director | Woodbank Wilmslow Park SK9 2BA Wilmslow Cheshire | Gb-Eng | British | 10776940001 | |||||
| VIZARD, Ronald Charles, Harold | Director | Fieldfare Pigeon Green, Snitterfield CV37 OLP Stratford-Upon-Avon Warwickshire | British | 122881190001 | ||||||
| WICKS, David Frederick | Director | 8 Gloucester Drive Kempshott Rise RG22 4PH Basingstoke Hampshire | British | 1257240001 | ||||||
| WILLETTS, Andrew John | Director | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 120451550002 |
¿Tiene HAMMOND-HOPKINS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creado el 29 abr 1978 Entregado el 17 may 1978 | Pendiente | Cantidad garantizada £8,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. | |
Breve descripción 2 queen mary avenue cleethorpes humberside. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage | Creado el 29 abr 1978 Entregado el 08 may 1978 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Freehold lands & premises 2 queen mary avenue, cleethorpes south humberside. Together with all fixtures whatsoever. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge | Creado el 24 jun 1977 Entregado el 01 jul 1977 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0