SSL RETAIL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSSL RETAIL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01296016
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SSL RETAIL LIMITED?

    • Otra venta al por menor no en tiendas, puestos o mercados (47990) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra SSL RETAIL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Kpmg Llp
    1 St Peter'S Square
    M2 3AE Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SSL RETAIL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    OLYMPUS SPORT INTERNATIONAL LIMITED30 jun 198530 jun 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SSL RETAIL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta29 ene 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para SSL RETAIL LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SSL RETAIL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Informe de progreso del administrador hasta 25 sept 2015

    23 páginas2.24B

    Aviso de cambio de la administración a la disolución el 25 sept 2015

    23 páginas2.35B

    Informe de progreso del administrador hasta 02 jul 2015

    21 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 02 ene 2015

    22 páginas2.24B

    Domicilio social registrado cambiado de Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE a Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE el 28 ene 2015

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Kpmg Llp St. James's Square Manchester Lancashire M2 6DS a Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE el 28 ene 2015

    2 páginasAD01

    Informe de progreso del administrador hasta 02 jul 2014

    23 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 02 ene 2014

    24 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 02 jul 2013

    24 páginas2.24B

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Informe de progreso del administrador hasta 31 mar 2013

    24 páginas2.24B

    Domicilio social registrado cambiado de * J J B Sports Plc Martland Park Challenge Way Wigan Lancashire WN5 0LD* el 20 dic 2012

    2 páginasAD01

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Declaración de la propuesta del administrador

    35 páginas2.17B

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    6 páginas2.16B

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Cese del nombramiento de Keith Jones como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 ene 2012

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 jun 2012

    Estado de capital el 08 jun 2012

    • Capital: GBP 40,135,000
    SH01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Company business 26/04/2012
    RES13

    legacy

    15 páginasMG01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 ene 2011

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mr Keith John Jones como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de SSL RETAIL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WILLIAMS, David Robert
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Secretario
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    161511810001
    WILLIAMS, David Robert
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Director
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish157062220001
    ASHBY, Jonathan
    Hinckley Court
    CW12 4WE Congleton
    1
    Cheshire
    Secretario
    Hinckley Court
    CW12 4WE Congleton
    1
    Cheshire
    British134682180001
    FOOT, Peter John Lewis
    1 Normanton Lane
    Stanford On Soar
    LE12 5PZ Loughborough
    Leicestershire
    Secretario
    1 Normanton Lane
    Stanford On Soar
    LE12 5PZ Loughborough
    Leicestershire
    British51176110002
    GREENWOOD, John David
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Secretario
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    British4527320003
    HEATHER, John Langdale
    32 Beauchamp Avenue
    CV32 5TA Leamington Spa
    Warwickshire
    Secretario
    32 Beauchamp Avenue
    CV32 5TA Leamington Spa
    Warwickshire
    British33307810001
    KAYE, David Stanley
    56 Castleton Drive
    Newton Mearns
    G77 5LE Glasgow
    Secretario
    56 Castleton Drive
    Newton Mearns
    G77 5LE Glasgow
    British78278710002
    MADELEY, David Phillip
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    Secretario
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    British128847520001
    MANNING, Richard Denley John
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    Secretario
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    152719260001
    SIMKINS, Paul Charles
    49 Hazel Crescent
    NN12 6UQ Towcester
    Northamptonshire
    Secretario
    49 Hazel Crescent
    NN12 6UQ Towcester
    Northamptonshire
    British37115350001
    CLAIRMONTS SOLICITORS
    9 Clairmont Gardens
    G3 7LW Glasgow
    Secretario corporativo
    9 Clairmont Gardens
    G3 7LW Glasgow
    44581680001
    SEARS SPORTS AND LEISUREWEAR PLC
    Sunningdale Road
    LE3 1TP Leicester
    Secretario corporativo
    Sunningdale Road
    LE3 1TP Leicester
    16600870001
    CHAMBERLAIN, Adrian
    Butlers Hall
    Wareside
    SG12 7QL Ware
    Hertfordshire
    Director
    Butlers Hall
    Wareside
    SG12 7QL Ware
    Hertfordshire
    British117106730001
    CLIFFORD, Timothy David Ordish
    Flint House
    Hatherden
    SP11 0HP Andover
    Hampshire
    Director
    Flint House
    Hatherden
    SP11 0HP Andover
    Hampshire
    British44473790001
    COPPOCK, Lawrence Patrick
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    Director
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    EnglandUnited Kingdom152718990001
    DAVIES, Philip Norman
    62 Cunningham Drive
    LE17 4YR Lutterworth
    Leicestershire
    Director
    62 Cunningham Drive
    LE17 4YR Lutterworth
    Leicestershire
    British30542390001
    DUNN, Barry John Keith
    The Farm House
    Back Lane Heath Charnock
    PR6 9DJ Chorley
    Director
    The Farm House
    Back Lane Heath Charnock
    PR6 9DJ Chorley
    United KingdomBritish60493690005
    FALLON, John Edward
    Gardeners Cottage Old Hall Drive
    Widmerpool Keyworth
    NG12 5PZ Nottingham
    Director
    Gardeners Cottage Old Hall Drive
    Widmerpool Keyworth
    NG12 5PZ Nottingham
    British52124910001
    GLANVILLE, Richard
    Crooked Willows
    Wash Road
    SS15 4BP Basildon
    Essex
    Director
    Crooked Willows
    Wash Road
    SS15 4BP Basildon
    Essex
    British69669910004
    GRABINER, Ian Michael
    Daylesford
    5 Methven Road
    G46 6TG Glasgow
    Director
    Daylesford
    5 Methven Road
    G46 6TG Glasgow
    ScotlandBritish63235540002
    GREEN, Philip Nigel Ross, Sir
    129 Marylebone Road
    London
    Nw1 5qd
    Director
    129 Marylebone Road
    London
    Nw1 5qd
    United KingdomBritish103945640001
    GREENWOOD, John David
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Director
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritish4527320003
    GUNTER, Kevin
    9 Hawthorn Drive
    Uppingham
    LE15 9TA Oakham
    Leicestershire
    Director
    9 Hawthorn Drive
    Uppingham
    LE15 9TA Oakham
    Leicestershire
    British55255580001
    HELME, John Frederick
    23 Peacock Place
    NN1 2DP Northampton
    Northamptonshire
    Director
    23 Peacock Place
    NN1 2DP Northampton
    Northamptonshire
    British34463520002
    HUNTER, Thomas Blane, Sir
    Ladykirk House
    Ladykirk Estate
    KA9 2SF Monkton
    Director
    Ladykirk House
    Ladykirk Estate
    KA9 2SF Monkton
    United KingdomBritish97904280003
    JONES, Andrew Gethin
    Orchard Bank Button Bridge Lane
    DY12 3DN Bewdley
    Worcestershire
    Director
    Orchard Bank Button Bridge Lane
    DY12 3DN Bewdley
    Worcestershire
    British57400720001
    JONES, Anthony David
    32 Howe Lane
    LE7 7LB Rothley
    Leicestershire
    Director
    32 Howe Lane
    LE7 7LB Rothley
    Leicestershire
    British41640680002
    JONES, Keith John
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    Director
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish149574500001
    KINNAIRD, John
    1 Courthill
    Bearsden
    G61 3SN Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    1 Courthill
    Bearsden
    G61 3SN Glasgow
    Lanarkshire
    British70691510002
    KNIGHT, Thomas William
    Flat 5 Eastfield House
    15 Moor Road South
    NE3 1ND Gosforth
    Director
    Flat 5 Eastfield House
    15 Moor Road South
    NE3 1ND Gosforth
    British11423040008
    LOVELOCK, Derek John
    Oldfields Farm
    Amersham Road
    HP9 2UG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Oldfields Farm
    Amersham Road
    HP9 2UG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116560620001
    LUSTMAN, Margaret Eve
    25 Sherriff Road
    NW6 2AS London
    Director
    25 Sherriff Road
    NW6 2AS London
    British40930620001
    MADELEY, David Phillip
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    Director
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    EnglandBritish128847520001
    MANNING, Richard Denley John
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    Director
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    EnglandBritish77961690002
    MCCLUSKEY, Brian
    5b Longbank Road
    Alloway
    KA7 4SA Ayr
    Ayrshire
    Uk
    Director
    5b Longbank Road
    Alloway
    KA7 4SA Ayr
    Ayrshire
    Uk
    British68223140002

    ¿Tiene SSL RETAIL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 27 abr 2012
    Entregado el 04 may 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and from each other chargor (except as guarantor for the company) to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Security Agent for the Finance Parties)
    Transacciones
    • 04 may 2012Registro de un cargo (MG01)
    Guarantee & debenture
    Creado el 03 jun 2009
    Entregado el 17 jun 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 17 jun 2009Registro de un cargo (395)
    Account charge
    Creado el 17 dic 2008
    Entregado el 24 dic 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever
    Breve descripción
    All of the chargor's rights,title and interest from time to time in and to each charged asset see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for Itself and Bank of Scotland PLC and Kaupthing Singer & Friedlander Limited
    Transacciones
    • 24 dic 2008Registro de un cargo (395)
    • 21 jul 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 06 oct 2008
    Entregado el 11 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Kaupthing Singer & Friedlander Limited
    Transacciones
    • 11 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 21 jul 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 26 sept 2008
    Entregado el 02 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 11 dic 2009Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 07 abr 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creado el 26 sept 2008
    Entregado el 29 sept 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 29 sept 2008Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 03 abr 1996
    Entregado el 17 abr 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 abr 1996Registro de un cargo (395)
    • 25 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 26 nov 1995
    Entregado el 30 nov 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 30 nov 1995Registro de un cargo (395)
    • 11 mar 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene SSL RETAIL LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    01 oct 2012Inicio de la administración
    25 sept 2015Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Profesional
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    David James Costley-Wood
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester
    Profesional
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0