CPC 2010 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCPC 2010 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01297210
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CPC 2010 LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra CPC 2010 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Derby Road
    DE13 0BH Burton-On-Trent
    Staffordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CPC 2010 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CPK AUTO PRODUCTS LIMITED31 dic 197731 dic 1977
    TRANHILL LIMITED04 feb 197704 feb 1977

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CPC 2010 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para CPC 2010 LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CPC 2010 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 may 2014

    Estado de capital el 28 may 2014

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Bruno Camisasca como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Bruno Carlo Maria Camisasca como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Glen Andrews como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Charanjit Singh Sagoo como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Flavio Cateni como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    7 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed cpk auto products LIMITED\certificate issued on 25/10/10
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    25 oct 2010

    NOTICE OF CHANGE OF NAME NM01 - RESOLUTION

    CONNOT

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 29 sept 2010

    RES15

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    7 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    7 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de CPC 2010 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SAGOO, Charanjit Singh
    Cherrywood Road
    Streetly
    B74 3RT Sutton Coldfield
    33
    West Midlands
    Secretario
    Cherrywood Road
    Streetly
    B74 3RT Sutton Coldfield
    33
    West Midlands
    British140904140001
    ANDREWS, Glen
    Derby Road
    DE13 0BH Burton-On-Trent
    Staffordshire
    Director
    Derby Road
    DE13 0BH Burton-On-Trent
    Staffordshire
    EnglandEnglishExecutive168024040001
    SAGOO, Charanjit Singh
    Derby Road
    DE13 0BH Burton-On-Trent
    Staffordshire
    Director
    Derby Road
    DE13 0BH Burton-On-Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishExecutive168018390001
    SANDIVASCI, Dominic Antonio
    2 Whirlow Grange Avenue
    S11 9RW Sheffield
    Director
    2 Whirlow Grange Avenue
    S11 9RW Sheffield
    EnglandItalianExecutive61626380002
    PAGE, Richard Harvey
    14 Barby Road
    Kilsby
    CV23 8XD Rugby
    Warwickshire
    Secretario
    14 Barby Road
    Kilsby
    CV23 8XD Rugby
    Warwickshire
    British75981030001
    PIPER, David John
    Cherry Tree Cottage
    Highmoor
    RG9 5DH Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secretario
    Cherry Tree Cottage
    Highmoor
    RG9 5DH Henley On Thames
    Oxfordshire
    British8673860001
    SODERBERG, John Warren
    36 Netherhall Gardens
    Flat 3 Hampstead
    NW3 5TP London
    Secretario
    36 Netherhall Gardens
    Flat 3 Hampstead
    NW3 5TP London
    American76253090002
    SYKES, Jeremy Patrick Nelson
    Flat 3 Riley House
    Ann Lane
    SW10 0BS London
    Secretario
    Flat 3 Riley House
    Ann Lane
    SW10 0BS London
    British53768840001
    ARIOLI, Massimo Luca, Dr
    17 Manor Rise
    WS14 9SL Lichfield
    Director
    17 Manor Rise
    WS14 9SL Lichfield
    ItalianExecutive92955960002
    BAVESTRELLI, Luciano
    Beech House 35 Burton Road
    Repton
    DE65 6FN Derby
    Derbyshire
    Director
    Beech House 35 Burton Road
    Repton
    DE65 6FN Derby
    Derbyshire
    ItalianExecutive8524830001
    BIANCONI, Carlo
    The Old Rectory Church Lane
    Dalbury
    DE6 5BR Ashbourne
    Derbyshire
    Director
    The Old Rectory Church Lane
    Dalbury
    DE6 5BR Ashbourne
    Derbyshire
    ItalianExecutive55625830002
    BOCCHIO, Fabio
    466 Lichfield Road
    Four Oaks
    B74 4EL Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    466 Lichfield Road
    Four Oaks
    B74 4EL Sutton Coldfield
    West Midlands
    ItalianExecutive105266880001
    CALVI, Paul
    Beech House 35 Burton Road
    Repton
    DE65 6FN Derby
    Derbyshire
    Director
    Beech House 35 Burton Road
    Repton
    DE65 6FN Derby
    Derbyshire
    CanadianExecutive31220260001
    CAMISASCA, Bruno Carlo Maria
    Derby Road
    DE13 0BH Burton-On-Trent
    Staffordshire
    Director
    Derby Road
    DE13 0BH Burton-On-Trent
    Staffordshire
    ItalyItalianBusiness Executive175410840001
    CANGELOSI, Giuseppe
    19 Kensington Oval
    WS13 6NR Lichfield
    Staffordshire
    Director
    19 Kensington Oval
    WS13 6NR Lichfield
    Staffordshire
    ItalianExecutive117925550001
    CATENI, Flavio
    Kensington Oval
    WS13 6NR Lichfield
    19
    Staffordshire
    Director
    Kensington Oval
    WS13 6NR Lichfield
    19
    Staffordshire
    United KingdomItalianExecutive129637270001
    CLARKE, Terence Graham
    Somersal End
    Somersal Herbert
    DE6 5PD Ashbourne
    Derbyshire
    Director
    Somersal End
    Somersal Herbert
    DE6 5PD Ashbourne
    Derbyshire
    United KingdomBritishExecutive81945150002
    COSTA, Carlo
    Via Mylius 6
    16128 Genova
    Italy
    Director
    Via Mylius 6
    16128 Genova
    Italy
    ItalianExecutive69232200002
    CRADDOCK, Michael William
    62 Falconers Field
    AL5 3ET Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    62 Falconers Field
    AL5 3ET Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishExecutive8524840001
    ENSOR, Anthony Edward
    3 Deacon Close
    CV22 5AQ Rugby
    Warwickshire
    Director
    3 Deacon Close
    CV22 5AQ Rugby
    Warwickshire
    BritishExecutive73937950001
    EVANS, Christopher Paul
    5 Foxton Close
    Alrewas
    DE13 7FE Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    5 Foxton Close
    Alrewas
    DE13 7FE Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritishExecutive205782200001
    FANCIULLI, Dott Francesco
    Via Uruguay 30/2
    Milano
    Italy
    Director
    Via Uruguay 30/2
    Milano
    Italy
    ItalianManager83162170001
    MASERA, Giorgio Paolo
    20b
    The Close
    WS13 7LD Lichfield
    Staffordshire
    Director
    20b
    The Close
    WS13 7LD Lichfield
    Staffordshire
    ItalianExecutive43785480003
    MAZZANTINI, Carlo Adriano
    Beech House
    35 Burton Road
    DE65 6FN Repton
    Derbyshire
    Director
    Beech House
    35 Burton Road
    DE65 6FN Repton
    Derbyshire
    ItalianExecutive36632560001
    PAGE, Richard Harvey
    14 Barby Road
    Kilsby
    CV23 8XD Rugby
    Warwickshire
    Director
    14 Barby Road
    Kilsby
    CV23 8XD Rugby
    Warwickshire
    EnglandBritishExecutive75981030001
    RENDELL, Christopher John
    Alveston
    55 Savey Lane, Yoxall
    DE13 8PD Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    Alveston
    55 Savey Lane, Yoxall
    DE13 8PD Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishManaging Director65857750002
    ROSS, Lesley Pamela
    Reapers Cottage
    Barton Blount
    DE65 5AT Church Broughton
    Derbyshire
    Director
    Reapers Cottage
    Barton Blount
    DE65 5AT Church Broughton
    Derbyshire
    EnglandBritishExecutive8358540007
    STERLING, William Robert
    4 Chevin Bank
    Hazelwood Road Duffield
    DE56 4AA Belper
    Derbyshire
    Director
    4 Chevin Bank
    Hazelwood Road Duffield
    DE56 4AA Belper
    Derbyshire
    BritishExecutive40291130001

    ¿Tiene CPC 2010 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental trust deed
    Creado el 27 jun 1980
    Entregado el 04 jul 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing debenture stock of pirelli limited amounting to £920,000. 7% debenture stock 1983/88 and all other monies intended to be secured under a trust deed dated 24 june 1955 and deeds supplemental thereto.
    Breve descripción
    Floating charge & fixed charges undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. See doc (M26).
    Personas con derecho
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transacciones
    • 04 jul 1980Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 27 jun 1980
    Entregado el 11 jul 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital, together with all fixtures, fixed plant and machinery. Stocks shares & other securities.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 11 jul 1980Registro de una carga
    Mortgage debenture
    Creado el 27 jun 1980
    Entregado el 03 jul 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge - undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital & all stocks, shares & other security.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 03 jul 1980Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0