CPC 2010 LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | CPC 2010 LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01297210 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CPC 2010 LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra CPC 2010 LIMITED?
Dirección de la sede social | Derby Road DE13 0BH Burton-On-Trent Staffordshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CPC 2010 LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
CPK AUTO PRODUCTS LIMITED | 31 dic 1977 | 31 dic 1977 |
TRANHILL LIMITED | 04 feb 1977 | 04 feb 1977 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CPC 2010 LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2012 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para CPC 2010 LIMITED?
Declaración anual |
|
---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CPC 2010 LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 may 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Bruno Camisasca como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 may 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Bruno Carlo Maria Camisasca como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 may 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Glen Andrews como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Charanjit Singh Sagoo como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Flavio Cateni como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 may 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed cpk auto products LIMITED\certificate issued on 25/10/10 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 may 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009 | 7 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 287 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008 | 7 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 4 páginas | 363a | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CPC 2010 LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGOO, Charanjit Singh | Secretario | Cherrywood Road Streetly B74 3RT Sutton Coldfield 33 West Midlands | British | 140904140001 | ||||||
ANDREWS, Glen | Director | Derby Road DE13 0BH Burton-On-Trent Staffordshire | England | English | Executive | 168024040001 | ||||
SAGOO, Charanjit Singh | Director | Derby Road DE13 0BH Burton-On-Trent Staffordshire | United Kingdom | British | Executive | 168018390001 | ||||
SANDIVASCI, Dominic Antonio | Director | 2 Whirlow Grange Avenue S11 9RW Sheffield | England | Italian | Executive | 61626380002 | ||||
PAGE, Richard Harvey | Secretario | 14 Barby Road Kilsby CV23 8XD Rugby Warwickshire | British | 75981030001 | ||||||
PIPER, David John | Secretario | Cherry Tree Cottage Highmoor RG9 5DH Henley On Thames Oxfordshire | British | 8673860001 | ||||||
SODERBERG, John Warren | Secretario | 36 Netherhall Gardens Flat 3 Hampstead NW3 5TP London | American | 76253090002 | ||||||
SYKES, Jeremy Patrick Nelson | Secretario | Flat 3 Riley House Ann Lane SW10 0BS London | British | 53768840001 | ||||||
ARIOLI, Massimo Luca, Dr | Director | 17 Manor Rise WS14 9SL Lichfield | Italian | Executive | 92955960002 | |||||
BAVESTRELLI, Luciano | Director | Beech House 35 Burton Road Repton DE65 6FN Derby Derbyshire | Italian | Executive | 8524830001 | |||||
BIANCONI, Carlo | Director | The Old Rectory Church Lane Dalbury DE6 5BR Ashbourne Derbyshire | Italian | Executive | 55625830002 | |||||
BOCCHIO, Fabio | Director | 466 Lichfield Road Four Oaks B74 4EL Sutton Coldfield West Midlands | Italian | Executive | 105266880001 | |||||
CALVI, Paul | Director | Beech House 35 Burton Road Repton DE65 6FN Derby Derbyshire | Canadian | Executive | 31220260001 | |||||
CAMISASCA, Bruno Carlo Maria | Director | Derby Road DE13 0BH Burton-On-Trent Staffordshire | Italy | Italian | Business Executive | 175410840001 | ||||
CANGELOSI, Giuseppe | Director | 19 Kensington Oval WS13 6NR Lichfield Staffordshire | Italian | Executive | 117925550001 | |||||
CATENI, Flavio | Director | Kensington Oval WS13 6NR Lichfield 19 Staffordshire | United Kingdom | Italian | Executive | 129637270001 | ||||
CLARKE, Terence Graham | Director | Somersal End Somersal Herbert DE6 5PD Ashbourne Derbyshire | United Kingdom | British | Executive | 81945150002 | ||||
COSTA, Carlo | Director | Via Mylius 6 16128 Genova Italy | Italian | Executive | 69232200002 | |||||
CRADDOCK, Michael William | Director | 62 Falconers Field AL5 3ET Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | Executive | 8524840001 | ||||
ENSOR, Anthony Edward | Director | 3 Deacon Close CV22 5AQ Rugby Warwickshire | British | Executive | 73937950001 | |||||
EVANS, Christopher Paul | Director | 5 Foxton Close Alrewas DE13 7FE Burton On Trent Staffordshire | England | British | Executive | 205782200001 | ||||
FANCIULLI, Dott Francesco | Director | Via Uruguay 30/2 Milano Italy | Italian | Manager | 83162170001 | |||||
MASERA, Giorgio Paolo | Director | 20b The Close WS13 7LD Lichfield Staffordshire | Italian | Executive | 43785480003 | |||||
MAZZANTINI, Carlo Adriano | Director | Beech House 35 Burton Road DE65 6FN Repton Derbyshire | Italian | Executive | 36632560001 | |||||
PAGE, Richard Harvey | Director | 14 Barby Road Kilsby CV23 8XD Rugby Warwickshire | England | British | Executive | 75981030001 | ||||
RENDELL, Christopher John | Director | Alveston 55 Savey Lane, Yoxall DE13 8PD Burton On Trent Staffordshire | British | Managing Director | 65857750002 | |||||
ROSS, Lesley Pamela | Director | Reapers Cottage Barton Blount DE65 5AT Church Broughton Derbyshire | England | British | Executive | 8358540007 | ||||
STERLING, William Robert | Director | 4 Chevin Bank Hazelwood Road Duffield DE56 4AA Belper Derbyshire | British | Executive | 40291130001 |
¿Tiene CPC 2010 LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Supplemental trust deed | Creado el 27 jun 1980 Entregado el 04 jul 1980 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For securing debenture stock of pirelli limited amounting to £920,000. 7% debenture stock 1983/88 and all other monies intended to be secured under a trust deed dated 24 june 1955 and deeds supplemental thereto. | |
Breve descripción Floating charge & fixed charges undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. See doc (M26). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 27 jun 1980 Entregado el 11 jul 1980 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital, together with all fixtures, fixed plant and machinery. Stocks shares & other securities. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 27 jun 1980 Entregado el 03 jul 1980 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed & floating charge - undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital & all stocks, shares & other security. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0