CHELFUL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCHELFUL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01301332
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CHELFUL LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra CHELFUL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    35 Tameside Drive
    Castle Bromwich
    B35 7AG Birmingham
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CHELFUL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CHELFUL INVESTMENTS LIMITED23 ene 198923 ene 1989
    CHELFUL LIMITED07 mar 197707 mar 1977

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CHELFUL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ene 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CHELFUL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Retiro de la solicitud de exclusión de la empresa

    2 páginasDS02

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Exercice comptable en cours raccourci du 31 ene 2012 au 31 dic 2011

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 21 oct 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 nov 2011

    Estado de capital el 18 nov 2011

    • Capital: GBP 2,871,253
    SH01

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Resoluciones

    Resolutions
    12 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Re sect 175 ca 2006 29/11/2010
    RES13
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Déclaration annuelle établie au 21 oct 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Comptes modifiés d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 ene 2010

    1 páginasAAMD

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ene 2010

    1 páginasAA

    Nombramiento de Mr James Charles Shears como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Mervyn Keene como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 21 oct 2009 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cambio de datos del director Philip Ratcliffe el 16 nov 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mervyn Peter John Keene el 16 nov 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Stephen James Grant el 16 nov 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr James Charles Shears el 16 nov 2009

    1 páginasCH03

    Cuentas preparadas hasta el 31 ene 2009

    1 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas287

    Cuentas preparadas hasta el 31 ene 2008

    1 páginasAA

    Cuentas preparadas hasta el 31 ene 2007

    1 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de CHELFUL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SHEARS, James Charles
    Tameside Drive
    Castle Bromwich
    B35 7AG Birmingham
    35
    United Kingdom
    Secretario
    Tameside Drive
    Castle Bromwich
    B35 7AG Birmingham
    35
    United Kingdom
    BritishChartered Accountant72228840002
    GRANT, Stephen James
    Tameside Drive
    Castle Bromwich
    B35 7AG Birmingham
    35
    United Kingdom
    Director
    Tameside Drive
    Castle Bromwich
    B35 7AG Birmingham
    35
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director60161650002
    RATCLIFFE, Philip
    Tameside Drive
    Castle Bromwich
    B35 7AG Birmingham
    35
    United Kingdom
    Director
    Tameside Drive
    Castle Bromwich
    B35 7AG Birmingham
    35
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector67890400001
    SHEARS, James Charles
    Tameside Drive
    Castle Bromwich
    B35 7AG Birmingham
    35
    United Kingdom
    Director
    Tameside Drive
    Castle Bromwich
    B35 7AG Birmingham
    35
    United Kingdom
    EnglandEnglishDirector152168520001
    COOPER, Jayne
    The Old Hall Hulland Village
    DE6 3EP Derby
    Derbyshire
    Secretario
    The Old Hall Hulland Village
    DE6 3EP Derby
    Derbyshire
    British46001630001
    DOWNS, Kevin
    21 Gleneagles Drive
    Stretton
    DE13 0YG Burton On Trent
    Staffordshire
    Secretario
    21 Gleneagles Drive
    Stretton
    DE13 0YG Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishAccountant14395290001
    GREEN, Andrew Bernard
    Roddenbrook Lodge Huntenhull Lane
    Chapmanslade
    BA13 4AS Westbury
    Wiltshire
    Secretario
    Roddenbrook Lodge Huntenhull Lane
    Chapmanslade
    BA13 4AS Westbury
    Wiltshire
    British62833460001
    HANDS, Stephen James
    41 Sandy Hill Road
    Shirley
    B90 2ET Solihull
    West Midlands
    Secretario
    41 Sandy Hill Road
    Shirley
    B90 2ET Solihull
    West Midlands
    British68658850001
    KEENE, Mervyn Peter John
    5 Broadway
    Crowland
    PE6 0BJ Peterborough
    Secretario
    5 Broadway
    Crowland
    PE6 0BJ Peterborough
    BritishAccountant984450001
    LLOYD, Cheryl Ann
    15 Kington Close
    WV12 5YW Willenhall
    West Midlands
    Secretario
    15 Kington Close
    WV12 5YW Willenhall
    West Midlands
    BritishChief Accountant Company Secre72610320001
    RICHARDSON, Mary Elizabeth
    7 Deer Park Drive
    Arnold
    NG5 8SA Nottingham
    Nottinghamshire
    Secretario
    7 Deer Park Drive
    Arnold
    NG5 8SA Nottingham
    Nottinghamshire
    British30830090001
    BALDERSON, Martin Christopher
    15 The Park
    Mayfield
    DE6 2HT Ashbourne
    Derbyshire
    Director
    15 The Park
    Mayfield
    DE6 2HT Ashbourne
    Derbyshire
    BritishGeneral Manager32449230001
    BALDERSON, Martin Christopher
    15 The Park
    Mayfield
    DE6 2HT Ashbourne
    Derbyshire
    Director
    15 The Park
    Mayfield
    DE6 2HT Ashbourne
    Derbyshire
    BritishPurchasing Director32449230001
    CHUTE, Lawrence
    15 Beverley Close
    Balsall Common
    CV7 7GA Coventry
    Director
    15 Beverley Close
    Balsall Common
    CV7 7GA Coventry
    EnglishCompany Director37855480001
    COOPER, Howard Lee
    The Old Hall
    Hulland
    DE6 3EP Ashbourne
    Derbyshire
    Director
    The Old Hall
    Hulland
    DE6 3EP Ashbourne
    Derbyshire
    EnglandBritishCompany Director85143030001
    COOPER, Jayne
    The Old Hall Hulland Village
    DE6 3EP Derby
    Derbyshire
    Director
    The Old Hall Hulland Village
    DE6 3EP Derby
    Derbyshire
    BritishCompany Director46001630001
    DOBBS, Kenneth
    4 Birkdale Close
    Mickleover
    DE3 5YG Derby
    Director
    4 Birkdale Close
    Mickleover
    DE3 5YG Derby
    BritishFinancial Director32449240001
    DOWNS, Kevin
    21 Gleneagles Drive
    Stretton
    DE13 0YG Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    21 Gleneagles Drive
    Stretton
    DE13 0YG Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector14395290001
    FURBER, Nevill Dugdale
    15 Ashbury Court
    Henley In Arden
    B95 5AF Solihull
    West Midlands
    Director
    15 Ashbury Court
    Henley In Arden
    B95 5AF Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director62903030002
    GROVE, David Leslie
    Badgers Holt, Rookery Lane
    Lowsonford
    B95 5EP Solihull
    West Midlands
    Director
    Badgers Holt, Rookery Lane
    Lowsonford
    B95 5EP Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director4174280001
    KEENE, Mervyn Peter John
    Tameside Drive
    Castle Bromwich
    B35 7AG Birmingham
    35
    United Kingdom
    Director
    Tameside Drive
    Castle Bromwich
    B35 7AG Birmingham
    35
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant984450001
    LITWINOWICZ, Leszek Richard
    72 Rosemary Hill Road
    Streetly
    B74 4HJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    72 Rosemary Hill Road
    Streetly
    B74 4HJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishAccountant70815770002
    RICHARDSON, Mary Elizabeth
    7 Deer Park Drive
    Arnold
    NG5 8SA Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    7 Deer Park Drive
    Arnold
    NG5 8SA Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishAccountant30830090001
    VICARY, Albert Paul
    Woodlands
    88 Atlantic Way
    EX39 1JG Westward Ho
    Devon
    Director
    Woodlands
    88 Atlantic Way
    EX39 1JG Westward Ho
    Devon
    BritishDirector30066960002

    ¿Tiene CHELFUL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of debenture made between mv sports group PLC,the company and the other companies as chargors (as defined) and burdale financial limited ("burdale")
    Creado el 14 sept 2001
    Entregado el 28 sept 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Burdale Financial Limited
    Transacciones
    • 28 sept 2001Registro de un cargo (395)
    • 05 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge (all assets)
    Creado el 08 mar 1999
    Entregado el 10 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Floating charge all the undertaking of the company and all assets acquired by the company or in which it now has or in future acquires including the stock in trade and its uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Griffin Credit Services Limited
    Transacciones
    • 10 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 15 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest and on other debts and floating charge on proceeds of other debts
    Creado el 08 mar 1999
    Entregado el 10 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Breve descripción
    Fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder & the company including the associated rights relating thereto, which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason all amounts of indebtedness now or at any time hereafter owing or becoming due to the company on any account whatsoever including the associated rights relating thereto (other than debts the subject of (I) above) but subject to paragraph 2 below by way of floating charge such monies as the company may receive in respect of the debts as shall from time to time stand released from the fixed charge created thereon.
    Personas con derecho
    • Griffin Credit Services Limited
    Transacciones
    • 10 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 15 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 05 mar 1999
    Entregado el 18 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 18 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 15 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 10 jun 1994
    Entregado el 16 jun 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 jun 1994Registro de un cargo (395)
    • 08 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge
    Creado el 19 may 1993
    Entregado el 28 may 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a facility letter dated 19.04.93 or under the charge
    Breve descripción
    All moneys due owing or payable to the company by buyers on whom the company holds credit risk insurance cover. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 28 may 1993Registro de un cargo (395)
    • 08 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 25 mar 1993
    Entregado el 08 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H-land at pybus street, derby. T/n-DY169025 (for full details see form 395 and contd sheet).
    Personas con derecho
    • Howard Lee Cooper
    Transacciones
    • 08 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 01 jul 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge
    Creado el 25 mar 1993
    Entregado el 08 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter dated 27 january 1993 and/or the charge
    Breve descripción
    All amounts due, owing or payable to the company by buyers on whom the company holds credit risk insurance cover under the contracts entered into or at any time after the date of the charge to be entered into by the company for the sale of goods on credit terms not exceeding 180 days from the date of despatch or delivery (for full details of charge see form 395).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 08 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 25 mar 1993
    Entregado el 06 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land and buildings at pybus street derby t/no.DY169025. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • Grove Industries Limited
    Transacciones
    • 06 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 08 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge
    Creado el 02 may 1991
    Entregado el 16 may 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a debenture dated 17-3-88
    Breve descripción
    All right title & interest of the company in a receivables financing deed dated 9/8/90 & all book debts.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 may 1991Registro de una carga
    • 14 abr 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge
    Creado el 16 abr 1991
    Entregado el 18 abr 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £60,000 & all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    A first fixed charge over goods as shown in detail on form 395 m/46/C.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 18 abr 1991Registro de una carga
    • 12 ene 1994Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 01 jul 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 25 mar 1988
    Entregado el 05 abr 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and buildings adjoining pybus street derby derbyshire. T.N. dy 28901.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 abr 1988Registro de una carga
    • 08 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 17 mar 1988
    Entregado el 23 mar 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 23 mar 1988Registro de una carga
    • 14 abr 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 14 abr 1987
    Entregado el 01 may 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a a warehouse situate on the north west side of and fronting to clifton road ashbourne county of derby and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 01 may 1987Registro de una carga
    Mortgage debenture
    Creado el 06 may 1986
    Entregado el 16 may 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over the companies f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts benefit of licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 may 1986Registro de una carga
    Mortgage debenture
    Creado el 18 dic 1985
    Entregado el 24 dic 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over the company's f/h and l/h properties and the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital benefit of licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 24 dic 1985Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0