C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED

C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaC.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01303919
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED?

    • Comercio al por mayor no especializado (46900) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o C/O ATLANTIC PLASTICS LIMITED
    Coytrahene Close
    Brackla Industrial Estate
    CF31 2AX Bridgend
    Mid Glamorgan
    Wales
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01
    A3BPC0A8

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 sept 2013

    5 páginasAA
    A3BA06F4

    Domicilio social registrado cambiado de * C/O Atlantic Plastics Ltd Unit H200 Edison Road Hams Hall Coleshill West Midlands B46 1AB* el 17 mar 2014

    1 páginasAD01
    X33VM5TK

    Déclaration annuelle établie au 24 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 oct 2013

    Estado de capital el 15 oct 2013

    • Capital: GBP 30,000
    SH01
    X2J0VKHU

    Nombramiento de Mr Mark Vernon Hodgens como director

    2 páginasAP01
    X2I5U8R6

    Cese del nombramiento de Saul Godfrey como director

    1 páginasTM01
    X2HSR975

    Cese del nombramiento de Marcus Billman como director

    1 páginasTM01
    X25FQVF4

    Nombramiento de Dr Ansgar Nonn como director

    2 páginasAP01
    X250GW61

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2012

    17 páginasAA
    A22TYQNN

    Cese del nombramiento de Kris Holla como director

    1 páginasTM01
    X1MZBVQI

    Déclaration annuelle établie au 24 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    X1JEFQ3N

    Nombramiento de Mr Marcus Billman como director

    2 páginasAP01
    X1DE2DKW

    Cese del nombramiento de Oliver Gosemann como director

    1 páginasTM01
    X1DE2D9E

    Nombramiento de Mr Kris Holla como director

    2 páginasAP01
    X15SQQLN

    Nombramiento de Mr Oliver Frank Gosemann como director

    2 páginasAP01
    X15IB2G3

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2011

    17 páginasAA
    A11Q8SL5

    Déclaration annuelle établie au 24 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    X104BYCN

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado

    1 páginasAD04
    X104AYCM

    Cese del nombramiento de Jan Van Ooijen como director

    1 páginasTM01
    XVK2AXXI

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD
    AO3TPWL0

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES United Kingdom

    1 páginasAD02
    XQOO8UGH

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010

    18 páginasAA
    ARVV3SWI

    Nombramiento de Mr James Fry como secretario

    1 páginasAP03
    X0F7GSC3

    ¿Quiénes son los directivos de C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FRY, James
    c/o C/O Atlantic Plastics Limited
    Close
    Brackla Industrial Estate
    CF31 2AX Bridgend
    Coytrahene
    Mid Glamorgan
    Wales
    Secretario
    c/o C/O Atlantic Plastics Limited
    Close
    Brackla Industrial Estate
    CF31 2AX Bridgend
    Coytrahene
    Mid Glamorgan
    Wales
    158470000001
    HODGENS, Mark Vernon
    Coytrahene Close
    Brackla Industrial Estate
    CF31 2AX Bridgend
    Atlantic Plastics Limited
    Mid Glamorgan
    Wales
    Director
    Coytrahene Close
    Brackla Industrial Estate
    CF31 2AX Bridgend
    Atlantic Plastics Limited
    Mid Glamorgan
    Wales
    EnglandBritishManaging Director94971440002
    NONN, Ansgar, Dr
    Senefelder Strasse 2
    63110 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    Director
    Senefelder Strasse 2
    63110 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    GermanyGermanChief Executive177013380001
    HUNT, Nigel Thomas
    84 Fabis Close
    Walton Park
    DE11 9SN Swadlincote
    Derbyshire
    Secretario
    84 Fabis Close
    Walton Park
    DE11 9SN Swadlincote
    Derbyshire
    British39559640001
    MARTIN, Terry
    18 Ashford Crescent
    EN3 7HU Enfield
    Middlesex
    Secretario
    18 Ashford Crescent
    EN3 7HU Enfield
    Middlesex
    BritishAccountant69720220001
    MATTHEWS, Darren Jon
    60 Whitemoor Drive
    Monkspath
    B90 4UL Shirley
    West Midlands
    Secretario
    60 Whitemoor Drive
    Monkspath
    B90 4UL Shirley
    West Midlands
    BritishAccountant112391130001
    WALKER, Lesley
    5 Brookside
    Birch Cross, Marchington
    ST14 8NU Uttoxeter
    Staffordshire
    Secretario
    5 Brookside
    Birch Cross, Marchington
    ST14 8NU Uttoxeter
    Staffordshire
    British57030200002
    BILLMAN, Marcus
    Senefelder Strasse 2
    63110 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    Director
    Senefelder Strasse 2
    63110 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    United KingdomSwedishChief Operating Officer142246880001
    CATT, Nicholas William
    Farquhar Street
    SG14 3BP Hertford
    Little Eaves 6
    Hertfordshire
    Director
    Farquhar Street
    SG14 3BP Hertford
    Little Eaves 6
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector128624750001
    DAWES, Michael William
    The Nook
    Alton
    ST10 4BH Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    The Nook
    Alton
    ST10 4BH Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishCompany Director21194340001
    DURY, Paul John Edwin
    45 St Johns Treet
    DE6 1GP Ashbourne
    Derbyshire
    Director
    45 St Johns Treet
    DE6 1GP Ashbourne
    Derbyshire
    BritishProduction Director46194000001
    EDMONDS, David Henry
    One Carrington House
    Buxton Road
    DE6 1EX Ashbourne
    Derbyshire
    Director
    One Carrington House
    Buxton Road
    DE6 1EX Ashbourne
    Derbyshire
    BritishMarketing Director73468520001
    GODFREY, Saul Gideon
    Charwood Close
    WD7 9LH Shenley
    12
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Charwood Close
    WD7 9LH Shenley
    12
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director103524290001
    GOSEMANN, Oliver Frank
    Senefelder Strasse 2
    63100 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    Director
    Senefelder Strasse 2
    63100 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    GermanyGermanChief Executive Officer167850440001
    HOLLA, Kris
    Senefelder Strasse 2
    63100 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    Director
    Senefelder Strasse 2
    63100 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    GermanyAmericanChief Sales Officer167994810001
    KING, Stuart Derek
    68 Wenallt Road
    Rhiwbina
    CF4 6SE Cardiff
    South Glamorgan
    Director
    68 Wenallt Road
    Rhiwbina
    CF4 6SE Cardiff
    South Glamorgan
    BritishDirector40173530001
    MACKEY, Damian
    18 Clinton Road
    CF64 3JD Penarth
    South Glamorgan
    Director
    18 Clinton Road
    CF64 3JD Penarth
    South Glamorgan
    AustralianManaging Director125261330001
    MCKENDRY, Francis James
    26/28 Avenue Raymond Poincarre
    FOREIGN Paris
    75116
    France
    Director
    26/28 Avenue Raymond Poincarre
    FOREIGN Paris
    75116
    France
    FranceBritishFinancial Executive124595550001
    NICHOLAS, David Charles
    Lillingstone House
    84 Knowle Wood Road Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    Director
    Lillingstone House
    84 Knowle Wood Road Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    BritishDirector96403410001
    POLINE, Olivier Pierre
    30 Allee Du Chateau
    69780 Mioms
    France
    Director
    30 Allee Du Chateau
    69780 Mioms
    France
    FrenchChief Finance Officer112391190001
    TURNER, Stanley
    The Maples
    The Park
    B79 9DF Elford
    Staffordshire
    Director
    The Maples
    The Park
    B79 9DF Elford
    Staffordshire
    EnglandBritishManaging Director70686150004
    VAN OOIJEN, Jan Roelf
    Heeckerenlaan 5
    7531 HW Enschede
    7531 Hw
    Netherlands
    Director
    Heeckerenlaan 5
    7531 HW Enschede
    7531 Hw
    Netherlands
    DutchPresident Tww Emea125281750001
    WALKER, Lesley
    5 Brookside
    Birch Cross, Marchington
    ST14 8NU Uttoxeter
    Staffordshire
    Director
    5 Brookside
    Birch Cross, Marchington
    ST14 8NU Uttoxeter
    Staffordshire
    EnglandBritishFinance57030200002
    WARD, Marcus Gordon Waddie
    Rue De Tenbosch 85
    Flat 113
    FOREIGN Brussels
    1050
    Belgium
    Director
    Rue De Tenbosch 85
    Flat 113
    FOREIGN Brussels
    1050
    Belgium
    BritishChartered Accountant74246040001
    WHELDON, Stephen
    11 Ashfield Park
    NE16 4SQ Whickham
    Tyne & Wear
    Director
    11 Ashfield Park
    NE16 4SQ Whickham
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishSales Director93126410001
    WILLIAMS, Andrew
    79 The Crescent
    WS1 2DA Walsall
    Director
    79 The Crescent
    WS1 2DA Walsall
    BritishSolicitor39210390001

    ¿Tiene C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage debenture
    Creado el 06 ene 2000
    Entregado el 11 ene 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 11 ene 2000Registro de un cargo (395)
    • 26 abr 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creado el 20 ago 1999
    Entregado el 27 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a land and garage premises and part garage premises on the west side of woodland road swadlincote derbyshire t/no's;-DY3354 DY3355. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 27 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 26 abr 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creado el 31 mar 1994
    Entregado el 20 abr 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transacciones
    • 20 abr 1994Registro de un cargo (395)
    • 19 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 18 oct 1991
    Entregado el 22 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land & premises woodland road swadlincote t/no DY3354 & DY3355.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 22 oct 1991Registro de un cargo (395)
    • 19 abr 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 13 mar 1987
    Entregado el 20 mar 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge on all book & other debts now & from time to time due or owing to the company.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 20 mar 1986Registro de una carga
    • 19 abr 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 oct 1982
    Entregado el 08 oct 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Freehold land & premises k/a 115 and 117 hearthcote road, swadlincote, derbyshire. Title no: dy 82283.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 08 oct 1982Registro de una carga
    • 19 abr 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge
    Creado el 16 dic 1977
    Entregado el 29 dic 1977
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 29 dic 1977Registro de una carga
    • 19 abr 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0