CENTRELINK EXPRESS LIMITED

CENTRELINK EXPRESS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCENTRELINK EXPRESS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01307163
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CENTRELINK EXPRESS LIMITED?

    • Hoteles y alojamientos similares (55100) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida
    • Restaurantes con licencia (56101) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida

    ¿Dónde se encuentra CENTRELINK EXPRESS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o SMITH & WILLIAMSON LLP
    3rd Floor 9
    Colmore Row
    B3 2BJ Birmingham
    West Midlands
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CENTRELINK EXPRESS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    FARLEYER HOUSE HOTEL LIMITED12 may 199412 may 1994
    SOUTHSTREAM LIMITED06 abr 197706 abr 1977

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CENTRELINK EXPRESS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CENTRELINK EXPRESS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2012

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Btg Tax 19 George Road Edgbaston Birmingham West Midlands B15 1NU el 14 jun 2012

    1 páginasAD01

    Estado de capital el 13 jun 2012

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancel share prem a/c 24/05/2012
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 jun 2011

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2010

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de Andrew Shaw como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Andrew Shaw como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 26 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Janice Anne Reid el 25 mar 2010

    2 páginasCH01

    Cuentas preparadas hasta el 30 jun 2009

    5 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas353

    legacy

    1 páginas190

    Cuentas preparadas hasta el 30 jun 2008

    5 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas353

    legacy

    1 páginas190

    ¿Quiénes son los directivos de CENTRELINK EXPRESS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    REID, Derek Donald
    Broomhill
    Kinclaven
    PH1 4QL Stanley
    Perthshire
    Director
    Broomhill
    Kinclaven
    PH1 4QL Stanley
    Perthshire
    ScotlandBritish24165790005
    REID, Janice Anne
    Broomhill
    Kinclaven
    PH1 4QL Stanley
    Perthshire
    Director
    Broomhill
    Kinclaven
    PH1 4QL Stanley
    Perthshire
    ScotlandNew Zealand37962070002
    ATKINS, Gerald
    Farleyer Field House
    PH25 2JE Aberfeldy
    Perthshire
    Secretario
    Farleyer Field House
    PH25 2JE Aberfeldy
    Perthshire
    British53861890001
    REID, Derek Donald
    Bonhard House
    PH2 7PQ Scone
    Perthshire
    Secretario
    Bonhard House
    PH2 7PQ Scone
    Perthshire
    British24165790003
    SHAW, Andrew Charles
    Barley House
    2 The Granary, Besford
    WR8 9BY Worcester
    Worcestershire
    Secretario
    Barley House
    2 The Granary, Besford
    WR8 9BY Worcester
    Worcestershire
    British29924060011
    ATKINS, Frances
    Farleyer Field House
    PH25 2JE Aberfeldy
    Perthshire
    Director
    Farleyer Field House
    PH25 2JE Aberfeldy
    Perthshire
    British53862050001
    ATKINS, Gerald
    Farleyer Field House
    PH25 2JE Aberfeldy
    Perthshire
    Director
    Farleyer Field House
    PH25 2JE Aberfeldy
    Perthshire
    British53861890001
    HEATH, Anthony
    Kildinny Farm
    Forteviot
    PH2 9DD Perth
    Perthshire
    Director
    Kildinny Farm
    Forteviot
    PH2 9DD Perth
    Perthshire
    British73926030001
    REID, Derek Donald
    Bonhard House
    PH2 7PQ Scone
    Perthshire
    Director
    Bonhard House
    PH2 7PQ Scone
    Perthshire
    British24165790003
    SHAW, Andrew Charles
    Barley House
    2 The Granary, Besford
    WR8 9BY Worcester
    Worcestershire
    Director
    Barley House
    2 The Granary, Besford
    WR8 9BY Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish29924060011
    SINEL, Malcolm Leslie
    Oaklands
    La Rue De La Frontiere, St. Mary
    JE3 3EG Jersey
    Channel Islands
    Director
    Oaklands
    La Rue De La Frontiere, St. Mary
    JE3 3EG Jersey
    Channel Islands
    British66336350001
    WHITE, Andrew Nicholas
    Panmure Taybridge Road
    PH15 2BH Aberfeldy
    Perthshire
    Director
    Panmure Taybridge Road
    PH15 2BH Aberfeldy
    Perthshire
    British43824820001
    WHITE, Jonathon Grenville
    La Heche
    Rue Du Fliquet St Martin
    JE3 6BP Jersey
    Director
    La Heche
    Rue Du Fliquet St Martin
    JE3 6BP Jersey
    United KingdomBritish61996120001

    ¿Tiene CENTRELINK EXPRESS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Standard security which was presented for registration in scotland on 19/12/96
    Creado el 22 dic 1995
    Entregado el 31 dic 1996
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Farleyer house hotel,farleyer,by aberfeldy,perthshire.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 31 dic 1996Registro de un cargo (395)
    Standard security.
    Creado el 18 sept 1991
    Entregado el 03 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Farleyer house and policies, aberfeldy, perthshire.
    Personas con derecho
    • Cokato Holdings Limited.
    Transacciones
    • 03 oct 1991Registro de una carga
    • 10 sept 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security
    Creado el 17 sept 1991
    Entregado el 27 sept 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £11,000 under the terms of a loan agreement dated 9TH sept. 1991.
    Breve descripción
    Farleyer house and policies, aberfeldy, perthshire.
    Personas con derecho
    • Mrs Frances Elizabeth Atkins
    Transacciones
    • 27 sept 1991Registro de una carga
    • 03 jul 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security.
    Creado el 17 sept 1991
    Entregado el 27 sept 1991
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £11,000 under the terms of a loan agreement dated 9TH sept, 1991.
    Breve descripción
    Farleyer house and policies, aberfeldy, perthshire.
    Personas con derecho
    • Mr Gerald Atkins.
    Transacciones
    • 27 sept 1991Registro de una carga
    Bond and floating charge
    Creado el 09 sept 1991
    Entregado el 20 sept 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in respect of a loan agreement dated 9TH sept. 1991
    Breve descripción
    (See form 395 relevant to this charge).. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Gerald Atkins
    Transacciones
    • 20 sept 1991Registro de una carga
    • 03 jul 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Bond and floating charge
    Creado el 09 sept 1991
    Entregado el 20 sept 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in respect of a loan agreement dated 9TH sept. 1991
    Breve descripción
    (See form 395 relevant to this charge).. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Frances Elizabeth Atkins
    Transacciones
    • 20 sept 1991Registro de una carga
    • 03 jul 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Bond and floating charge
    Creado el 09 sept 1991
    Entregado el 11 sept 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dtd 09/09/91
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Cokato Holdings Limited
    Transacciones
    • 11 sept 1991Registro de una carga
    • 10 sept 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 oct 1990
    Entregado el 20 nov 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (See form 395 and schedule relevant to this charge).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transacciones
    • 20 nov 1990Registro de una carga
    • 11 sept 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 25TH october 1990
    Creado el 25 oct 1990
    Entregado el 02 nov 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Farleyer house and policies, aberfeldy, perthshire.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transacciones
    • 02 nov 1990Registro de una carga
    • 11 sept 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland.
    Creado el 02 nov 1988
    Entregado el 19 nov 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Part & portion of the estate of farleyer in the county of perth (26.8 hectares).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 nov 1988Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 29 ene 1988
    Entregado el 10 feb 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The old plow inn flowers bottom speen, aylesbury, buckinghamshire. T/no:- bm 94450.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 feb 1988Registro de una carga
    • 11 sept 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 19 ene 1987
    Entregado el 21 ene 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £225,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    "The old plow inn" flowers bottom speen near lacey green buckinghamshire and the assignment of the goodwill of the business floating charge undertaking and all property and assets present and future.
    Personas con derecho
    • Allied Irish Finance Company Limited
    Transacciones
    • 21 ene 1987Registro de una carga
    • 30 ago 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0