HALLITE POLYTEK LIMITED

HALLITE POLYTEK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHALLITE POLYTEK LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01308929
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HALLITE POLYTEK LIMITED?

    • fabricación de plásticos en formas primarias (20160) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra HALLITE POLYTEK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HALLITE POLYTEK LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HALLITE DEVELOPMENTS LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    HALLITE BELLOWS LIMITED31 dic 197731 dic 1977
    TRUSHELFCO (NO. 134) LIMITED15 abr 197715 abr 1977

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HALLITE POLYTEK LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ago 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HALLITE POLYTEK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 09 ene 2021

    8 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 09 ene 2020

    8 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de Hesslewood Country Office Park Ferriby Road Hessle East Yorkshire HU13 0PW a C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor Lowgate House Lowgate Hull HU1 1EL el 06 feb 2019

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 10 ene 2019

    LRESSP

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 08 ene 2019

    • Capital: GBP 1.00
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    The company share premium account cancelled 13/12/2018
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Richard William Hewlett como director el 12 dic 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Vijay Markanday como director el 12 dic 2018

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr William John Pratt el 10 sept 2018

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 04 ago 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 ago 2018 au 31 dic 2018

    1 páginasAA01

    Cuentas no auditadas abreviadas presentadas hasta el 31 ago 2017

    7 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr William John Pratt el 16 mar 2018

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Simon Alan Davies como director el 05 mar 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 04 ago 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ago 2016

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 04 ago 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ago 2015

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 ago 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 ago 2015

    Estado de capital el 04 ago 2015

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de HALLITE POLYTEK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRADBURY, Debra
    Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor
    Secretario
    Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor
    British72879990002
    CALEY, Andrew Maitland
    Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor
    Director
    Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor
    United KingdomBritish49060800002
    PRATT, William John
    Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor
    Director
    Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor
    United KingdomBritish194710300003
    GILLETT, Christopher Joseph
    White Lodge
    12 Ashurst Road
    KT20 5EU Tadworth
    Surrey
    Secretario
    White Lodge
    12 Ashurst Road
    KT20 5EU Tadworth
    Surrey
    British69961270001
    HARDACRE, Eian Clark
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    Secretario
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    British119450490001
    LYALL, Gordon John
    Hildegarth
    New Yatt
    OX8 6TF Witney
    Oxfordshire
    Secretario
    Hildegarth
    New Yatt
    OX8 6TF Witney
    Oxfordshire
    British15413660003
    MARKANDAY, Vijay
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secretario
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British49523130001
    WELLER, Christopher
    3 Halfway Cottages
    Bath Road
    RG20 8NG Newbury
    Berkshire
    Secretario
    3 Halfway Cottages
    Bath Road
    RG20 8NG Newbury
    Berkshire
    British80664920001
    BENNETT, Peter Ian
    24 Coulter Close
    Cuffley
    EN6 4RR Potters Bar
    Hertfordshire
    Director
    24 Coulter Close
    Cuffley
    EN6 4RR Potters Bar
    Hertfordshire
    British4154020001
    CHAFFIN, Peter
    The Croft 21 The Ridgeway
    TN10 4NH Tonbridge
    Kent
    Director
    The Croft 21 The Ridgeway
    TN10 4NH Tonbridge
    Kent
    British1508410001
    DAVIES, Simon Alan
    28 Stonebridge Field
    Eton
    SL4 6PS Windsor
    Berkshire
    Director
    28 Stonebridge Field
    Eton
    SL4 6PS Windsor
    Berkshire
    British44598860003
    GILLETT, Christopher Joseph
    White Lodge
    12 Ashurst Road
    KT20 5EU Tadworth
    Surrey
    Director
    White Lodge
    12 Ashurst Road
    KT20 5EU Tadworth
    Surrey
    Great BritainBritish69961270001
    HARDACRE, Eian Clark
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    Director
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    EnglandBritish119450490001
    HEWLETT, Richard William
    34 Bradford Drive
    KT19 0AH Epsom
    Surrey
    Director
    34 Bradford Drive
    KT19 0AH Epsom
    Surrey
    British59434460001
    HOWIE, Andrew Wright
    4 Tregarth Place
    GU21 3JY Woking
    Surrey
    Director
    4 Tregarth Place
    GU21 3JY Woking
    Surrey
    British15413650001
    JONES, David Henry
    Neen Court
    DY14 0AH Neen Sollars
    Worcestershire
    Director
    Neen Court
    DY14 0AH Neen Sollars
    Worcestershire
    United KingdomBritish101383260001
    KINGSNORTH, Robert Stanley
    The Dolphins 23 Kingsley Avenue
    GU15 2NA Camberley
    Surrey
    Director
    The Dolphins 23 Kingsley Avenue
    GU15 2NA Camberley
    Surrey
    British58131230001
    LYALL, Gordon John
    Hildegarth
    New Yatt
    OX8 6TF Witney
    Oxfordshire
    Director
    Hildegarth
    New Yatt
    OX8 6TF Witney
    Oxfordshire
    British15413660003
    MARKANDAY, Vijay
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British49523130001
    MUMFORD, Michael Charles
    Crookhaugh
    3 Rydens Avenue
    KT12 3JB Walton On Thames
    Surrey
    Director
    Crookhaugh
    3 Rydens Avenue
    KT12 3JB Walton On Thames
    Surrey
    British18807630002
    PAVER, Michael
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    Director
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish10035580002
    PERRY, Richard John
    Hesslewood Country Office Park
    Ferriby Road
    HU13 0PW Hessle
    East Yorkshire
    Director
    Hesslewood Country Office Park
    Ferriby Road
    HU13 0PW Hessle
    East Yorkshire
    United KingdomBritish40260860002
    RUBERY, Steven Henry
    16 Whynot Lane
    SP10 3ES Andover
    Hampshire
    Director
    16 Whynot Lane
    SP10 3ES Andover
    Hampshire
    British15413670001
    WELLER, Christopher
    3 Halfway Cottages
    Bath Road
    RG20 8NG Newbury
    Berkshire
    Director
    3 Halfway Cottages
    Bath Road
    RG20 8NG Newbury
    Berkshire
    British80664920001
    WESTON, Peter Maurice
    28 Curley Hill Road
    GU18 5YQ Lightwater
    Surrey
    Director
    28 Curley Hill Road
    GU18 5YQ Lightwater
    Surrey
    EnglandBritish112416950001
    WILKINS, Christopher Stuart Henry
    Banktop House
    Hopton Lane Hopton
    ST18 0AH Stafford
    Staffordshire
    Director
    Banktop House
    Hopton Lane Hopton
    ST18 0AH Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritish127017930001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HALLITE POLYTEK LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Hesslewood Country Office Park
    Ferriby Road
    HU13 0PW Hessle
    Unit 5
    East Yorkshire
    England
    06 abr 2016
    Hesslewood Country Office Park
    Ferriby Road
    HU13 0PW Hessle
    Unit 5
    East Yorkshire
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro01104611
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene HALLITE POLYTEK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 17 sept 1998
    Entregado el 22 sept 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 22 sept 1998Registro de un cargo (395)
    • 30 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creado el 31 ene 1994
    Entregado el 21 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in connection with the agreement (as defined in the original debenture)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co. Limitedas Agent and Trustee for Itself the Arranger and for the Banks (As Defined)
    Transacciones
    • 21 feb 1994Registro de un cargo (395)
    • 31 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creado el 23 feb 1990
    Entregado el 13 mar 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent & trustee for itself, the arranger & the banks (as defined in the original debenture being 2 debentures dated 27.7.89 & 1.9.89) an any account whatsoever under the terms of the agreement (as defined in the original debenture)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transacciones
    • 13 mar 1990Registro de una carga
    • 31 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 01 sept 1989
    Entregado el 05 sept 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company as agent and trustee for itself, the arranger and for the danks under the terms of the agreement and ancilliary facility and/or any other security documents
    Breve descripción
    (For full details see doc. M372).. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Company Limited
    Transacciones
    • 05 sept 1989Registro de una carga
    • 31 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & second debenture
    Creado el 25 ago 1989
    Entregado el 05 sept 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility agreement dated 27/7/89
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • First Britannia Mezzanine Capital B.V.(For Itself and as Trustee for the Lendes)
    Transacciones
    • 05 sept 1989Registro de una carga
    • 31 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & second debenture
    Creado el 27 jul 1989
    Entregado el 17 ago 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    See doc for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • First Britannia Mezzanine Capital B.V.
    Transacciones
    • 17 ago 1989Registro de una carga
    • 31 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & second debenture
    Creado el 27 jul 1989
    Entregado el 07 ago 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from and/or all or any of the other companies named therein under the terms of a mezzanine loan agreement dated 27TH july 1989 and the deed. The company to the chargee.
    Breve descripción
    (See form 395 - ref M541C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Frist Britannia Mezzenine Capital B.V.(As Trustee for the Lenders.)
    Transacciones
    • 07 ago 1989Registro de una carga
    • 31 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 jul 1989
    Entregado el 07 ago 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agrent and trustee for itself the arrange and for the banks) on any account whatsoever under the terms of a facility agreement dated 27.7.89, the ancillary facility and the security documents (as defined in the facility agreement).
    Breve descripción
    For further details see doc M106).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co. Limited.
    Transacciones
    • 07 ago 1989Registro de una carga
    • 31 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene HALLITE POLYTEK LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    10 ene 2019Inicio de la liquidación
    15 dic 2021Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sarah Louise Burge
    First Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    Profesional
    First Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0