GLEN DIMPLEX UK LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GLEN DIMPLEX UK LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01313016 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GLEN DIMPLEX UK LIMITED?
- fabricación de electrodomésticos (27510) / Industrias manufactureras
- Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y equipos y suministros de calefacción (46740) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra GLEN DIMPLEX UK LIMITED?
| Dirección de la sede social | Dimplex Millbrook House, Grange Drive Hedge End SO30 2DF Southampton England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GLEN DIMPLEX UK LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GDC GROUP LIMITED | 03 abr 2009 | 03 abr 2009 |
| DIMPLEX UK LIMITED | 01 ago 2007 | 01 ago 2007 |
| GLEN DIMPLEX UK LIMITED | 30 sept 2002 | 30 sept 2002 |
| GLEN DIMPLEX HEATING LIMITED | 10 mar 1999 | 10 mar 1999 |
| DIMPLEX (UK) LIMITED | 27 mar 1991 | 27 mar 1991 |
| DIMPLEX HEATING LIMITED | 31 dic 1977 | 31 dic 1977 |
| CONTRACTFINE LIMITED | 06 may 1977 | 06 may 1977 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GLEN DIMPLEX UK LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 sept 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para GLEN DIMPLEX UK LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 26 dic 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 09 ene 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 26 dic 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GLEN DIMPLEX UK LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 26 dic 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2024 | 38 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Ms Yvonne Burke como secretario el 01 abr 2025 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Vanessa King como secretario el 31 mar 2025 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Fergal James Leamy como director el 31 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 dic 2024 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Registro de la carga 013130160008, creada el 02 dic 2024 | 46 páginas | MR01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Millbrook House Grange Drive, Hedge End Southampton Hampshire SO30 2DF a Dimplex Millbrook House, Grange Drive Hedge End Southampton SO30 2DF el 31 jul 2024 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2023 | 37 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Ms Yvonne Burke el 13 feb 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 dic 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Fergal John Naughton el 24 ago 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2022 | 37 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2021 | 37 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 dic 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Yvonne Burke como director el 01 oct 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Donal Francis Flynn como director el 01 oct 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Fergal Leamy como director el 20 ago 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2020 | 36 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 dic 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2019 | 36 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Donal Francis Flynn el 29 jun 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 dic 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 4 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GLEN DIMPLEX UK LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURKE, Yvonne | Secretario | Millbrook House, Grange Drive Hedge End SO30 2DF Southampton Dimplex England | 334231060001 | |||||||
| BURKE, Yvonne | Director | Millbrook House, Grange Drive Hedge End SO30 2DF Southampton Dimplex England | Ireland | Irish | 288041840005 | |||||
| NAUGHTON, Fergal John | Director | Millbrook House, Grange Drive Hedge End SO30 2DF Southampton Dimplex England | Ireland | Irish | 223364140005 | |||||
| NAUGHTON, Martin Lawrence | Director | Stackallen House IRISH Slane County Meath Ireland | Ireland | Irish | 39165340001 | |||||
| STEWART, Neil | Director | 12 Knightsbridge Manor BT9 5ET Belfast | Northern Ireland | British | 76833580001 | |||||
| FOLLETT, Brian | Secretario | 13 Hocombe Road Chandlers Ford SO53 5SL Eastleigh Hampshire | British | 3170680001 | ||||||
| GEORGE, Laurence Anthony | Secretario | Bay Tree Cottage 11 Longhedge BA12 7QZ Corsley Wiltshire | British | 55307690001 | ||||||
| HAWKINS, Peter Charles | Secretario | 26 Barnfield Road GU31 4DQ Petersfield Hampshire | British | 55176190001 | ||||||
| KING, Vanessa | Secretario | Millbrook House, Grange Drive Hedge End SO30 2DF Southampton Dimplex England | 166122150001 | |||||||
| MC COOEY, John Charles | Secretario | 45 Cranbourne Drive Otterbourne SO21 2ES Winchester Hampshire | Irish | 77850570003 | ||||||
| O'DRISCOLL, Sean, Mr. | Secretario | Millbrook House Grange Drive, Hedge End SO30 2DF Southampton Hampshire | 164486320001 | |||||||
| ARLISS, Jeremy Herbert | Director | 4 Randall Road Chandlers Ford SO53 5AL Eastleigh Hampshire | British | 3170690001 | ||||||
| BOULDIN, John Anthony | Director | 30 Wickham Drive Corfe Mullen BH21 3JT Wimborne Dorset | British | 25693430001 | ||||||
| FISHER, George | Director | 13 Little Fosters Chaddesley Glen BH13 7PB Poole Dorset | England | British | 109412800001 | |||||
| FLYNN, Donal Francis | Director | Millbrook House Grange Drive, Hedge End SO30 2DF Southampton Hampshire | Ireland | Irish | 126967800002 | |||||
| FOLLETT, Brian | Director | 13 Hocombe Road Chandlers Ford SO53 5SL Eastleigh Hampshire | British | 3170680001 | ||||||
| GAULT, John Samuel | Director | 1 Calhame Road BT39 9NA Ballyclare County Antrim | Northern Ireland | British | 34301460001 | |||||
| GEORGE, Laurence Anthony | Director | Bay Tree Cottage 11 Longhedge BA12 7QZ Corsley Wiltshire | United Kingdom | British | 55307690001 | |||||
| GODDARD, Terence Ivor | Director | Marymead Fountains Park Netley Abbey SO31 5FB Southampton Hampshire | United Kingdom | British | 3170710001 | |||||
| HAWKINS, Peter Charles | Director | 26 Barnfield Road GU31 4DQ Petersfield Hampshire | England | British | 55176190001 | |||||
| HOPE, Monica Ann | Director | 22 Denham Close SO23 7BL Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 30064020001 | |||||
| KAVANAGH, Antony Joseph | Director | 70 Rusper Road RH12 4BL Horsham West Sussex | United Kingdom | British | 101865540001 | |||||
| LEAMY, Fergal James | Director | Millbrook House, Grange Drive Hedge End SO30 2DF Southampton Dimplex England | Ireland | Irish | 286841980001 | |||||
| MACKENZIE, Stuart | Director | Highwood 281 New Road BH22 8EH Ferndown Dorset | United Kingdom | British | 102801150001 | |||||
| MC COOEY, John Charles | Director | 45 Cranbourne Drive Otterbourne SO21 2ES Winchester Hampshire | Irish | 77850570003 | ||||||
| MCGOVERN, Brian | Director | 17 Whitemoss Road East Kilbride G74 4JB Glasgow Lanarkshire | British | 76997230001 | ||||||
| MCLORNAN, Brian Desmond | Director | 15 Dundrinne Road BT31 9EX Castlewellan County Down N Ireland | Irish | 22176310001 | ||||||
| NEWTON, Peter Joseph | Director | Acacia Cottage Botley Road SO32 2DU Curdridge Hampshire | England | British | 32881080002 | |||||
| O'DRISCOLL, Sean Finbar | Director | Cedar Granville Road IRISH Blackrock County Dublin Eire | Ireland | Irish | 134723530001 | |||||
| QUINN, Lochlann Gerard | Director | 5 Seaview Terrace Donnybrook Dublin Ireland | United Kingdom | Irish | 6388110001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GLEN DIMPLEX UK LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr Martin Lawrence Naughton | 06 abr 2016 | Millbrook House, Grange Drive Hedge End SO30 2DF Southampton Dimplex England | No |
Nacionalidad: Irish País de residencia: Ireland | |||
Naturaleza del control
| |||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0