R&Q REINSURANCE COMPANY (UK) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | R&Q REINSURANCE COMPANY (UK) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01315641 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de R&Q REINSURANCE COMPANY (UK) LIMITED?
- Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra R&Q REINSURANCE COMPANY (UK) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 3 Lloyd's Avenue EC3N 3DS London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de R&Q REINSURANCE COMPANY (UK) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BRANDYWINE REINSURANCE COMPANY (UK) LIMITED | 03 sept 1999 | 03 sept 1999 |
| CIGNA REINSURANCE COMPANY (UK) LIMITED | 31 mar 1988 | 31 mar 1988 |
| INA REINSURANCE COMPANY (U.K.) LIMITED | 31 may 1977 | 31 may 1977 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de R&Q REINSURANCE COMPANY (UK) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para R&Q REINSURANCE COMPANY (UK) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 30 jul 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 13 ago 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 30 jul 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para R&Q REINSURANCE COMPANY (UK) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Mr Christopher Riseborough como director el 10 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Malcolm Graham Mccaig como director el 04 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 jul 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 71 Fenchurch Street London EC3M 4BS United Kingdom a 3 Lloyd's Avenue London EC3N 3DS el 30 jul 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 32 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de R&Q Central Services Limited como secretario el 31 mar 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Mark John Tilney como director el 08 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Malcolm Graham Mccaig como director el 08 nov 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 jul 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 31 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 jul 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 30 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Mark John Tilney como director el 09 ene 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Gregg Daniel Jarvis como director el 16 sept 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 jul 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 30 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Mark Andrew Langridge como director el 17 dic 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Richard James Finney como director el 01 dic 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 31 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 27 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 30 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Michael Logan Glover como director el 31 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Gregg Daniel Jarvis como director el 08 oct 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 29 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de R&Q REINSURANCE COMPANY (UK) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINNEY, Richard James | Director | Lloyd's Avenue EC3N 3DS London 3 England | United Kingdom | British | 106351780004 | |||||||||
| RISEBOROUGH, Christopher | Director | Lloyd's Avenue EC3N 3DS London 3 England | England | British | 268705870002 | |||||||||
| BAMFORTH, Peter John | Secretario | Foxbury Giddy Horn Lane Allington ME16 0EE Maidstone Kent | British | 43277270002 | ||||||||||
| ELLENDER, John Eric | Secretario | 30 Bodsham Crescent Bearsted ME15 8NL Maidstone Kent | British | 5267650001 | ||||||||||
| WATT, Jeremy | Secretario | 12 Magpie Close CO12 4WG Harwich Essex | British | 78458600001 | ||||||||||
| WATT, Jeremy | Secretario | 12 Magpie Close CO12 4WG Harwich Essex | British | 78458600001 | ||||||||||
| WILLSHER, James Andrew | Secretario | The Warren 7 Sheridan Close IP14 1UL Stowmarket Suffolk | British | 97223010001 | ||||||||||
| ACE LONDON SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 100 Leadenhall Street EC3A 3BP London | 73849550002 | |||||||||||
| R&Q CENTRAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Fenchurch Street EC3M 4BS London 71 United Kingdom |
| 183686520001 | ||||||||||
| R&Q SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Fenchurch Street EC3M 5JT London 110 United Kingdom |
| 135220830001 | ||||||||||
| BAMFORTH, Peter John | Director | Foxbury Giddy Horn Lane Allington ME16 0EE Maidstone Kent | British | 43277270002 | ||||||||||
| BOOTH, Thomas Alexander | Director | Fenchurch Street EC3M 4BS London 71 United Kingdom | United Kingdom | British | 156884580013 | |||||||||
| CURTIS, Philippa Mary | Director | Flat 20 St Hilda's Wharf 160 Wapping High Street E1W 3PG London | United Kingdom | British | 40995560001 | |||||||||
| DURKIN, Michael Eugene | Director | Cuckoos Rest Priory Close East Farleigh ME15 0EY Maidstone Kent | British | 4375790003 | ||||||||||
| FEDYNA, Michael William | Director | 1836 Howe Lane Maple Glen 19002 Pennsylvania Usa | Us Citizen | 36319860001 | ||||||||||
| GHASSEMI, Riaz | Director | 73 Weald Road CM14 4TP Brentwood Essex | British | 14887410001 | ||||||||||
| GLOVER, Michael Logan | Director | Fenchurch Street EC3M 4BS London 71 United Kingdom | United Kingdom | British | 94249710005 | |||||||||
| GLOVER, Michael Logan | Director | Dunelm 41. St. Catherines Road EN10 7LD Broxbourne Herts | British | 94249710001 | ||||||||||
| JARVIS, Gregg Daniel | Director | Fenchurch Street EC3M 4BS London 71 United Kingdom | United Kingdom | British | 252432630002 | |||||||||
| LANGRIDGE, Mark Andrew | Director | Fenchurch Street EC3M 4BS London 71 United Kingdom | United Kingdom | British | 74401960003 | |||||||||
| MAHONEY, Thomas Joseph | Director | Rue Franz Merjay 199 FOREIGN 1180 Brussells Belgium | Usa | 44459840001 | ||||||||||
| MANTZ, John Martin | Director | 5 Selbourne Road GU4 7JP Guildford Surrey | British | 16108970001 | ||||||||||
| MCCAIG, Malcolm Graham | Director | Lloyd's Avenue EC3N 3DS London 3 England | England | British | 141026580004 | |||||||||
| MCCANN, Peter John | Director | 14 Ross Way Langdon Hills SS16 6LX Basildon Essex | United Kingdom | British | 39976250001 | |||||||||
| MCCOY, Robin Edward | Director | The Lawns Clockhouse Road, Little Burstead CM12 9ST Billericay Essex | United Kingdom | British | 51429940002 | |||||||||
| MELLOR, Christopher John | Director | 16 Addison Place W11 4RJ London | British | 68312140001 | ||||||||||
| QUILTER, Alan Kevin | Director | Fenchurch Street EC3M 5JT London 110 England | England | British | 13145680001 | |||||||||
| RANDALL, Kenneth Edward | Director | Fenchurch Street EC3M 4BS London 71 United Kingdom | Bermuda | British | 142663950002 | |||||||||
| SCHMALZRIEDT, Gary | Director | 188 East 76th Street Penthouse A New York 1002 United States | American | 76185280007 | ||||||||||
| SINGH, Charles Wesley | Director | Fenchurch Street EC3M 5JT London 110 England | England | British | 73263410001 | |||||||||
| SMITH, Michael James | Director | 69 Ash Grove ME16 0AD Maidstone Kent | British | 33864420001 | ||||||||||
| TILNEY, Mark John | Director | Fenchurch Street EC3M 4BS London 71 United Kingdom | England | British | 166063340002 | |||||||||
| TURNEY, Rodney Desmond | Director | 44 Eisenhower Drive TN37 7TQ St. Leonards-On-Sea East Sussex | British | 79534980002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de R&Q REINSURANCE COMPANY (UK) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randall & Quilter Ii Holdings Limited | 26 jul 2018 | Fenchurch Street EC3M 4BS London 71 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Kenneth Edward Randall | 06 abr 2016 | Fenchurch Street EC3M 4BS London 71 United Kingdom | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: Bermuda | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Randall & Quilter Investment Holdings, Ltd. | 06 abr 2016 | 2 Church Street Hamilton Clarendon House Bermuda | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0