PRUDENTIAL (AN) LIMITED

PRUDENTIAL (AN) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPRUDENTIAL (AN) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01347088
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PRUDENTIAL (AN) LIMITED?

    • (6601) /

    ¿Dónde se encuentra PRUDENTIAL (AN) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PRUDENTIAL (AN) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PRUDENTIAL HOLBORN PENSIONS LIMITED21 sept 198721 sept 1987
    VANBRUGH PENSIONS LIMITED09 ene 197809 ene 1978

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PRUDENTIAL (AN) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PRUDENTIAL (AN) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    5 páginas4.71

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 3 Sheldon Square London W2 6PR

    2 páginasAD02

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 30 jun 2011

    LRESSP

    Domicilio social registrado cambiado de Laurence Pountney Hill London EC4R 0HH el 08 jul 2011

    2 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 13 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 jun 2011

    Estado de capital el 22 jun 2011

    • Capital: GBP 18,000,000
    SH01

    Nombramiento de Mr Mark Geoffrey Morbey como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Finbar O'dwyer como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Belsham como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Kelvin Nunn como director

    1 páginasTM01

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2010 au 30 jun 2011

    1 páginasAA01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    2 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    2 páginasAD02

    Déclaration annuelle établie au 13 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Kelvin Nunn como director

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    28 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de PRUDENTIAL (AN) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PRUDENTIAL GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    Secretario corporativo
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    79384540001
    MORBEY, Mark Geoffrey
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    Director
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    EnglandBritish94079860001
    RUPAREL, Vanessa Frances
    54 Clarendon Avenue
    CV32 4SA Leamington Spa
    Warwickshire
    Secretario
    54 Clarendon Avenue
    CV32 4SA Leamington Spa
    Warwickshire
    British66822710002
    WALKER, Robert
    6 Albion Road
    RH2 7JY Reigate
    Surrey
    Secretario
    6 Albion Road
    RH2 7JY Reigate
    Surrey
    British61132230001
    WALKER, Robert
    6 Albion Road
    RH2 7JY Reigate
    Surrey
    Secretario
    6 Albion Road
    RH2 7JY Reigate
    Surrey
    British61132230001
    ALLEN, Anthony Simon Echalaz
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    Director
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    British97055430001
    BEDELL PEARCE, Keith Leonard
    4 The Ridge
    CR8 3PE Purley
    Surrey
    Director
    4 The Ridge
    CR8 3PE Purley
    Surrey
    United KingdomBritish9522540001
    BELSHAM, David John
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    Director
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    United KingdomBritish51945120001
    BERKETT, Neil Anthony
    Woodpeckers 31 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    Director
    Woodpeckers 31 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    EnglandNew Zealander145735920001
    CASSONI, Maria Luisa
    125 Providence Square
    Bermondsey Wall West
    SE1 2ED London
    Director
    125 Providence Square
    Bermondsey Wall West
    SE1 2ED London
    EnglandBritish74583340001
    COOK, Alan Ronald
    Orchard Grange 28 Church End Road
    Shenley Brook End
    MK5 7AB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Director
    Orchard Grange 28 Church End Road
    Shenley Brook End
    MK5 7AB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish53705220002
    ELBOURNE, John Kenneth
    1 Lissoms Road
    CR5 3LE Chipstead
    Surrey
    Director
    1 Lissoms Road
    CR5 3LE Chipstead
    Surrey
    British4792320001
    EVERETT, Richard Charles
    23 Stanhope Way
    Riverhead
    TN13 2DZ Sevenoaks
    Kent
    Director
    23 Stanhope Way
    Riverhead
    TN13 2DZ Sevenoaks
    Kent
    British91615080001
    HANBY, Peter Nicholas
    12 Battledown Close
    GL52 6RD Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    12 Battledown Close
    GL52 6RD Cheltenham
    Gloucestershire
    British1553180001
    HARDING, David Charles Ian
    2 Castle Grove
    CV8 1NF Kenilworth
    Warwickshire
    Director
    2 Castle Grove
    CV8 1NF Kenilworth
    Warwickshire
    British92569260001
    HARRIS, Rosemary
    The Mount
    GU2 4JB Guildford
    74
    Surrey
    Director
    The Mount
    GU2 4JB Guildford
    74
    Surrey
    EnglandBritish228468970001
    HURD, Brian Willian
    70 Stamford Road
    WA14 2JF Bowden
    Cheshire
    Director
    70 Stamford Road
    WA14 2JF Bowden
    Cheshire
    EnglandUnited Kingdom99461690001
    JACK, James White
    Azalea Cottage
    Alderton Drive
    HP4 1NA Little Gaddesden
    Hertfordshire
    Director
    Azalea Cottage
    Alderton Drive
    HP4 1NA Little Gaddesden
    Hertfordshire
    EnglandBritish191658610001
    JACK, James White
    Azalea Cottage
    Alderton Drive
    HP4 1NA Little Gaddesden
    Hertfordshire
    Director
    Azalea Cottage
    Alderton Drive
    HP4 1NA Little Gaddesden
    Hertfordshire
    EnglandBritish191658610001
    MITCHELL, James Charles
    4 Strachan Crescent
    FK14 7HL Dollar
    Clackmannanshire
    Director
    4 Strachan Crescent
    FK14 7HL Dollar
    Clackmannanshire
    British26179390001
    MOORES, Michael John
    94 The Avenue
    TW16 5EX Sunbury On Thames
    Middlesex
    Director
    94 The Avenue
    TW16 5EX Sunbury On Thames
    Middlesex
    United KingdomBritish17690270001
    NICOLSON, Roy Macdonald
    'Ardgarten'
    45 Doune Road
    FK15 9HR Dunblane
    Perthshire
    Director
    'Ardgarten'
    45 Doune Road
    FK15 9HR Dunblane
    Perthshire
    British238750001
    NUNN, Kelvin
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    Director
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    United KingdomBritish109126660001
    O'DWYER, Finbar Anthony
    Tynebank Road
    EH41 4DW Haddington
    Tynebank House
    East Lothian
    Scotland
    Director
    Tynebank Road
    EH41 4DW Haddington
    Tynebank House
    East Lothian
    Scotland
    ScotlandIrish133418790001
    PULLEN, Trevor Keith
    Loxwood
    Grassy Lane
    TN13 1PL Sevenoaks
    Kent
    Director
    Loxwood
    Grassy Lane
    TN13 1PL Sevenoaks
    Kent
    British80114850001
    ROBERTSON, Angus John
    48 Kilpatrick Gardens
    Clarkston
    G76 7RH Glasgow
    Director
    48 Kilpatrick Gardens
    Clarkston
    G76 7RH Glasgow
    British64974900001
    ROBERTSON, William John
    4 Cavendish Drive
    Newton Mearns
    G77 5NY Glasgow
    Director
    4 Cavendish Drive
    Newton Mearns
    G77 5NY Glasgow
    ScotlandBritish145428580001
    SHAUGHNESSY, Gary Paul John
    Wheathold Farm
    Wolverton
    RG26 5SA Tadley
    Hampshire
    Director
    Wheathold Farm
    Wolverton
    RG26 5SA Tadley
    Hampshire
    United KingdomBritish153315930001
    SHEPPARD, Morag Helen
    The Station House
    FK9 3JX Arnprior
    Stirlingshire
    Director
    The Station House
    FK9 3JX Arnprior
    Stirlingshire
    British118314860001
    STEWART, Gavin Macneill
    17 Baldernock Road
    Milngavie
    G62 8DU Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    17 Baldernock Road
    Milngavie
    G62 8DU Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish4844910002
    TOOKEY, Timothy James William
    28 Brabourne Rise
    BR3 6SG Beckenham
    Kent
    Director
    28 Brabourne Rise
    BR3 6SG Beckenham
    Kent
    British57236570002
    WOOD, Gregory Mark
    21 Sprimont Place
    SW3 3HT London
    Director
    21 Sprimont Place
    SW3 3HT London
    British51415410002

    ¿Tiene PRUDENTIAL (AN) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of charge
    Creado el 30 jun 2005
    Entregado el 21 jul 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of floating charge all the chargor's right to and title and interest in the charged property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transacciones
    • 21 jul 2005Registro de un cargo (395)
    • 20 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Third party legal charge
    Creado el 12 mar 2003
    Entregado el 27 mar 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the trustees from time to time of the prudential holborn 1990 personal pension scheme (the trust) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Units 1 & 2 phase 4 forde court forde road brunel industrial estate newton abbot devon. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 27 mar 2003Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of legal charge
    Creado el 06 dic 1999
    Entregado el 16 dic 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a 39 new hall lane heaton bolton greater manchester. Floating charge over equipment thereon comprising all unfixed plants and machinery and other chattels and equipment now or in future.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 16 dic 1999Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of legal charge
    Creado el 06 dic 1999
    Entregado el 16 dic 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a 41 new hall lane heaton bolton greater manchester. Floating charge over equipment thereon comprising all unfixed plants and machinery and other chattels and equipment now or in future.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 16 dic 1999Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 25 ago 1999
    Entregado el 28 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property known as charlton house, draytons passage, shrewsbury shropshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 28 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 20 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 25 ago 1999
    Entregado el 28 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Unit 9 sweetlake business village shrewsbury shropshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 28 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 27 mar 1998
    Entregado el 16 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company as trustees of prudential (1990) personal pension scheme (a/c R.d edwards and D.J.lowe) to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    14A the thoroughfare halesworth suffolk. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Personas con derecho
    • Nationwide Building Society
    Transacciones
    • 16 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 12 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 jun 1997
    Entregado el 02 jul 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge
    Breve descripción
    Suite 3, 26 church street bishops stortford herts ("the property") t/n-HD296149. Note: clause 43: notwithstanding any provision to the contary contained in this charge the bank shall only be entitled to recover any moneys due from the mortgagor under this charge from the proceeds of realisation of the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 02 jul 1997Registro de un cargo (395)
    • 20 ene 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 16 jun 1997
    Entregado el 20 jun 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property at 19 birmingham street oldbury warley west midlands.t/no.wm 194784.note:by clause 13 of the deed the mortgage is placed on a "limited recourse" basis,excluding any fixed/floating charges over assets other than the property.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 20 jun 1997Registro de un cargo (395)
    • 12 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 19 jul 1996
    Entregado el 31 jul 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company k a lambert b trust w s michie and b a e maydell to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property at units 17 & 18 the capstan centre thurrock park way tilbury essex with the benefit of all rights licences and guarantees and the goodwill of the business. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 31 jul 1996Registro de un cargo (395)
    • 12 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 12 may 1995
    Entregado el 23 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    73 high street southwold suffolk. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on the mortgaged prorerty and the goodwill carried on at the mortgaged property together with the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Personas con derecho
    • Nationwide Building Society
    Transacciones
    • 23 may 1995Registro de un cargo (395)
    • 12 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security
    Creado el 28 abr 1995
    Entregado el 10 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The old toll garage, 128 and 128A main street overton wishaw scotland.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 10 may 1995Registro de un cargo (395)
    • 02 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene PRUDENTIAL (AN) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    30 jun 2011Inicio de la liquidación
    26 sept 2012Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profesional
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Alistair Steven Wood
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Profesional
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0