NESTOR MEDICAL DUTY SERVICES LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | NESTOR MEDICAL DUTY SERVICES LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01354503 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de NESTOR MEDICAL DUTY SERVICES LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra NESTOR MEDICAL DUTY SERVICES LIMITED?
Dirección de la sede social | Cavendish House Lakpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NESTOR MEDICAL DUTY SERVICES LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
NESTOR MEDICAL DEPUTISING GROUP LIMITED | 31 dic 1979 | 31 dic 1979 |
VENTADALE LIMITED | 23 feb 1978 | 23 feb 1978 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de NESTOR MEDICAL DUTY SERVICES LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para NESTOR MEDICAL DUTY SERVICES LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Cese del nombramiento de Carl Michael Brown como director el 21 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2017 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Henry Whitehead como director el 12 jun 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Carl Michael Brown como director el 12 jun 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 20 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Mark Preece como director el 16 feb 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Richard Mark Preece como director el 22 ene 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy Mark Pethick como director el 31 dic 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 31 ene 2016 au 31 dic 2015 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Victoria Haynes como secretario el 01 dic 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Enbrook Park Sandgate Folkestone Kent CT20 3SE a Cavendish House Lakpur Court Staffordshire Technology Park Stafford ST18 0FX el 04 dic 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ene 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Darryn Stanley Gibson como director el 09 sept 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Timothy Mark Pethick como director el 09 sept 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr John Henry Whitehead el 01 mar 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 jun 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ene 2014 | 3 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de NESTOR MEDICAL DUTY SERVICES LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLISON, David | Secretario | 44 Lowther Road SW13 9NU London England | British | 34835160001 | ||||||
DAVIES, John | Secretario | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | 158562460001 | |||||||
HAYNES, Victoria | Secretario | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | British | 182412280001 | ||||||
NGONDONGA, Taguma | Secretario | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire United Kingdom | 171612800001 | |||||||
ROBERTS THOMAS, Caroline Emma | Secretario | 5 Broomsleigh Street NW6 1QQ London | British | Company Secretary | 76032450005 | |||||
WOOD, John | Secretario | Pear Tree Cottage Bishopstone HP12 8SH Aylesbury Buckinghamshire | British | 59323380001 | ||||||
ARNOLD, Thomas George | Director | 253 Brookhurst Avenue L63 0PG Bromborough Merseyside | British | Finance Director | 57124490001 | |||||
BOOTY, Stephen Martin | Director | South Lodge Guildford Road KT24 5QE Effingham Surrey | United Kingdom | British | Director | 147928010001 | ||||
BROWN, Carl Michael | Director | Lakpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House United Kingdom | England | British | Accountant | 232841280001 | ||||
CHAPMAN, Clive Richard | Director | Flat 1 36 Oakley Street SW3 5NT London | United Kingdom | British | Finance Director | 86129050001 | ||||
COCKBURN, John Jeffrey, Doctor | Director | Flat 14 Brompton Court 2a Brompton Avenue Sefton Park L17 3BY Liverpool | British | Company Director | 11672280012 | |||||
ELLIS, Martyn Anthony | Director | Beaconsfield Road AL10 8HU Hatfield Beaconsfield Court Hertfordshire | England | British | Group Finance Director | 95749550002 | ||||
FITZGERALD, John Gerald Anthony, Dr | Director | 141 Monmouth Drive B73 6JN Sutton Coldfield West Midlands | Irish | Doctor | 11715250001 | |||||
GIBSON, Darryn Stanley | Director | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | United Kingdom | New Zealander | Company Director | 177930490001 | ||||
GILL, Waseem Tariq, Dr | Director | 6 Malvern Drive WA14 4NQ Altrincham Cheshire | British | Medical Director | 55080700001 | |||||
HOWARD, Stuart Michael | Director | Enbrook Park CT20 3SE Folkestone 2 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 160271430001 | ||||
IVERS, John Joseph | Director | Beaconsfield Road AL10 8HU Hatfield Beaconsfield Court Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 77692980002 | ||||
JEWITT, Justin Allan Spaven, Professor | Director | The Stables 89 Aston End Road Aston SG2 7EY Stevenage Hertfordshire | England | British | Group Chief Executive | 39701670001 | ||||
LYON, David Oliver | Director | 41 Park Avenue North AL5 2EE Harpenden Hertfordshire | England | British | Group Finance Director | 51084280003 | ||||
PAGE, Stephen Robert | Director | Oak Tree House Berry Lane WD3 5EY Chorleywood Hertfordshire | England | British | Director | 257896700001 | ||||
PETHICK, Timothy Mark | Director | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 172197670001 | ||||
PREECE, Richard Mark | Director | Lakpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House United Kingdom | England | British | Company Director | 97531900001 | ||||
ROGERS, Michael Greig | Director | 1 Jenningsbury Court London Road SG13 7NS Hertford Hertfordshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 107156650001 | ||||
STOKES, Marilyn Ann | Director | 35 Fox Hollies Road Walmley B76 2RJ Sutton Coldfield West Midlands | England | British | Managing Director | 3284280001 | ||||
WHITEHEAD, John Henry | Director | Beaconsfield Road AL10 8HU Hatfield Beaconsfield House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 182872850002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de NESTOR MEDICAL DUTY SERVICES LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nestor Healthcare Group Limited | 06 abr 2016 | Lakhpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene NESTOR MEDICAL DUTY SERVICES LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Creado el 30 abr 1986 Entregado el 09 may 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge on the company onthe company f/h & l/h property ad & the proceeds of sale fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Collatered debenture | Creado el 30 abr 1986 Entregado el 09 may 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from nester-bna limited to the charge on any account whatsoever. | |
Breve descripción Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Collateral debenture | Creado el 30 abr 1986 Entregado el 09 may 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from nesster-bna limited to the charge on any account whatsoever. | |
Breve descripción Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0