KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED

KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01356836
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED?

    • fabricación de productos de alambre, cadenas y resortes (25930) / Industrias manufactureras
    • fabricación de otros cables y alambres electrónicos y eléctricos (27320) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4 Stirling Court
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Herts
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PLESSEY WIRING SYSTEMS LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    PLESSEY GROUP SERVICES LIMITED09 mar 197809 mar 1978

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    19 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 16 abr 2016

    17 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de Brook Point 1412-1420 High Road Whetstone London N20 9BH a 4 Stirling Court Stirling Way Borehamwood Herts WD6 2BT el 19 oct 2015

    1 páginasAD01

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 16 abr 2015

    19 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 16 abr 2014

    19 páginas4.68

    Resumen de ingresos y gastos del supervisor del acuerdo voluntario hasta 01 abr 2014

    8 páginas1.3

    Notificación de finalización del acuerdo voluntario

    8 páginas1.4

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación

    LRESEX

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    600

    Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19

    22 páginas4.20

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Domicilio social registrado cambiado de * 5 Fleet Place London EC4M 7RD England* el 11 abr 2013

    2 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Company place voluntary creditors liquidation/appoint liquidator 27/03/2013
    RES13

    legacy

    5 páginasMG01

    Déclaration annuelle établie au 01 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 feb 2013

    Estado de capital el 20 feb 2013

    • Capital: GBP 2,718,215
    SH01

    Cese del nombramiento de William Gimson como director

    2 páginasTM01

    Modification de la date de clôture de l'exercice comptable

    3 páginasAA01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2011

    23 páginasAA

    Notificación al Registro Mercantil del acuerdo voluntario de empresas que entra en vigor

    8 páginas1.1

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Richard Martin como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Andrew Mckerrow como director

    1 páginasTM01

    legacy

    6 páginasMG02

    ¿Quiénes son los directivos de KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HALCO SECRETARIES LIMITED
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Secretario corporativo
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2503744
    146855460001
    GIMSON, John Peter
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    4 Stirling Court
    Herts
    Director
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    4 Stirling Court
    Herts
    EnglandBritishDirector89639570001
    EDGE, Geoffrey
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    Secretario
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    British2055530001
    ELLARD, Sarah Louise
    3 Glenney Close
    PO13 8FD Lee On The Solent
    Hampshire
    Secretario
    3 Glenney Close
    PO13 8FD Lee On The Solent
    Hampshire
    BritishCompany Secretary43855640009
    LEIGHTON, Iain Gordon Kerr
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    Secretario
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    British42841660001
    VINE, Sylvia Elizabeth Faith
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    Secretario
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    BritishCompany Director3801050001
    WILLIFER, Mark Eamon
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Secretario
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    BritishDirector33089100003
    AUSTIN, Brian Sergio, Mr.
    Innovis House
    108 High Street
    RH10 1AS Crawley
    West Sussex
    Director
    Innovis House
    108 High Street
    RH10 1AS Crawley
    West Sussex
    EnglandBritishManaging Director83674480001
    BILLINGTON, Philip Gordon
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    Director
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    BritishChairman18247670001
    BOWEN, Malcolm Alvin
    29 Purn Road
    Bleadon
    BS24 9JQ Weston Super Mare
    Avon
    Director
    29 Purn Road
    Bleadon
    BS24 9JQ Weston Super Mare
    Avon
    BritishManager27471100001
    CLEARY, Michael John
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    Director
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishDirector1525670001
    DAVIES, Arthur Thomas
    Charlecote 4 Stag Gates
    Blackfield
    SO45 1SR Southampton
    Hants
    Director
    Charlecote 4 Stag Gates
    Blackfield
    SO45 1SR Southampton
    Hants
    BritishDirector24258700001
    EVANS, David Roger
    Yoxhall Lodge
    10 Worsley Road
    PO5 3DY Southsea
    Hampshire
    Director
    Yoxhall Lodge
    10 Worsley Road
    PO5 3DY Southsea
    Hampshire
    EnglandBritishChief Executive4471420003
    GIBBS, Raymond John
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    Director
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    BritishFinance Director & Company Sec85421380001
    GIMSON, William Peter Critchley
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Director
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    United Kingdom British Director162987980001
    HOLLAND, Richard Andrew
    Cedarcroft
    Twyning Green
    GL20 6DQ Tewkesbury
    Gloucestershire
    Director
    Cedarcroft
    Twyning Green
    GL20 6DQ Tewkesbury
    Gloucestershire
    EnglandBritishManaging Director107177720001
    LYNN, John James
    House On The Corner
    Cricklade Street, Poulton
    GL7 5HW Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    House On The Corner
    Cricklade Street, Poulton
    GL7 5HW Cirencester
    Gloucestershire
    BritishManaging Director69883500001
    MACDERMOTT, Philip
    179 Sternhold Avenue
    SW2 4PF London
    Director
    179 Sternhold Avenue
    SW2 4PF London
    BritishDirector25679470001
    MARTIN, Richard
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Director
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    EnglandBritishDirector27471110004
    MCKERROW, Andrew James
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Director
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    EnglandBritishFinance Director83845420002
    MOLONY, Peter John
    Mill House
    Great Elm
    BA11 3NY Frome
    Somerset
    Director
    Mill House
    Great Elm
    BA11 3NY Frome
    Somerset
    BritishChief Executive42803990001
    RAINBIRD, Graham Dennis
    23 Barcote Close
    Redhouse
    SN25 2BH Swindon
    Wiltshire
    Director
    23 Barcote Close
    Redhouse
    SN25 2BH Swindon
    Wiltshire
    BritishOperations Director83845440002
    RAYNER, Paul Adrian
    48 Kilham Lane
    SO22 5QD Winchester
    Hampshire
    Director
    48 Kilham Lane
    SO22 5QD Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritishFinance Director45628680002
    RAYNER, Paul Adrian
    The Well House
    Collins Lane Hursley
    SO21 2JX Winchester
    Hampshire
    Director
    The Well House
    Collins Lane Hursley
    SO21 2JX Winchester
    Hampshire
    BritishFinancial Director45628680001
    SHORE, David Alan
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Director
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    United KingdomBritishJoint Managing Director116529450001
    STOPPS, Ian Robert, Mr.
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Director
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    United KingdomBritishChairman154207190001
    WHITEHORN, Justin Michael
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    Director
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector42825970001
    WILLIFER, Mark Eamon
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Director
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    United KingdomBritishDirector33089100003

    ¿Tiene KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 05 mar 2013
    Entregado el 06 mar 2013
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the charge holder on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property including goodwill, debts, uncalled capital see image for full details.
    Personas con derecho
    • Champlain Cable Corporation
    Transacciones
    • 06 mar 2013Registro de un cargo (MG01)
    Full form debenture
    Creado el 04 jul 2011
    Entregado el 19 jul 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Leumi Abl Limited
    Transacciones
    • 19 jul 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 24 mar 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 13 ago 2010
    Entregado el 25 ago 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Leumi Abl Limited
    Transacciones
    • 25 ago 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 24 mar 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creado el 27 sept 2004
    Entregado el 05 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transacciones
    • 05 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 02 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 08 nov 2003
    Entregado el 15 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Venture Finance PLC
    Transacciones
    • 15 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 14 ago 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creado el 05 feb 2001
    Entregado el 14 feb 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the chargee under or pursuant to the financing documents (all terms defined therein)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transacciones
    • 14 feb 2001Registro de un cargo (395)
    • 11 nov 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over book debts
    Creado el 06 dic 1994
    Entregado el 14 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific charge over all book debts and other debts as from time to time be due or owing to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 14 dic 1994Registro de un cargo (395)
    • 09 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 29 abr 1993
    Entregado el 06 may 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to the principal charge dated 18/12/89
    Breve descripción
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 06 may 1993Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 sept 1990
    Entregado el 09 oct 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 09 oct 1990Registro de una carga
    • 15 mar 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 18 dic 1989
    Entregado el 02 ene 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge on all book & other debts floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 02 ene 1990Registro de una carga
    • 15 mar 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 15 jul 1988
    Entregado el 21 jul 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    First fixed charge as all book and otherdebts floating charge on all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 21 jul 1988Registro de una carga
    • 15 mar 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 10 ago 1982
    Entregado el 20 ago 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    First food charge over all book & other debts with 9 floating charge over (see doc 34). undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 20 ago 1982Registro de una carga

    ¿Tiene KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    19 jul 2012Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    01 abr 2014Fecha de finalización o terminación del CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Eric Walls
    C12 Marquis Court Marquis Way
    Team Valley
    NE11 0RU Gateshead
    Profesional
    C12 Marquis Court Marquis Way
    Team Valley
    NE11 0RU Gateshead
    2
    FechaTipo
    17 abr 2013Inicio de la liquidación
    30 sept 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    John Stephen Kelmanson
    Brook Point 1412-1420 High Road
    N20 9BH London
    Profesional
    Brook Point 1412-1420 High Road
    N20 9BH London
    Alexander Kinninmonth
    Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire
    Profesional
    Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0