SJ PERRY NO. 1 LIMITED

SJ PERRY NO. 1 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSJ PERRY NO. 1 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01360993
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SJ PERRY NO. 1 LIMITED?

    • Otras industrias manufactureras n.c.p. (32990) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra SJ PERRY NO. 1 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Chitterman Grange Polly Botts Lane
    Ulverscroft
    LE67 9PT Markfield
    Leicestershire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SJ PERRY NO. 1 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GRAPHICRAFT LIVERIES LIMITED29 dic 199529 dic 1995
    GRAPHICRAFT LIMITED08 dic 198708 dic 1987
    CURTAYNE AND NORMAN LIMITED03 abr 197803 abr 1978

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SJ PERRY NO. 1 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 nov 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para SJ PERRY NO. 1 LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SJ PERRY NO. 1 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Domicilio social registrado cambiado de Singer Way Woburn Road Ind Estate Kempston Bedford MK42 7AN el 17 jun 2014

    1 páginasAD01

    Cancelación total de la carga 8

    1 páginasMR04

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed graphicraft liveries LIMITED\certificate issued on 09/06/14
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name09 jun 2014

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 02 jun 2014

    RES15

    Déclaration annuelle établie au 09 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 nov 2013

    Estado de capital el 12 nov 2013

    • Capital: GBP 2,000
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 nov 2012

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 30 nov 2011

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 30 nov 2010

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 30 nov 2009

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 nov 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Steven James Perry el 09 nov 2009

    2 páginasCH01

    Cuentas preparadas hasta el 30 nov 2008

    6 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    legacy

    3 páginas363a

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cuentas preparadas hasta el 30 nov 2007

    6 páginasAA

    Cuentas preparadas hasta el 30 nov 2006

    5 páginasAA

    legacy

    6 páginas363s

    Cuentas preparadas hasta el 30 nov 2005

    5 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de SJ PERRY NO. 1 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ADAMSON, Paul
    128 Putnoe Street
    MK41 8HJ Bedford
    Bedfordshire
    Secretario
    128 Putnoe Street
    MK41 8HJ Bedford
    Bedfordshire
    BritishFinancial Controller98602940001
    PERRY, Steven James
    Chitterman Grange
    Polly Botts Lane Ulverscroft
    LE67 9PT Markfield
    Director
    Chitterman Grange
    Polly Botts Lane Ulverscroft
    LE67 9PT Markfield
    EnglandBritishManaging Director37681100004
    COLLEY, Richard Gwyn
    The Gray House 3 Church Street
    Market Bosworth
    CV13 0LG Nuneaton
    Warwickshire
    Secretario
    The Gray House 3 Church Street
    Market Bosworth
    CV13 0LG Nuneaton
    Warwickshire
    British116469150001
    CURTAYNE, Olga Marguerita
    39 Church Road
    Oakley
    MK43 7RP Bedford
    Bedfordshire
    Secretario
    39 Church Road
    Oakley
    MK43 7RP Bedford
    Bedfordshire
    British18811230001
    MCGREEVY, Jillian
    5 The Chase
    Kempston Rural
    MK43 9HN Bedford
    Bedfordshire
    Secretario
    5 The Chase
    Kempston Rural
    MK43 9HN Bedford
    Bedfordshire
    BritishFinancial Controller38142800003
    PERRY, Steven James
    12 Oakley Drive
    LE11 3LF Loughborough
    Leicestershire
    Secretario
    12 Oakley Drive
    LE11 3LF Loughborough
    Leicestershire
    British37680930001
    BARTRAM, David John
    5 Kimble Drive
    MK41 9SX Bedford
    Bedfordshire
    Director
    5 Kimble Drive
    MK41 9SX Bedford
    Bedfordshire
    BritishDirector37681010001
    CURTAYNE, Olga Marguerita
    39 Church Road
    Oakley
    MK43 7RP Bedford
    Bedfordshire
    Director
    39 Church Road
    Oakley
    MK43 7RP Bedford
    Bedfordshire
    BritishCompany Director18811230001
    CURTAYNE, Terry John
    39 Church Road
    Oakley
    MK43 7RP Bedford
    Director
    39 Church Road
    Oakley
    MK43 7RP Bedford
    BritishCompany Director18811240001
    HYAMS, Anthony Michael
    81 Broad Road
    M33 2EU Sale
    Cheshire
    Director
    81 Broad Road
    M33 2EU Sale
    Cheshire
    BritishVenture Capital Dire56167340003
    KEYWORTH, Stanley John
    St Christophers
    2 Croft Bank
    WR14 4BW West Malvern
    Worcestershire
    Director
    St Christophers
    2 Croft Bank
    WR14 4BW West Malvern
    Worcestershire
    BritishDirector75121880001
    MCGREEVY, Jillian
    5 The Chase
    Kempston Rural
    MK43 9HN Bedford
    Bedfordshire
    Director
    5 The Chase
    Kempston Rural
    MK43 9HN Bedford
    Bedfordshire
    BritishFinance Director38142800003
    NORMAN, Gordon
    88 Station Road
    Tempsford
    SG19 2AX Sandy
    Bedfordshire
    Director
    88 Station Road
    Tempsford
    SG19 2AX Sandy
    Bedfordshire
    BritishCompany Director59185010001
    NORMAN, Irene Margaret
    Pyghtle Farmhouse 88 Station Road
    Tempsford
    SG19 2AX Sandy
    Bedfordshire
    Director
    Pyghtle Farmhouse 88 Station Road
    Tempsford
    SG19 2AX Sandy
    Bedfordshire
    BritishCompany Director18811260001
    PERRY, Steven James
    12 Oakley Drive
    LE11 3LF Loughborough
    Leicestershire
    Director
    12 Oakley Drive
    LE11 3LF Loughborough
    Leicestershire
    BritishDirector37681100001

    ¿Tiene SJ PERRY NO. 1 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 25 nov 2005
    Entregado el 26 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 26 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 17 jun 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture stock deed
    Creado el 21 ene 1994
    Entregado el 03 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £777,000 and all other sums due from the company and/or graphicraft holdings limited to the chargees
    Breve descripción
    15 the manton centre,manton lane,bedford MK41 9PX. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Terry John Curtayne,Olga Marguerita Curtayne,Gordon Charles Norman and Irene Margaret Norman
    Transacciones
    • 03 feb 1994Registro de un cargo (395)
    • 30 sept 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 21 ene 1994
    Entregado el 02 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or graphicraft holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 feb 1994Registro de un cargo (395)
    • 30 sept 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Marine mortgage
    Creado el 09 dic 1986
    Entregado el 19 dic 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account currant
    Breve descripción
    Sixty four shares by way of a legal mortgage in the vessel named "serani girl" official number 712042 which was registered in the port of plymouth under number 45 in 1986.
    Personas con derecho
    • Nws Trust Limited.
    Transacciones
    • 19 dic 1986Registro de una carga
    • 16 nov 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 01 dic 1983
    Entregado el 08 dic 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Please see doc M17).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 dic 1983Registro de una carga
    • 18 feb 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 15 feb 1983
    Entregado el 22 feb 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current
    Breve descripción
    64/64 shares in the "penang girl" (evolution 22) sailing vessel official number 397751.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central Public Limited Company
    Transacciones
    • 22 feb 1983Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 10 mar 1981
    Entregado el 28 mar 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £5,400
    Breve descripción
    The vessel:- evolution 22 1981 with outboard engine.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central Limited
    Transacciones
    • 28 mar 1981Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 05 feb 1981
    Entregado el 13 feb 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold & leasehold properties. Fixed & floating charges over the undertaking & all property & assets both present & future including goodwill & book debts.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 feb 1981Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0