HALAROSE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | HALAROSE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01362834 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HALAROSE LIMITED?
- Actividades de consultoría en tecnología de la información (62020) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra HALAROSE LIMITED?
| Dirección de la sede social | 2nd Floor, Waterside 1310 Arlington Business Park, Theale RG7 4SA Reading England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HALAROSE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 may 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HALAROSE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Robert James Grubb como director el 01 nov 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 oct 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Graham Quinton Kellett-Clarke como director el 30 ago 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jane Mackie como secretario el 30 ago 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jane Mackie como director el 30 ago 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Ruth Paterson como secretario el 30 ago 2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Ruth Paterson como director el 30 ago 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David John Meaden como director el 01 jun 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 may 2018 au 31 oct 2018 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew John Riley como director el 03 mar 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Richard Graham Quinton Kellett-Clarke como director el 03 ene 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 may 2017 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 oct 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 10 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Jane Mackie como secretario el 16 ago 2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Alan John Quinton como director el 16 ago 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Peter Pinnell como director el 16 ago 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Vinay John Neogi como director el 16 ago 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cessation de Carol Joan Quinton en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 ago 2017 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Alan Tsz-Hing Mok en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 ago 2017 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cessation de William Alan John Quinton en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 ago 2017 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de HALAROSE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATERSON, Ruth | Secretario | Arlington Business Park, Theale RG7 4SA Reading 2nd Floor, Waterside 1310 England | 249933310001 | |||||||
| GRUBB, Robert James | Director | Arlington Business Park, Theale RG7 4SA Reading 2nd Floor, Waterside 1310 England | England | British | 130190980002 | |||||
| MEADEN, David John | Director | Arlington Business Park, Theale RG7 4SA Reading 2nd Floor, Waterside 1310 England | England | British | 247279410001 | |||||
| PATERSON, Ruth | Director | Arlington Business Park, Theale RG7 4SA Reading 2nd Floor, Waterside 1310 England | Northern Ireland | Irish | 249931280001 | |||||
| MACKIE, Jane | Secretario | Arlington Business Park, Theale RG7 4SA Reading 2nd Floor, Waterside 1310 England | 236936060001 | |||||||
| QUINTON, Carol Joan | Secretario | Black Lion Cottage Greenmoor Woodcote RG8 0RD Oxon | British | 43309140001 | ||||||
| QUINTON, Thomas Henry Alexander | Secretario | Bennerley Road SW11 6DR London 75 | 146425630001 | |||||||
| FUSSELL, Philip James | Director | Beechwood Court Long Toll RG8 0RR Woodcote Goring House Oxfordshire | United Kingdom | British | 176547260002 | |||||
| HARDY, Dale Anthony | Director | 166 Elgar Road RG2 0BN Reading Berkshire | British | 59887540002 | ||||||
| KELLETT-CLARKE, Richard Graham Quinton | Director | Arlington Business Park, Theale RG7 4SA Reading 2nd Floor, Waterside 1310 England | England | British | 138013280002 | |||||
| KILANOWSKI, Slawomir | Director | Beechwood Court Long Toll RG8 0RR Woodcote Goring House Oxfordshire | England | British | 182324700001 | |||||
| MACKIE, Jane | Director | Arlington Business Park, Theale RG7 4SA Reading 2nd Floor, Waterside 1310 England | Scotland | British | 185540170001 | |||||
| MOK, Alan Tsz-Hing | Director | Arlington Business Park, Theale RG7 4SA Reading 2nd Floor, Waterside 1310 England | England | British | 118719580001 | |||||
| NEOGI, Vinay John | Director | Arlington Business Park, Theale RG7 4SA Reading 2nd Floor, Waterside 1310 England | England | British | 203732460001 | |||||
| PINNELL, David Peter | Director | Arlington Business Park, Theale RG7 4SA Reading 2nd Floor, Waterside 1310 England | United Kingdom | British | 166768190001 | |||||
| POOLE, Christopher George | Director | Tavystones 15 Crandford Close EX20 4HB Okehampton Devon | British | 76327730001 | ||||||
| QUINTON, Carol Joan | Director | Black Lion Cottage Greenmoor Woodcote RG8 0RD Oxon | United Kingdom | British | 43309140001 | |||||
| QUINTON, Christopher John | Director | Black Lion Cottage Greenmoor RG8 0RD Woodcote Oxfordshire | England | British | 21406350001 | |||||
| QUINTON, Thomas Henry Alexander | Director | Bennerley Road SW11 6DR London 75 | United Kingdom | British | 132884620001 | |||||
| QUINTON, William Alan John, Dr | Director | Arlington Business Park, Theale RG7 4SA Reading 2nd Floor, Waterside 1310 England | England | British | 129178400002 | |||||
| RILEY, Andrew John | Director | Arlington Business Park, Theale RG7 4SA Reading 2nd Floor, Waterside 1310 England | England | British | 199618290001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HALAROSE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halarose Holdings Limited | 16 ago 2017 | Arlington Business Park, Theale RG7 4SA Reading 2nd Floor, Waterside 1310 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Alan Tsz-Hing Mok | 06 abr 2016 | Arlington Business Park, Theale RG7 4SA Reading 2nd Floor, Waterside 1310 England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mrs Carol Joan Quinton | 06 abr 2016 | Arlington Business Park, Theale RG7 4SA Reading 2nd Floor, Waterside 1310 England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Dr William Alan John Quinton | 06 abr 2016 | Arlington Business Park, Theale RG7 4SA Reading 2nd Floor, Waterside 1310 England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene HALAROSE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 18 ago 2008 Entregado el 21 ago 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 18 ago 2008 Entregado el 21 ago 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property k/a shop 1 and flat 1, wood green, goring road, woodcote, reading t/no ON178105 all fixtures & fittings & all fixed plant & machinery (not being chattels within the meaning of the bills of sales acts). A floating charge over all unfixed plant & machinery & other chattels & equipment, & assigns the goodwill of the business carried on at or from the property & the benefit of the licence or certificate. The right to recover & receive any compensation payable in respect of the licence or the certificate. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 18 ago 2008 Entregado el 20 ago 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge | Creado el 11 nov 1982 Entregado el 02 dic 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed charge over all book debts & other debts due during or incurred to the company interest & future floaitng charge over present aned future including uncalled capital (see doc M26). Undertaking and all property and assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0