PAC INTERNATIONAL LIMITED

PAC INTERNATIONAL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPAC INTERNATIONAL LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01363776
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PAC INTERNATIONAL LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra PAC INTERNATIONAL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Stanley Black & Decker Hellaby Lane
    Hellaby
    S66 8HN Rotherham
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PAC INTERNATIONAL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SOFTWARE CONTROL LIMITED19 ene 198319 ene 1983
    ASSYDES LIMITED19 abr 197819 abr 1978

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PAC INTERNATIONAL LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2024
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PAC INTERNATIONAL LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta29 jun 2025
    Próxima declaración de confirmación vence13 jul 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta29 jun 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PAC INTERNATIONAL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cambio de datos del director Mr Amit Kumar Sood el 09 may 2025

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Steven John Costello el 09 may 2025

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Steven John Costello el 09 may 2025

    1 páginasCH03

    Declaración de confirmación presentada el 29 jun 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023

    3 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 29 jun 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de 270 Bath Road Slough Berkshire SL1 4DX United Kingdom a C/O Stanley Black & Decker Hellaby Lane Hellaby Rotherham South Yorkshire S66 8HN el 17 jun 2023

    1 páginasAD01

    Cambio de datos del director Mr Amit Kumar Sood el 22 may 2023

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    3 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Steven John Costello el 22 jul 2022

    1 páginasCH03

    Nombramiento de Mr Amit Kumar Sood como director el 15 jul 2022

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Mark Richard Smiley como director el 15 jul 2022

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Steven John Costello como director el 15 jul 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Stephen Lord como director el 15 jul 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 29 jun 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Stephanie Irene Merrifield como director el 01 mar 2022

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Ms Stephanie Irene Merrifield el 19 nov 2021

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Andrew Stephen Lord el 19 nov 2021

    2 páginasCH01

    Modification des détails de Stanley Security Solutions Operations Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 nov 2021

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de Stanley House Bramble Road Swindon Wilts SN2 8ER a 270 Bath Road Slough Berkshire SL1 4DX el 19 nov 2021

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 29 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 29 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de PAC INTERNATIONAL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COSTELLO, Steven John
    Hellaby Lane
    Hellaby
    S66 8HN Rotherham
    C/O Stanley Black & Decker
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Hellaby Lane
    Hellaby
    S66 8HN Rotherham
    C/O Stanley Black & Decker
    South Yorkshire
    United Kingdom
    186094530001
    COSTELLO, Steven John
    Hellaby Lane
    Hellaby
    S66 8HN Rotherham
    C/O Stanley Black & Decker
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Hellaby Lane
    Hellaby
    S66 8HN Rotherham
    C/O Stanley Black & Decker
    South Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant217824350001
    SMILEY, Mark Richard
    Europa Court
    Sheffield Business Park
    S9 1XE Sheffield
    3
    England And Wales
    United Kingdom
    Director
    Europa Court
    Sheffield Business Park
    S9 1XE Sheffield
    3
    England And Wales
    United Kingdom
    United KingdomBritishGeneral Manager Uk & Roi194271890001
    SOOD, Amit Kumar
    Hellaby Lane
    Hellaby
    S66 8HN Rotherham
    C/O Stanley Black & Decker
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Hellaby Lane
    Hellaby
    S66 8HN Rotherham
    C/O Stanley Black & Decker
    South Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director195541990002
    COLLINS, Richard Hawke
    5 Halland Road
    GL53 0DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    5 Halland Road
    GL53 0DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British53398040001
    HAYHURST, Fred
    Europa Court
    Sheffield Business Park
    S9 1XE Sheffield
    3
    S Yorkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Europa Court
    Sheffield Business Park
    S9 1XE Sheffield
    3
    S Yorkshire
    United Kingdom
    British149706500001
    HENDERSON, Alex
    8 Pulteney Avenue
    BA2 4HH Bath
    Secretario
    8 Pulteney Avenue
    BA2 4HH Bath
    British81352070001
    MACINNES, Colin David
    The Well Cottage
    61 Caps Lane
    OX10 9HQ Cholsey
    Oxfordshire
    Secretario
    The Well Cottage
    61 Caps Lane
    OX10 9HQ Cholsey
    Oxfordshire
    British7341360001
    TAYLOR, Christine
    7 Fatherford Close Diggle
    Saddleworth
    OL3 5PY Oldham
    Secretario
    7 Fatherford Close Diggle
    Saddleworth
    OL3 5PY Oldham
    BritishCompany Secretary35658270001
    WHITTAM, Karen Anne
    19 Seven Stiles Drive
    Marple
    SK6 6LT Stockport
    Cheshire
    Secretario
    19 Seven Stiles Drive
    Marple
    SK6 6LT Stockport
    Cheshire
    British29646020001
    BERTENSHAW, Philip
    98 Glossop Road
    Marple Bridge
    SK6 5EL Stockport
    Cheshire
    Director
    98 Glossop Road
    Marple Bridge
    SK6 5EL Stockport
    Cheshire
    BritishCorporate Executive83849370001
    BEST, Richard John
    2/R 3 Holmbank Avenue
    Shawlands
    G41 3JQ Glasgow
    Strathclyde
    Scotland
    Director
    2/R 3 Holmbank Avenue
    Shawlands
    G41 3JQ Glasgow
    Strathclyde
    Scotland
    BritishDirector61334520001
    BEWICK, Stephen Alfred
    Peace Cottage
    St Marys Way, Brownshill
    GL6 8SW Stroud
    Glos
    Director
    Peace Cottage
    St Marys Way, Brownshill
    GL6 8SW Stroud
    Glos
    EnglandBritishSales & Marketing122982330001
    BOUSTEAD, Roger
    3 Cressingham Road
    Stretford
    M32 9DN Manchester
    Director
    3 Cressingham Road
    Stretford
    M32 9DN Manchester
    BritishOperations Director75578870001
    COGZELL, Matthew James
    Stanley House
    Bramble Road
    SN2 8ER Swindon
    Wilts
    Director
    Stanley House
    Bramble Road
    SN2 8ER Swindon
    Wilts
    EnglandBritishHr Director157755080001
    COOKE, Dean Christopher
    14 Erleigh Drive
    SN15 2NQ Chippenham
    Director
    14 Erleigh Drive
    SN15 2NQ Chippenham
    United KingdomBritishAccountant85254310002
    COWLEY, John Mitchell
    Stanley House
    Bramble Road
    SN2 8ER Swindon
    Wilts
    Director
    Stanley House
    Bramble Road
    SN2 8ER Swindon
    Wilts
    EnglandBritishDirector153045530001
    FENNA, David Geoffrey
    119 New Hall Lane
    Heaton
    BL1 5HQ Bolton
    Director
    119 New Hall Lane
    Heaton
    BL1 5HQ Bolton
    BritishDirector43266490002
    GINNEVER, Bruce Quentin
    The Forge
    GL7 5JS Meysey Hampton
    Cirencester
    Director
    The Forge
    GL7 5JS Meysey Hampton
    Cirencester
    United KingdomBritishDirector19214470003
    GLOSTER, Michael George
    26 Mayflower Avenue
    Pennsylvania
    EX4 5DS Exeter
    Devon
    Director
    26 Mayflower Avenue
    Pennsylvania
    EX4 5DS Exeter
    Devon
    EnglandBritishDirector55306290001
    GREGORY, Timothy John
    208 Desborough Avenue
    HP11 2TN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Director
    208 Desborough Avenue
    HP11 2TN High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishSales Director49097280001
    HALLITT, Peter William
    The Mistral Lower Busker Farm
    Busker Lane Scissett
    HD8 9JU Huddersfield
    Director
    The Mistral Lower Busker Farm
    Busker Lane Scissett
    HD8 9JU Huddersfield
    BritishChief Executive Officer100185830001
    HARVEY, Robert William
    88 Macclesfield Road
    Hazel Grove
    SK7 6DT Stockport
    Cheshire
    Director
    88 Macclesfield Road
    Hazel Grove
    SK7 6DT Stockport
    Cheshire
    BritishTechnical Marketing Manager71636190001
    HAUXWELL, Timothy Norbury
    The Shielings Highgrove Gardens
    Edwalton
    NG12 4DF Nottingham
    Director
    The Shielings Highgrove Gardens
    Edwalton
    NG12 4DF Nottingham
    BritishFinance Director70993740001
    HELAS, John Peter
    Stanley House
    Bramble Road
    SN2 8ER Swindon, Wiltshire
    Stanley Security Solutions - Europe Limited
    England And Wales
    United Kingdom
    Director
    Stanley House
    Bramble Road
    SN2 8ER Swindon, Wiltshire
    Stanley Security Solutions - Europe Limited
    England And Wales
    United Kingdom
    EnglandBritishGeneral Manager217758150001
    HERKES, Richard
    10 Adlington Hall Mews
    Adlington
    SK10 4LF Macclesfield
    Cheshire
    Director
    10 Adlington Hall Mews
    Adlington
    SK10 4LF Macclesfield
    Cheshire
    BritishChief Executive Officer75579020003
    HERZOG, Corinne
    15 Avenue Wansart
    FOREIGN Brussels
    1180
    Belgium
    Director
    15 Avenue Wansart
    FOREIGN Brussels
    1180
    Belgium
    BelgiumFrenchLegal Director Europe125644650001
    HEWITT, John Donald Kerr
    16 Coppice Gardens
    RG45 6EE Crowthorne
    Berkshire
    Director
    16 Coppice Gardens
    RG45 6EE Crowthorne
    Berkshire
    BritishChartered Secretary650900001
    KIMBER, Simon Jeremy Michael
    56 Highfield Road
    WA13 0EE Lymm
    Cheshire
    Director
    56 Highfield Road
    WA13 0EE Lymm
    Cheshire
    EnglandBritishManaging Director40542810001
    LEE, Michael John
    7 Rectory Road
    Frampton Cotterell
    BS36 2BN Bristol
    Avon
    Director
    7 Rectory Road
    Frampton Cotterell
    BS36 2BN Bristol
    Avon
    BritishFinance Director7341400002
    LORD, Andrew Stephen
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    270
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    270
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant194669590001
    MACINNES, Colin David
    The Well Cottage
    61 Caps Lane
    OX10 9HQ Cholsey
    Oxfordshire
    Director
    The Well Cottage
    61 Caps Lane
    OX10 9HQ Cholsey
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector & Group Coy Sec7341360001
    MERRIFIELD, Stephanie Irene
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    270
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    270
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishHr Director219947100001
    MURRAY, Vanda
    12 Betchworth Way
    SK10 2PA Tytherington Macclesfield
    Cheshire
    Director
    12 Betchworth Way
    SK10 2PA Tytherington Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritishDirector47527140003
    ORR, Alex
    13 Harwood Drive
    Uxbridge
    UB10 0BG Hillingdon
    Middlesex
    Director
    13 Harwood Drive
    Uxbridge
    UB10 0BG Hillingdon
    Middlesex
    BritishCompany Director75397180001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de PAC INTERNATIONAL LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    270
    Berkshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    270
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro658166
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene PAC INTERNATIONAL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 22 jul 1992
    Entregado el 31 jul 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    See 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank Plcas Agent of and Trustee for the Banks So Defined
    Transacciones
    • 31 jul 1992Registro de un cargo (395)
    • 14 feb 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 22 jul 1992
    Entregado el 31 jul 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the composite guarantee and debenture
    Breve descripción
    Floating charge. Undertaking and all property and assets.
    Personas con derecho
    • Expamet International PLC
    Transacciones
    • 31 jul 1992Registro de un cargo (395)
    • 14 feb 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 30 mar 1983
    Entregado el 07 abr 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and the proceeds of sale therof. Fixed floating charge over the :- undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 07 abr 1983Registro de una carga
    • 21 jul 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0