PAC INTERNATIONAL LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | PAC INTERNATIONAL LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01363776 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PAC INTERNATIONAL LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra PAC INTERNATIONAL LIMITED?
Dirección de la sede social | C/O Stanley Black & Decker Hellaby Lane Hellaby S66 8HN Rotherham South Yorkshire United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PAC INTERNATIONAL LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
SOFTWARE CONTROL LIMITED | 19 ene 1983 | 19 ene 1983 |
ASSYDES LIMITED | 19 abr 1978 | 19 abr 1978 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PAC INTERNATIONAL LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PAC INTERNATIONAL LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 29 jun 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 13 jul 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 29 jun 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PAC INTERNATIONAL LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Cambio de datos del director Mr Amit Kumar Sood el 09 may 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Steven John Costello el 09 may 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del secretario Steven John Costello el 09 may 2025 | 1 páginas | CH03 | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023 | 3 páginas | AA | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 270 Bath Road Slough Berkshire SL1 4DX United Kingdom a C/O Stanley Black & Decker Hellaby Lane Hellaby Rotherham South Yorkshire S66 8HN el 17 jun 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Cambio de datos del director Mr Amit Kumar Sood el 22 may 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 3 páginas | AA | ||
Cambio de datos del secretario Steven John Costello el 22 jul 2022 | 1 páginas | CH03 | ||
Nombramiento de Mr Amit Kumar Sood como director el 15 jul 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Mark Richard Smiley como director el 15 jul 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Steven John Costello como director el 15 jul 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Andrew Stephen Lord como director el 15 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Stephanie Irene Merrifield como director el 01 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Ms Stephanie Irene Merrifield el 19 nov 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Andrew Stephen Lord el 19 nov 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Modification des détails de Stanley Security Solutions Operations Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 nov 2021 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Stanley House Bramble Road Swindon Wilts SN2 8ER a 270 Bath Road Slough Berkshire SL1 4DX el 19 nov 2021 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de PAC INTERNATIONAL LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSTELLO, Steven John | Secretario | Hellaby Lane Hellaby S66 8HN Rotherham C/O Stanley Black & Decker South Yorkshire United Kingdom | 186094530001 | |||||||
COSTELLO, Steven John | Director | Hellaby Lane Hellaby S66 8HN Rotherham C/O Stanley Black & Decker South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 217824350001 | ||||
SMILEY, Mark Richard | Director | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 3 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | General Manager Uk & Roi | 194271890001 | ||||
SOOD, Amit Kumar | Director | Hellaby Lane Hellaby S66 8HN Rotherham C/O Stanley Black & Decker South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 195541990002 | ||||
COLLINS, Richard Hawke | Secretario | 5 Halland Road GL53 0DJ Cheltenham Gloucestershire | British | 53398040001 | ||||||
HAYHURST, Fred | Secretario | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 3 S Yorkshire United Kingdom | British | 149706500001 | ||||||
HENDERSON, Alex | Secretario | 8 Pulteney Avenue BA2 4HH Bath | British | 81352070001 | ||||||
MACINNES, Colin David | Secretario | The Well Cottage 61 Caps Lane OX10 9HQ Cholsey Oxfordshire | British | 7341360001 | ||||||
TAYLOR, Christine | Secretario | 7 Fatherford Close Diggle Saddleworth OL3 5PY Oldham | British | Company Secretary | 35658270001 | |||||
WHITTAM, Karen Anne | Secretario | 19 Seven Stiles Drive Marple SK6 6LT Stockport Cheshire | British | 29646020001 | ||||||
BERTENSHAW, Philip | Director | 98 Glossop Road Marple Bridge SK6 5EL Stockport Cheshire | British | Corporate Executive | 83849370001 | |||||
BEST, Richard John | Director | 2/R 3 Holmbank Avenue Shawlands G41 3JQ Glasgow Strathclyde Scotland | British | Director | 61334520001 | |||||
BEWICK, Stephen Alfred | Director | Peace Cottage St Marys Way, Brownshill GL6 8SW Stroud Glos | England | British | Sales & Marketing | 122982330001 | ||||
BOUSTEAD, Roger | Director | 3 Cressingham Road Stretford M32 9DN Manchester | British | Operations Director | 75578870001 | |||||
COGZELL, Matthew James | Director | Stanley House Bramble Road SN2 8ER Swindon Wilts | England | British | Hr Director | 157755080001 | ||||
COOKE, Dean Christopher | Director | 14 Erleigh Drive SN15 2NQ Chippenham | United Kingdom | British | Accountant | 85254310002 | ||||
COWLEY, John Mitchell | Director | Stanley House Bramble Road SN2 8ER Swindon Wilts | England | British | Director | 153045530001 | ||||
FENNA, David Geoffrey | Director | 119 New Hall Lane Heaton BL1 5HQ Bolton | British | Director | 43266490002 | |||||
GINNEVER, Bruce Quentin | Director | The Forge GL7 5JS Meysey Hampton Cirencester | United Kingdom | British | Director | 19214470003 | ||||
GLOSTER, Michael George | Director | 26 Mayflower Avenue Pennsylvania EX4 5DS Exeter Devon | England | British | Director | 55306290001 | ||||
GREGORY, Timothy John | Director | 208 Desborough Avenue HP11 2TN High Wycombe Buckinghamshire | United Kingdom | British | Sales Director | 49097280001 | ||||
HALLITT, Peter William | Director | The Mistral Lower Busker Farm Busker Lane Scissett HD8 9JU Huddersfield | British | Chief Executive Officer | 100185830001 | |||||
HARVEY, Robert William | Director | 88 Macclesfield Road Hazel Grove SK7 6DT Stockport Cheshire | British | Technical Marketing Manager | 71636190001 | |||||
HAUXWELL, Timothy Norbury | Director | The Shielings Highgrove Gardens Edwalton NG12 4DF Nottingham | British | Finance Director | 70993740001 | |||||
HELAS, John Peter | Director | Stanley House Bramble Road SN2 8ER Swindon, Wiltshire Stanley Security Solutions - Europe Limited England And Wales United Kingdom | England | British | General Manager | 217758150001 | ||||
HERKES, Richard | Director | 10 Adlington Hall Mews Adlington SK10 4LF Macclesfield Cheshire | British | Chief Executive Officer | 75579020003 | |||||
HERZOG, Corinne | Director | 15 Avenue Wansart FOREIGN Brussels 1180 Belgium | Belgium | French | Legal Director Europe | 125644650001 | ||||
HEWITT, John Donald Kerr | Director | 16 Coppice Gardens RG45 6EE Crowthorne Berkshire | British | Chartered Secretary | 650900001 | |||||
KIMBER, Simon Jeremy Michael | Director | 56 Highfield Road WA13 0EE Lymm Cheshire | England | British | Managing Director | 40542810001 | ||||
LEE, Michael John | Director | 7 Rectory Road Frampton Cotterell BS36 2BN Bristol Avon | British | Finance Director | 7341400002 | |||||
LORD, Andrew Stephen | Director | Bath Road SL1 4DX Slough 270 Berkshire United Kingdom | England | British | Accountant | 194669590001 | ||||
MACINNES, Colin David | Director | The Well Cottage 61 Caps Lane OX10 9HQ Cholsey Oxfordshire | United Kingdom | British | Director & Group Coy Sec | 7341360001 | ||||
MERRIFIELD, Stephanie Irene | Director | Bath Road SL1 4DX Slough 270 Berkshire United Kingdom | England | British | Hr Director | 219947100001 | ||||
MURRAY, Vanda | Director | 12 Betchworth Way SK10 2PA Tytherington Macclesfield Cheshire | England | British | Director | 47527140003 | ||||
ORR, Alex | Director | 13 Harwood Drive Uxbridge UB10 0BG Hillingdon Middlesex | British | Company Director | 75397180001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PAC INTERNATIONAL LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanley Security Solutions Operations Limited | 06 abr 2016 | Bath Road SL1 4DX Slough 270 Berkshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene PAC INTERNATIONAL LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and debenture | Creado el 22 jul 1992 Entregado el 31 jul 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción See 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creado el 22 jul 1992 Entregado el 31 jul 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the composite guarantee and debenture | |
Breve descripción Floating charge. Undertaking and all property and assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 30 mar 1983 Entregado el 07 abr 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and the proceeds of sale therof. Fixed floating charge over the :- undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0