SG LEASING (UTILITIES) LIMITED

SG LEASING (UTILITIES) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSG LEASING (UTILITIES) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01364426
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?

    • Arrendamiento financiero (64910) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Interpath Ltd
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BMI (NO.3) LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    DANNYWELANT LIMITED21 abr 197821 abr 1978

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 jun 2022

    7 páginasLIQ03

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    7 páginasLIQ13

    Destitución del liquidador por orden judicial

    104 páginasLIQ10

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Domicilio social registrado cambiado de 10 Fleet Place London EC4M 7QS a C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place London EC4M 7RB el 04 jul 2022

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de 15 Canada Square London E14 5GL a 10 Fleet Place London EC4M 7QS el 14 dic 2021

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de One Bank Street Canary Wharf London E14 4SG England a 15 Canada Square London E14 5GL el 14 jul 2021

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 28 jun 2021

    LRESSP

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Cese del nombramiento de Lindsay Ginnette Sides como director el 04 jun 2021

    1 páginasTM01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG United Kingdom a C/O Group Legal One Bank Street London E14 4SG

    1 páginasAD02

    Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2019 au 30 jun 2020

    1 páginasAA01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG a One Bank Street Canary Wharf London E14 4SG el 18 nov 2019

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    30 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Paul Shields como director el 20 may 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Stuart Donald Cook como director el 05 abr 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    27 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Stephen Lethbridge Fowler el 20 sept 2018

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr. Paul Shields como director el 19 mar 2018

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BALINSKA-JUNDZILL, Catherine
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    Secretario
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    191477830001
    DENT, Nicholas Michael
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    Director
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    United KingdomBritish43922780002
    FOWLER, Stephen Lethbridge
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    Director
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    EnglandBritish135237620002
    RUFFELL, Lara Catherine
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    Secretario
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    British69140140002
    SHOOLBRED, Charles Frederick
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    Secretario
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    British540290002
    BARCOSEC LIMITED
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Secretario corporativo
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    49004930002
    AKRAM, Mohammed
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish169142800001
    BOOBYER, Christopher Leslie Richard
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Director
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    British92233050001
    BOX, Sarah
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    Director
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    British47381630004
    CALLENDER, John Dalrymple
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    Director
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    United KingdomBritish2444200001
    CLARK, Thomas Martin
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    Director
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    British5529800001
    COOK, Stuart Donald
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    Director
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    United KingdomBritish191477240004
    DOWDING, Eric Robert
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    Director
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    British46728970001
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Director
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritish113760650001
    EVANS, Christopher Hewitt
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British121774150001
    HARE, Darren Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish127470250001
    HUCKLE, Jonathan Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish163223760001
    LEATHER, Jonathan Terence
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish69140360004
    LEWIS, Barry Randall
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    Director
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish145163830001
    MACINTOSH, Gordon Paterson
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    Director
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    British25737780001
    MCMILLAN, Richard John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British68601920003
    MILES, Martin Graham
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish108439150001
    MILLINER, Craig
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    Director
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    British144700710001
    NIMMO, Mark Alexander
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    Director
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    EnglandBritish33420600001
    RIDOUT, Thomas Geoffrey
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish155056490001
    ROSE, Stephen George
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British143870380001
    ROWAN, Charles Paul
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    Director
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    British49237910001
    ROWBERRY, Duncan John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish49237880004
    SHIELDS, Paul
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    Director
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    EnglandBritish244361960001
    SIDES, Lindsay Ginnette
    Canary Wharf
    E14 4SG London
    One Bank Street
    England
    Director
    Canary Wharf
    E14 4SG London
    One Bank Street
    England
    EnglandBritish212141970001
    SILCOCK, Frank Avis
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    Director
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    British32895910001
    SIMPSON, Gavin John
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish149333050001
    WATSON, Hazel Anne Marie
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandIrish122291210001
    WEAL, Barry
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    Director
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    British40203100001
    WEAVING, John Martin
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    Director
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    British58523120001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Société Générale
    Boulevard Haussmann
    75009 Paris
    29
    France
    06 abr 2016
    Boulevard Haussmann
    75009 Paris
    29
    France
    No
    Forma jurídicaSociété Anonyme (French Public Limited Company)
    País de registroFrance
    Autoridad legalFrench Monetary And Financial Code And French Commercial Code
    Lugar de registroRegistre Du Commerce Et Des Sociétés - Greffe Du Tribunal De Commerce De Paris (Infogreffe - Les Greffes Des Tribunaux De Commerce)
    Número de registro552 120 222 00013 (Trade Register: 552 120 222 R.C.S. Paris)
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene SG LEASING (UTILITIES) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Secondary lease security assignment
    Creado el 30 dic 1992
    Entregado el 14 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due from i/s scantrack and/or ole soeberg to the chargee under the terms of the loan agreement dated 30.12.92
    Breve descripción
    All rights,title and interest in the agreements and all sums payable...............see form 395.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 14 ene 1993Registro de un cargo (395)
    • 15 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Sub-lessee security agreement
    Creado el 30 dic 1992
    Entregado el 14 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The performance of certain covenants due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sublease and the head lease both dated 24.11.92
    Breve descripción
    All rights,title and interest under the agreements......all proceeds receivable.....see form 395.
    Personas con derecho
    • Triborough Bridge and Tunnel Authority
    Transacciones
    • 14 ene 1993Registro de un cargo (395)
    • 15 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    First priority statutory mortgage
    Creado el 18 dic 1986
    Entregado el 07 ene 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a financial agreement dated 11.10.85 as amended by a supplemental financial agreement and a deed of covenant both dated 18.12.86
    Breve descripción
    64/64TH shares of and in the motor vessel "arco avon" registered in the name of the company at the port of southampton. Under official no 711642.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ene 1987Registro de una carga
    • 18 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of covenant
    Creado el 18 dic 1986
    Entregado el 07 ene 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £5,800,000 all monies due or to become due from the company to the chargee secured by a charge dated 18.12.86 and all other monies due or to become due under the terms of a financial agreement dated 11.10.85 as amended by a supplemental financial agreement dated 18.12.86 and this deed
    Breve descripción
    The motor vessel "arco avon" registered at the port of southampton under official no 711642 including any share of interest therein and her engines machinery boats tackle outfit share gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board ar ashore (the "ship") all the companys joint on other interests in and all benefits of policies and contracts of insurance (please see doc for full details).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ene 1987Registro de una carga
    • 18 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Financial agreement
    Creado el 11 oct 1985
    Entregado el 14 oct 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £5,800,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a building contract dated 31 may '85 and novation agreement dated 11 oct 1985
    Breve descripción
    All the company's beneficial interest and all its rights and titles in the contract including the vessel and all moneys payable (see doc M37 for full details).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 14 oct 1985Registro de una carga
    • 18 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Shipowners agreement
    Creado el 01 oct 1985
    Entregado el 14 oct 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a shipowners agreement
    Breve descripción
    Any moneys payable to the company in accordance with the terms of clause 9(b) or 15(b) of the financial agreement dated 11.10.85 (for full details see doc M36).
    Personas con derecho
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transacciones
    • 14 oct 1985Registro de una carga
    • 18 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of covenant
    Creado el 18 mar 1985
    Entregado el 03 abr 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from ugland brothers limited to the chargee secured by a mortgage 18.3.85 under the terms of a guarantee facility agreement 18.3.85
    Breve descripción
    All the companys interest in M.v "itm installer" see doc for fuller details.
    Personas con derecho
    • Bank of America National Trust & Savings Association
    Transacciones
    • 03 abr 1985Registro de una carga
    • 18 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    First priority statutory mortgage
    Creado el 18 mar 1985
    Entregado el 03 abr 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from ugland brothers limited to the chargee on an account current under the terms of a deed of covenant 18.3.85 and pursuant to a guarantee facility agreement 18.3.85
    Breve descripción
    64/64TH shares in M.V. "itm installer" registered number 703418 together with her boats and appurtenances.
    Personas con derecho
    • Bank of America National Trust & Savings Association
    Transacciones
    • 03 abr 1985Registro de una carga
    • 18 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Assignment
    Creado el 28 feb 1985
    Entregado el 12 mar 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on behalf of the banks under clause 3.01 of the interim boeing counter indemnity agreement dated 28 february 1985
    Breve descripción
    All the company's right title, interest and benefits in and to all moneys that may be or become payable by the boeing company to the company under articles 2.1(d) and 5.4 of part b of the purchase agreement dated 28.2.85 between the boeing company, british airways PLC and the company.
    Personas con derecho
    • Chemical Bank.
    Transacciones
    • 12 mar 1985Registro de una carga
    • 18 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene SG LEASING (UTILITIES) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    28 jun 2021Inicio de la liquidación
    21 oct 2022Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    David John Pike
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Profesional
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0