ANKER SYSTEMS

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaANKER SYSTEMS
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa 01365105
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ANKER SYSTEMS?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra ANKER SYSTEMS?

    Dirección de la sede social
    Oracle Parkway
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ANKER SYSTEMS?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ANKER SYSTEMS LIMITED31 mar 200031 mar 2000
    RIVA SYSTEMS LIMITED26 sept 198826 sept 1988
    RIVA TURNKEY COMPUTER SYSTEMS LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    BENCHWORLD LIMITED25 abr 197825 abr 1978

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ANKER SYSTEMS?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ANKER SYSTEMS?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2016

    11 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Re-registration 22/12/2016
    RES13

    Certificado de re-registro de Limitado a Ilimitado

    1 páginasCERT3

    Aprobación de re-registro

    1 páginasFOA-RR

    Re-registro del Memorándum y Estatutos

    38 páginasMAR

    Re-registro de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad privada de responsabilidad ilimitada

    1 páginasRR05

    Declaración de confirmación presentada el 05 dic 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2015

    22 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 dic 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 dic 2015

    Estado de capital el 07 dic 2015

    • Capital: GBP 500,001
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2014

    25 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 dic 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 ene 2015

    Estado de capital el 02 ene 2015

    • Capital: GBP 500,001
    SH01

    Cese del nombramiento de Stephen Walder como director el 26 nov 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Cynthia Russo como director el 26 nov 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Frank Peter Ward como director el 26 nov 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Stephen Walder como secretario el 26 nov 2014

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Kaweh Niroomand como director el 26 nov 2014

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Oracle Corporation Nominees Limited como director el 26 nov 2014

    2 páginasAP02

    Nombramiento de Mr David James Hudson como director el 26 nov 2014

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de 6-8 the Grove Slough Berkshire SL1 1QP a Oracle Parkway Thames Valley Park Reading Berkshire RG6 1RA el 01 dic 2014

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2013

    25 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 ene 2014

    Estado de capital el 02 ene 2014

    • Capital: GBP 500,001
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2012

    25 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de ANKER SYSTEMS?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HUDSON, David James
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    Director
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    EnglandBritish100987010002
    ORACLE CORPORATION NOMINEES LIMITED
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    Director corporativo
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro03062158
    118326710001
    ALEXANDER, Neil Brough
    Brook House Osbaston
    SY10 8HT Oswestry
    Shropshire
    Secretario
    Brook House Osbaston
    SY10 8HT Oswestry
    Shropshire
    British3699700001
    COOKSLEY, Graeme Roy
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    Secretario
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    New Zealander126903810001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    Secretario
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    British109926660001
    ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr.
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Secretario
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Other123425810001
    ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr.
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Secretario
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Other123425810001
    JOHNSON, Robin Simon
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    Secretario
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    British11498320001
    JONES, Stephen Philip
    11 Pownall Avenue
    Bramhall
    SK7 2HE Stockport
    Cheshire
    Secretario
    11 Pownall Avenue
    Bramhall
    SK7 2HE Stockport
    Cheshire
    British39173700002
    LEEK, Marcus
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    Secretario
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    British115960470001
    WALDER, Stephen
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    Secretario
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    British169959800001
    ABDO, Ashley
    63 West Ranch Trail
    CO80465 Morrison
    Colorado
    Usa
    Director
    63 West Ranch Trail
    CO80465 Morrison
    Colorado
    Usa
    American90157130001
    ALEXANDER, Neil Brough
    Brook House Osbaston
    SY10 8HT Oswestry
    Shropshire
    Director
    Brook House Osbaston
    SY10 8HT Oswestry
    Shropshire
    British3699700001
    APPLETON, Colin Arthur
    15 The Coppice
    Cuddington
    CW8 2XF Northwich
    Cheshire
    Director
    15 The Coppice
    Cuddington
    CW8 2XF Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish19964370001
    BAILEY, James R
    1000 Rock Ridge Lane
    Loveland
    Colorado
    80537
    Usa
    Director
    1000 Rock Ridge Lane
    Loveland
    Colorado
    80537
    Usa
    American69700010001
    BAKER, Jeremy David
    16 Bonville Chase
    WA14 4QA Altrincham
    Cheshire
    Director
    16 Bonville Chase
    WA14 4QA Altrincham
    Cheshire
    British51244270001
    BUTCHER, Steve John
    Lower Laithe Cottage
    Providence Lane, Oakworth
    BD22 7QS Keighley
    West Yorkshire
    Director
    Lower Laithe Cottage
    Providence Lane, Oakworth
    BD22 7QS Keighley
    West Yorkshire
    United KingdomBritish203318870001
    CALLAGHAN, Stephen James
    The Grove
    SL1 1QP Slough
    6-8
    Berkshire
    Director
    The Grove
    SL1 1QP Slough
    6-8
    Berkshire
    EnglandBritish87418990003
    COOKSLEY, Graeme Roy
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    Director
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    New Zealander126903810001
    COOKSLEY, Graeme
    19 Charmer Fussweg
    Zug
    6300
    Switzerland
    Director
    19 Charmer Fussweg
    Zug
    6300
    Switzerland
    New Zealander122786180001
    DOBIE, Timothy Arthur Ross
    1 St Andrews Road
    Brockhall Village Old Langho
    BB6 8BP Blackburn
    Lancashire
    Director
    1 St Andrews Road
    Brockhall Village Old Langho
    BB6 8BP Blackburn
    Lancashire
    EnglandBritish97704830001
    DOBSON, Melvyn John
    42 Ravens Wood
    Chorley New Road Heaton
    BL1 5TL Bolton
    Director
    42 Ravens Wood
    Chorley New Road Heaton
    BL1 5TL Bolton
    British45852970001
    DURKIN, Ivan Paul
    11 Stapleford Close
    BL8 2UG Bury
    Lancashire
    Director
    11 Stapleford Close
    BL8 2UG Bury
    Lancashire
    British51244360001
    EARHART, Stephen
    Brittens Lane
    Salford
    MK17 8BE Milton Keynes
    1
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Brittens Lane
    Salford
    MK17 8BE Milton Keynes
    1
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United States133153450001
    FOULKES, John Harold
    Cank Farmhouse
    Welford Road
    NN6 8AH Chapel Brampton
    Northamptonshire
    Director
    Cank Farmhouse
    Welford Road
    NN6 8AH Chapel Brampton
    Northamptonshire
    British1657980007
    GILDART, Steven
    12 Ennerdale Road
    Astley Tyldesley
    M29 7AR Manchester
    Director
    12 Ennerdale Road
    Astley Tyldesley
    M29 7AR Manchester
    British51244420001
    GILES, Peter Hardwick
    Arden House Lamb Lane
    Ashley
    WA14 3QG Altrincham
    Cheshire
    Director
    Arden House Lamb Lane
    Ashley
    WA14 3QG Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish35521860001
    GRADDEN, Amanda Jane
    Flat 2 10a Market Mews
    W1J 7BZ London
    Director
    Flat 2 10a Market Mews
    W1J 7BZ London
    EnglandBritish77425910003
    GREENOUGH, Michael
    711 Pintail Court
    Granbury
    Texas 76049
    Usa
    Director
    711 Pintail Court
    Granbury
    Texas 76049
    Usa
    Canadian123427350001
    HAYES, Laurence
    15 Heald Cottages
    Judith Street Lowerfold
    OL12 7HS Rochdale
    Lancashire
    Director
    15 Heald Cottages
    Judith Street Lowerfold
    OL12 7HS Rochdale
    Lancashire
    British51244430001
    HIRANO, Michael
    139 Eagle Canyon Circle
    PO BOX 1925
    CO80540 Lyons
    Colorado
    Usa
    Director
    139 Eagle Canyon Circle
    PO BOX 1925
    CO80540 Lyons
    Colorado
    Usa
    American90157180001
    HOLLENBECK, David Arthur
    5166 Buckingham Road
    CO80301 Boulder
    Colorado
    Usa
    Director
    5166 Buckingham Road
    CO80301 Boulder
    Colorado
    Usa
    American90157320001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    Director
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    British109926660001
    ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr.
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Director
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    UsaOther123425810001
    JONES, Stephen Philip
    11 Pownall Avenue
    Bramhall
    SK7 2HE Stockport
    Cheshire
    Director
    11 Pownall Avenue
    Bramhall
    SK7 2HE Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish39173700002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ANKER SYSTEMS?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    06 abr 2016
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom (England And Wales)
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro6273940
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene ANKER SYSTEMS alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 21 oct 2009
    Entregado el 02 nov 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Burdale Financial Limited
    Transacciones
    • 02 nov 2009Registro de un cargo (MG01)
    • 12 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture (the "agreement")
    Creado el 28 ene 2000
    Entregado el 09 feb 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the finance documents (including the agreement)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Commerzbank Ag London Branchas Trustee for the Beneficiaries (As Defined Inschedule 1)
    Transacciones
    • 09 feb 2000Registro de un cargo (395)
    • 08 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 18 ago 1999
    Entregado el 24 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 24 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 08 feb 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of adherence
    Creado el 12 may 1992
    Entregado el 14 may 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility letter DATED13TH april 1992 the composite debenture dated 26TH april 1990 and any other security documents (as defined)
    Breve descripción
    The charged assets as defined in the original charge see form 395 ref M563C.
    Personas con derecho
    • Fbg Holdings (UK) Limitedpreviously Elders Ixl Holdings (UK) Limited
    Transacciones
    • 14 may 1992Registro de un cargo (395)
    • 06 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Second supplemental deed
    Creado el 12 may 1992
    Entregado el 14 may 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility letter DATED13 april 1992 the composite debenture dated 26 april 1990 or any other security document (as defined)
    Breve descripción
    The charges and assignments contained inclause 2 of the original debenture DATED26 april 1990.
    Personas con derecho
    • Fbg Holdings (UK) Limitedpreviously Elders Ixl Holdings (UK) Limited
    Transacciones
    • 14 may 1992Registro de un cargo (395)
    • 06 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental deed
    Creado el 13 abr 1992
    Entregado el 30 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from theriva group PLC and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the finance documents as defined
    Breve descripción
    See form 395 ref M90. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank Plcmilneas Agent and Trustee for Itself the Banks and Mr
    Transacciones
    • 30 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 08 feb 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental deed
    Creado el 12 ago 1991
    Entregado el 20 ago 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility to the dated 23RD april 1990 and any other security document (as defined)
    Breve descripción
    (See form 395- ref M135 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Fbg Holdings (U.K.) Limited
    Transacciones
    • 20 ago 1991Registro de una carga
    • 06 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creado el 13 may 1991
    Entregado el 29 may 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from riva group PLC to the chargee under each of the finance documents as defined
    Breve descripción
    (See doc M148 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC.
    Transacciones
    • 29 may 1991Registro de una carga
    • 08 feb 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantees & mortgage debenture
    Creado el 26 abr 1990
    Entregado el 08 may 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter and this charge and any other security document
    Breve descripción
    (See doc M228 for full details). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • Elders Ixl Holdings (UK) Limited
    Transacciones
    • 08 may 1990Registro de una carga
    • 06 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 09 nov 1989
    Entregado el 30 nov 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from hugin sweda group (as defined) under the terms of each of the finance documents and/or the swedish loan agreements as defined to the chargee.
    Breve descripción
    All dividends paid or payable after the date of the debenture and all or any of the shares and all stocks, shares, securities (and the dividends or interest thereon) rights, money or property. (See form m 395 ref m 849C for full details).
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank Plcined)(As Agent for and on Behalf of the Banks, as Def
    Transacciones
    • 30 nov 1989Registro de una carga
    • 08 feb 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 11 sept 1987
    Entregado el 22 sept 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £133,000.00 and all other monies due or to become due from the and alistair scott petrie and barbara ann petrie company to the chargee
    Breve descripción
    1, the farthings, marcham abingdon, oxfordshire. T/n:- on 60470. and all fixtures thereon and additions thereto.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 22 sept 1987Registro de una carga
    • 25 ago 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 ene 1982
    Entregado el 04 feb 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed amd floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital. With all buildings, fixtures, fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 1982Registro de una carga
    • 25 ago 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 20 jun 1980
    Entregado el 24 jun 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. And all fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 24 jun 1980Registro de una carga
    • 25 ago 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0