NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED

NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01370566
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED?

    • (2524) /

    ¿Dónde se encuentra NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Brooks House
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Warwickshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SWISH BUILDING PRODUCTS LIMITED 05 mar 199805 mar 1998
    BREVILLE EUROPE LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    DROWLEN LIMITED25 may 197825 may 1978

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 sept 2013

    6 páginas4.68

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    5 páginas4.71

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 27 sept 2012

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Cese del nombramiento de Adrian Egerton Darling como director el 31 may 2012

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Jan-Feie Zwiers como director el 31 may 2012

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Robert Leslie Nash como director el 26 mar 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Mcfaull como director el 26 mar 2012

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Paul Thomas Moss como director el 26 mar 2012

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 oct 2011

    Estado de capital el 27 oct 2011

    • Capital: GBP 25,866,666.7
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    1 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    1 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del director John Mcfaull el 28 sept 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Robert Leslie Nash el 28 sept 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Adrian Egerton Darling el 28 sept 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Karen Roberts el 27 sept 2010

    2 páginasCH03

    Domicilio social registrado cambiado de 16 Stanier Way Wyvern Business Park Derby Derbyshire DE21 6BF England el 27 sept 2010

    1 páginasAD01

    Cambio de datos del director Robert Leslie Nash el 13 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Adrian Egerton Darling el 13 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director John Mcfaull el 13 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Karen Roberts el 13 ene 2010

    1 páginasCH03

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008

    1 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ROBERTS, Karen Dawn
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Secretario
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    British126457090001
    MOSS, Paul Thomas
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    Director
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    EnglandBritish167898270001
    ZWIERS, Jan-Feie
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    England
    Director
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    England
    NetherlandsDutch169623550001
    BOND, Sarah Caroline
    Hillside
    37 Rise End, Middleton
    DE4 4LS Wirksworth
    Derbyshire
    Secretario
    Hillside
    37 Rise End, Middleton
    DE4 4LS Wirksworth
    Derbyshire
    British90181180006
    CHAPMAN, Christopher John
    5 The Willows
    Walmley
    B76 2PX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secretario
    5 The Willows
    Walmley
    B76 2PX Sutton Coldfield
    West Midlands
    British50769680003
    LOWE, Tracey
    149 Smalley Drive
    Oakwood
    DE21 2SQ Derby
    Derbyshire
    Secretario
    149 Smalley Drive
    Oakwood
    DE21 2SQ Derby
    Derbyshire
    British86697030001
    PERKINS, Michael William
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    Secretario
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    British30958650001
    STRATTON, Malcolm
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    Secretario
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    British30601260018
    STRATTON, Malcolm
    White Rose Grange Hollington Road
    Stubwood
    ST14 5HY Uttoxeter
    Staffordshire
    Secretario
    White Rose Grange Hollington Road
    Stubwood
    ST14 5HY Uttoxeter
    Staffordshire
    British30601260002
    DARLING, Adrian Egerton
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Director
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish13813980005
    DAVIES, Michael Thomas
    Dadlington House Farm
    Shenton Lane
    CV13 6JD Dadlington
    Warwickshire
    Director
    Dadlington House Farm
    Shenton Lane
    CV13 6JD Dadlington
    Warwickshire
    British50770000002
    EDWARDS, Mark John
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    Director
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    United KingdomBritish56562210001
    GODDARD, David Peter
    The Hollies
    Ivy House Lane
    HP4 2PP Berkhamsted
    Hertfordshire
    Director
    The Hollies
    Ivy House Lane
    HP4 2PP Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish8828350002
    HANRAHAN, Shaun Patrick
    19 Wollaton Vale
    Wollaton
    NG8 2PD Nottingham
    Director
    19 Wollaton Vale
    Wollaton
    NG8 2PD Nottingham
    British49298590002
    MCFAULL, John
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    Director
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    British83628430003
    NASH, Robert Leslie
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Director
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish83397580001
    PURCHASE, Roger
    8 Moorfield Avenue
    Knowle
    B93 9RE Solihull
    West Midlands
    Director
    8 Moorfield Avenue
    Knowle
    B93 9RE Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish49298600001
    SIMPSON, Kenneth
    Copton Ash Cottage
    Sheepy Road, Twycross
    CV9 3PG Atherstone
    Warwickshire
    Director
    Copton Ash Cottage
    Sheepy Road, Twycross
    CV9 3PG Atherstone
    Warwickshire
    British27376570002
    STRATTON, Malcolm
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    Director
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    British30601260018
    NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Director corporativo
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363930002
    NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Director corporativo
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363930002
    NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Director corporativo
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363780002
    NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Director corporativo
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363780002
    WESTMINSTER SECURITIES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Director corporativo
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    33480800001
    WILLIAMS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Director corporativo
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    6125640001

    ¿Tiene NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee and debenture made between the company and the royal bank of scotland PLC as agent and trustee for the secured parties (as defined) pursuant to the intercreditor agreement (as defined)
    Creado el 05 dic 2000
    Entregado el 12 dic 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) including the guarantee and debenture
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 12 dic 2000Registro de un cargo (395)
    • 25 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creado el 27 feb 1998
    Entregado el 16 mar 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the finance parties (as therein defined) (or any of them) under each or any of the finance documents (as therein defined) on any account whatsoever provided that no obligation or liability shall be included in the definition of "secured liabilities" to the extent that, if it were included, supplemental debenture or the debenture (or any part thereof) would constitute unlawful financial assistance within the meaning of sections 151 and 152 of the companies act 1985
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Morgan Grenfell & Co Limited
    Transacciones
    • 16 mar 1998Registro de un cargo (395)
    • 06 dic 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Accession agreement relating to a debenture dated 4/12/96
    Creado el 31 dic 1996
    Entregado el 09 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each chargor (as defined) to the finance parties or any of them under each or any of the finance documents (as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Morgan Grenfell & Co. Limited,as Agent for the Chargors
    Transacciones
    • 09 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 06 dic 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    21 ene 2014Fecha de disolución
    27 sept 2012Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Profesional
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0