QBE RE (EUROPE) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | QBE RE (EUROPE) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Convertida/Cerrada |
| Forma jurídica | Convertida o cerrada |
| Número de empresa | 01378853 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de QBE RE (EUROPE) LIMITED?
- Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra QBE RE (EUROPE) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de QBE RE (EUROPE) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| QBE REINSURANCE (UK) LIMITED | 15 nov 1996 | 15 nov 1996 |
| ALLSTATE REINSURANCE CO. LIMITED | 23 nov 1982 | 23 nov 1982 |
| ALLSTATE REINSURANCE CO. (U.K.) LIMITED | 17 jul 1978 | 17 jul 1978 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de QBE RE (EUROPE) LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 dic 2018 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2019 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para QBE RE (EUROPE) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misceláneos Confirmation of transfer of assets and liabilities | 1 páginas | MISC | ||||||||||
Misceláneos Notification from overseas registry of completion of merger | 1 páginas | MISC | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jonathan Wyn Parry como director el 31 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Wai-Fong Au como director el 31 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stuart William Sinclair como director el 31 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Misceláneos CB01 - cross border merger notice | 42 páginas | MISC | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Malcolm Graham Mccaig el 27 abr 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Malcolm Graham Mccaig el 27 abr 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 49 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 46 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 jun 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Notification de Qbe Holdings (Eo) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Nombramiento de Alexandra Jane Smith como secretario el 26 jun 2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Esther Felton Smith como secretario el 26 jun 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Nigel Joseph Douty Terry como director el 19 dic 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Philip Andrew Dodridge como director el 19 dic 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Malcolm Graham Mccaig el 19 jul 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 29 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 45 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 jun 2015 avec liste complète des actionnaires | 9 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Joe Gordon como director el 29 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Dominic John Clayden como director el 29 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jan Leflot como director el 29 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian David Beckerson como director el 29 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de QBE RE (EUROPE) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITH, Alexandra Jane | Secretario | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | 234579550001 | |||||||
| INGRAM, Timothy Charles William | Director | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | United Kingdom | British | 213011270001 | |||||
| MCCAIG, Malcolm Graham | Director | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | England | British | 141026580004 | |||||
| PRYCE, Richard Vaughan | Director | 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London Plantation Place United Kingdom | United Kingdom | British | 67199680002 | |||||
| TERRY, Nigel Joseph Douty | Director | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | United Kingdom | British | 220136600001 | |||||
| WINKETT, David James | Director | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | United Kingdom | British | 73175560004 | |||||
| BOLAND, Sharon Maria | Secretario | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | British | 60727940002 | ||||||
| DONOVAN, Peter William | Secretario | 6 Oldfield Close BR1 2LL Bromley Kent | British | 56232250001 | ||||||
| FELTON SMITH, Esther | Secretario | 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London Plantation Place United Kingdom | 199284840001 | |||||||
| GREENHALGH, Mary Denise | Secretario | 61 Alexandra Road TW9 2BT Kew Surrey | British | 42172510001 | ||||||
| MACGREGOR, Richard James | Secretario | 14 Cheyne Avenue South Woodford E18 2DR London | British | 83245460001 | ||||||
| PALLOT, Hugh Glen | Secretario | 143 Gresham Road TW18 2AG Staines Middlesex | British | 14485660002 | ||||||
| WILLIAMS, Adrian Charles Harold | Secretario | The Upper Flat 94 Offord Road N1 1PF London | British | 103327620002 | ||||||
| ANGST, Kurt | Director | Lussirainstrasse 55 FOREIGN 6300 Zug Switzerland | Swiss | 13680770001 | ||||||
| AU, Wai-Fong | Director | 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London Plantation Place United Kingdom | England | British | 124364220001 | |||||
| BECKERSON, Ian David | Director | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | United Kingdom | British | 73004250005 | |||||
| BOGHE, Luc | Director | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | Belgium | Belgian | 172508490001 | |||||
| BOWER, Martin Andrew | Director | 33 Burns Avenue SS13 3AG Basildon Essex | British | 23307030001 | ||||||
| BURNS, Steven Paul | Director | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | United Kingdom | British | 18761850004 | |||||
| CALLAHAN, John Donald | Director | No 2 The Landmark FOREIGN Northfield Illinois 60093 Usa | Usa By Birth | 13680780001 | ||||||
| CLAYDEN, Dominic John | Director | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | England | British | 183858000002 | |||||
| COTTERILL, Brian Raymond | Director | Apartment 1305 Orchard Parksuites 11 Orchard Turn FOREIGN Singapore 23880 Singapore | Australian | 57508210004 | ||||||
| CURTIS, Cheryl Karen | Director | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | United Kingdom | British | 166056480001 | |||||
| DODRIDGE, Philip Andrew | Director | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | United Kingdom | British | 117364550002 | |||||
| DONOVAN, Peter William | Director | 6 Oldfield Close BR1 2LL Bromley Kent | United Kingdom | British | 56232250001 | |||||
| DRABSCH, Neil Gregory | Director | 26 Wyong Road Mosman Sydney 2088 FOREIGN Nsw Australia | Australian | 57323210001 | ||||||
| FABER, Robert Thomas | Director | 307 Churchill Court Sleepy Hollow Illinois 60118 United States | Us Citizen | 39520250001 | ||||||
| FOGARTY, Desmond | Director | 1 St Andrews Curragha Ashbourne Co Meath Ireland | Irish | 79250160001 | ||||||
| GLEN, Paul Edward | Director | Marlands Court Itchingfield RH13 0NN Horsham West Sussex | British | 43947920002 | ||||||
| GORDON, Joe | Director | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | England | British | 182302840001 | |||||
| GRANT, Robert Michael | Director | Betsoms Hill The Avenue TN16 2EE Westerham Kent | British | 70624210001 | ||||||
| GROVE, Peter Ernest | Director | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | United Kingdom | British | 4807730002 | |||||
| GROVE, Peter Ernest | Director | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | United Kingdom | British | 4807730002 | |||||
| HEDIEN, Wayne Evans | Director | 2531 Shannon Road FOREIGN Northbrook Illinois 60062 Usa | Usa By Birth | 13680740001 | ||||||
| HORGAN, Paul Liam | Director | 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London Plantation Place United Kingdom | United Kingdom | British | 172495500001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de QBE RE (EUROPE) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qbe Holdings (Eo) Limited | 06 abr 2016 | 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London Plantation Place United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene QBE RE (EUROPE) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creado el 13 oct 1998 Entregado el 16 oct 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Any and all oligations of the company to the chargee under the security agreement or under any agreement | |
Breve descripción The "charged portfolio" meaning all the company's right title and interest in all securities held to the order for the account or under the control or direction of the bank in account number 6-411604-001 all securities held by any clearance system on behalf of or for the bank in the account numbered euroclear 20419 and cedel 35254 and all rights benefits and proceeds and sums of money for full details please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Reinsurance deposit agreement | Creado el 27 jun 1988 Entregado el 29 jun 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the agreement dated 27.6.88. | |
Breve descripción All monies at the date of the reinsurance deposit agreement see 395 (M93) for details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Security agreement | Creado el 27 jun 1988 Entregado el 29 jun 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the security agreement dated 27/6/88 | |
Breve descripción Seeform 395 for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Letter of hypothecation | Creado el 20 dic 1985 Entregado el 08 ene 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción All bullion coinbills of exchange & other negotiable instruments & all bills of lading warrants & other documents of title to goods, debentures bonds stocks etc (see M45). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0