STORM OF LEICESTER LTD.

STORM OF LEICESTER LTD.

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSTORM OF LEICESTER LTD.
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01380416
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de STORM OF LEICESTER LTD.?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra STORM OF LEICESTER LTD.?

    Dirección de la sede social
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STORM OF LEICESTER LTD.?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    VERTIGONE LIMITED25 jul 197825 jul 1978

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de STORM OF LEICESTER LTD.?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para STORM OF LEICESTER LTD.?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Declaración de confirmación presentada el 29 mar 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Mark Philip Herbert como director el 01 abr 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Timothy Paul Holden como director el 31 mar 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Trevor Garry Finn como director el 31 mar 2019

    1 páginasTM01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 29 mar 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 06 abr 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 23 mar 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Richard James Maloney como secretario el 01 ene 2017

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Hilary Claire Sykes como director el 01 ene 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Hilary Claire Sykes como secretario el 01 ene 2017

    1 páginasTM02

    Cambio de datos del director Mr Trevor Garry Finn el 18 oct 2016

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 23 mar 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 abr 2016

    Estado de capital el 12 abr 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cambio de datos del director Timothy Paul Holden el 26 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 23 mar 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital26 mar 2015

    Estado de capital el 26 mar 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 23 mar 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 abr 2014

    Estado de capital el 10 abr 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 23 mar 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de STORM OF LEICESTER LTD.?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MALONEY, Richard James
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Secretario
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    222329150001
    CASHA, Martin Shaun
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector41114490010
    HERBERT, Mark Philip
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector123285980005
    BENNETT, Michael Ronald
    2 Kentmere Road
    HP21 7HZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secretario
    2 Kentmere Road
    HP21 7HZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    British75618940001
    BOOTH, Brenda
    62 Redesmere Park
    Urmston
    M41 9EP Manchester
    Lancashire
    Secretario
    62 Redesmere Park
    Urmston
    M41 9EP Manchester
    Lancashire
    BritishCompany Secretary16249170005
    DALBY, Sonia Christine
    18 Eastfield Road
    LE3 6FE Leicester
    Leicestershire
    Secretario
    18 Eastfield Road
    LE3 6FE Leicester
    Leicestershire
    British21910150001
    ELLISON, Martin Edward
    1a Longcroft Avenue
    AL5 2QY Harpenden
    Hertfordshire
    Secretario
    1a Longcroft Avenue
    AL5 2QY Harpenden
    Hertfordshire
    British97753620001
    HOLROYD, John
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    Secretario
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    BritishDirector Secretary21483450001
    PERRY, Brian
    46 Marlborough Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7AW Cheadle
    Cheshire
    Secretario
    46 Marlborough Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7AW Cheadle
    Cheshire
    British10759770001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Secretario
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector41559790001
    ANDREWS, Giles Edward Charles
    Flat 36 50 Narrow Street
    E14 8BP London
    Director
    Flat 36 50 Narrow Street
    E14 8BP London
    BritishDirector37743280001
    BIGGS, Anthony Mark
    Lime Tree House
    2 Braddens Furlong
    HP18 9BL Long Crendon
    Buckinghamshire
    Director
    Lime Tree House
    2 Braddens Furlong
    HP18 9BL Long Crendon
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector46681000002
    BRAMALL, Douglas Charles Antony
    Warren Farm Warren Lane
    Brearton
    HG3 3DB Harrogate
    Director
    Warren Farm Warren Lane
    Brearton
    HG3 3DB Harrogate
    United KingdomBritishDirector And Accountant29331220001
    BROWN, Angus Lushington Wylie
    2 Rockford Lodge
    WA16 8AH Knutsford
    Cheshire
    Director
    2 Rockford Lodge
    WA16 8AH Knutsford
    Cheshire
    BritishDirector10759780001
    DAVIS, Andrew Michael
    57 Lache Lane
    CH4 7LP Chester
    Cheshire
    Director
    57 Lache Lane
    CH4 7LP Chester
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector63557750001
    EGERTON, Peter John
    The Wilderness
    Lea Laughton Horton
    ST13 8PZ Rudyard
    Staffordshire
    Director
    The Wilderness
    Lea Laughton Horton
    ST13 8PZ Rudyard
    Staffordshire
    BritishChartered Accountant17294880001
    ELLISON, Martin Edward
    1a Longcroft Avenue
    AL5 2QY Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    1a Longcroft Avenue
    AL5 2QY Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director97753620001
    FINN, Trevor Garry
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector2652610013
    FORSYTH, David Robertson
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    Director
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    United KingdomBritishChartered Accountant55127120002
    GIBBON, John Spencer
    82 Coverside Road
    Great Glen
    LE8 9EA Leicester
    Leicestershire
    Director
    82 Coverside Road
    Great Glen
    LE8 9EA Leicester
    Leicestershire
    BritishDirector21910140001
    HOLDEN, Timothy Paul
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishChartered Accountant148034310003
    HOLROYD, John
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    Director
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    BritishDirector Secretary21483450001
    LINTOTT, Graham Gordon
    Hatch House Thorndon Park
    Herongate
    CM13 3SA Brentwood
    Essex
    Director
    Hatch House Thorndon Park
    Herongate
    CM13 3SA Brentwood
    Essex
    BritishDirector57169010001
    MURRAY, Alec Barclay
    24 Harrop Road
    Hale
    WA15 9DQ Altrincham
    Cheshire
    Director
    24 Harrop Road
    Hale
    WA15 9DQ Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Executive163818290001
    NERDRUM, Arild
    30 Carlton Hill
    NW8 0JY London
    Director
    30 Carlton Hill
    NW8 0JY London
    NorwegianDirector4137560001
    PATTERSON, Steven Shaw
    126 Knighton Road
    LE2 3TQ Leicester
    Leicestershire
    Director
    126 Knighton Road
    LE2 3TQ Leicester
    Leicestershire
    BritishDirector21910160001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector41559790001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de STORM OF LEICESTER LTD.?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Godfrey Davis Motor Group
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    06 abr 2016
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland & Wales
    Número de registro860056
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene STORM OF LEICESTER LTD. alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 13 feb 1995
    Entregado el 17 feb 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H land & buildings k/a 30 nelson street leicester and all buildings fixtures (other than trade) with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 17 feb 1995Registro de un cargo (395)
    • 20 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 jun 1993
    Entregado el 24 jun 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All monies owing to the company by lotus cars limited in respect of refu nds of monies paid by the company to lotus cars by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 24 jun 1993Registro de un cargo (395)
    • 12 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 17 ene 1992
    Entregado el 31 ene 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 31 ene 1992Registro de un cargo (395)
    • 20 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 05 jul 1989
    Entregado el 26 jul 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 26 jul 1989Registro de una carga
    • 20 dic 1991Nombramiento de un receptor o gerente (405 (1))
    • 23 ene 1992Aviso de cese de funciones como receptor o gerente (405 (2))
    • 12 feb 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
      • Número de expediente 1
    Debenture
    Creado el 25 mar 1986
    Entregado el 07 abr 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Stocks shares & securities. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Hongkong and Shanghai Banking
    Transacciones
    • 07 abr 1986Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 31 ene 1983
    Entregado el 07 feb 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Floating charge over undertaking and all property present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Clore Marris (UK) Limited
    Transacciones
    • 07 feb 1983Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 13 dic 1982
    Entregado el 23 dic 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over the f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed of floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts legal mortgage over:- the garage the nook anstey, charhwood, leicestershire. L/h piece of parcel of land fronting stadon road anstey in the county of leicester and/or the proceeds of sale thereof.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 23 dic 1982Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 11 dic 1980
    Entregado el 11 dic 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    15 the nook anstey leicester title no. Lt 105149. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 11 dic 1980Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 05 dic 1980
    Entregado el 05 dic 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land fronting stadon road anstey leicestershire.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 05 dic 1980Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 02 dic 1980
    Entregado el 04 dic 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that leasehold property fronting stadon rd, anstey, leicestershire. Together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Personas con derecho
    • Lambard North Central Limited
    Transacciones
    • 04 dic 1980Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 12 dic 1979
    Entregado el 03 ene 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    15 the nook, anstey, leices.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 03 ene 1980Registro de una carga

    ¿Tiene STORM OF LEICESTER LTD. algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    05 jul 1989Fecha del instrumento
    Administrador judicial nombrado
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Nicholas James Dargan
    St Johns House
    East Street
    LE1 6NG Leicester
    Profesional
    St Johns House
    East Street
    LE1 6NG Leicester
    Lindsay Kennedy Denney
    Touche Ross And Co
    St Johns House
    LE1 6NG East Street
    Leicester
    Profesional
    Touche Ross And Co
    St Johns House
    LE1 6NG East Street
    Leicester

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0