MSQ HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMSQ HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01382912
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MSQ HOLDINGS LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra MSQ HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o MSQ PARTNERS LIMITED
    90 Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MSQ HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    COUTTS HOLDINGS LIMITED14 dic 200414 dic 2004
    COUTTS HOLDINGS PLC.04 may 200404 may 2004
    C.A. COUTTS HOLDINGS PLC11 abr 199611 abr 1996
    ESSEX HOLDINGS LIMITED09 ago 197809 ago 1978

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MSQ HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 feb 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MSQ HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 28 feb 2017

    20 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 06 feb 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 10 Rathbone Place London W1T 1HP England a C/O Browne Jacobson Llp 6 Bevis Marks London EC3A 7BA

    1 páginasAD02

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado C/O Msq Partners Limited 90 Tottenham Court Road London W1T 4TJ

    1 páginasAD04

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 10 Rathbone Place London W1T 1HP

    1 páginasAD03

    Cuentas completas preparadas hasta el 29 feb 2016

    21 páginasAA

    Estado de capital el 22 sept 2016

    • Capital: GBP 0.20
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancel share prem a/c and capital redemption reserve 21/09/2016
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Déclaration annuelle établie au 06 feb 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 mar 2016

    Estado de capital el 24 mar 2016

    • Capital: GBP 4,043,722.2
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 28 feb 2015

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 06 feb 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 feb 2015

    Estado de capital el 06 feb 2015

    • Capital: GBP 4,043,722.2
    SH01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 10 Rathbone Place London W1T 1HP

    AD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 10 Rathbone Place London W1T 1HP

    AD02

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 28 feb 2014

    15 páginasAA

    legacy

    29 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Memorándum y Estatutos

    12 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resoluciones

    Various agreements as listed 16/07/2014
    RES13

    Cancelación total de la carga 12

    4 páginasMR04

    ¿Quiénes son los directivos de MSQ HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SHAH, Ashish
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Secretario
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    164776860001
    REID, Peter David
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Director
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritishChief Executive147274580002
    YARDLEY, Daniel John
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Director
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer180507300001
    ALEXANDER, Charles Stuart
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    Secretario
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    British7666350001
    BRIGDEN, Colin John
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Secretario
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    147343420001
    CLARKE, Martin John
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    Secretario
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    BritishAccountant53461320002
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Secretario
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    British147948820001
    ALEXANDER, Charles Stuart
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    Director
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    BritishChartered Accountant7666350001
    BECKETT, John Douglas Hamilton
    Littlewick Lodge
    Littlewick Green
    SL6 3QU Maidenhead
    Berks
    Director
    Littlewick Lodge
    Littlewick Green
    SL6 3QU Maidenhead
    Berks
    BritishSemi-Retired Consultantant7666360001
    BELL, Patrick Charles
    Coles Barn
    Belchamp Otten
    CO10 7BG Sudbury
    Suffolk
    Director
    Coles Barn
    Belchamp Otten
    CO10 7BG Sudbury
    Suffolk
    United KingdomBritishDirector71758630001
    BURNS, Graeme Ian, Mr.
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    Director
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    United KingdomBritishAccountant75720570001
    CAHN, Christopher Charles
    39 Anchorage Point
    Cuba Street
    E14 8NF London
    Director
    39 Anchorage Point
    Cuba Street
    E14 8NF London
    BritishDirector85328320001
    CUBBON, James Henry
    The Coach House
    Hammer Lane, Grayshott
    GU26 6JD Hindhead
    Surrey
    Director
    The Coach House
    Hammer Lane, Grayshott
    GU26 6JD Hindhead
    Surrey
    EnglandBritishDirector47485650002
    ESSEX, Charles Edward Oliver
    Elm Green Farm
    Danbury
    CM3 4DW Chelmsford
    Essex
    Director
    Elm Green Farm
    Danbury
    CM3 4DW Chelmsford
    Essex
    BritishSales Representative7666370001
    ESSEX, Norman Arthur
    Elm Green Farm
    Danbury
    CM3 4DW Chelmsford
    Essex
    Director
    Elm Green Farm
    Danbury
    CM3 4DW Chelmsford
    Essex
    BritishCompany Director7666380001
    ESSEX, Robert Thomas Tickler
    21 Rylett Road
    W12 9SS London
    Director
    21 Rylett Road
    W12 9SS London
    EnglandBritishCompany Director7666390002
    ESSEX, William Alexander Wells
    Potash Cottage
    Strethall
    CB11 4XJ Saffron Walden
    Essex
    Director
    Potash Cottage
    Strethall
    CB11 4XJ Saffron Walden
    Essex
    BritishMagazine Editor7666400001
    FOWLER, Robert Edward
    42 Foord Road
    Lenham
    ME17 2QN Maidstone
    Kent
    Director
    42 Foord Road
    Lenham
    ME17 2QN Maidstone
    Kent
    United KingdomBritishDirector26408910001
    HARRIS, Graeme Richard
    35 Allerton Road
    N16 5UF London
    Director
    35 Allerton Road
    N16 5UF London
    EnglandBritishDirector56342040002
    HIGSON, Alexander
    21 Straightsmouth
    SE10 9LB London
    Director
    21 Straightsmouth
    SE10 9LB London
    BritishExecutive Recruitment7666410001
    MIDDLETON, Arthur Jeremy Barritt
    Corbar Hall
    Corbar Road
    SK17 6TF Buxton
    Director
    Corbar Hall
    Corbar Road
    SK17 6TF Buxton
    EnglandBritishCompany Director72455560001
    PARRY, Roger George
    27 Edwardes Square
    W8 6HH London
    Director
    27 Edwardes Square
    W8 6HH London
    United KingdomBritishExec Chairman41614380002
    PENN, John Robert
    The Willows
    Wellington Hill
    IG10 4AH Loughton
    Essex
    Director
    The Willows
    Wellington Hill
    IG10 4AH Loughton
    Essex
    United KingdomEnglishNone7147450002
    SAYSELL, Richard Geoffrey
    43 Manor Avenue
    Brockley
    SE4 1PE London
    Director
    43 Manor Avenue
    Brockley
    SE4 1PE London
    BritishDirector50920320002
    SMITH, Anthony Michael
    9 Culverden Down
    TN4 9SB Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    9 Culverden Down
    TN4 9SB Tunbridge Wells
    Kent
    BritishDirector26408890003
    STERN, Nigel Duncan
    Flat 3, 27 Adolphus Road
    N4 2AT London
    Director
    Flat 3, 27 Adolphus Road
    N4 2AT London
    BritishDirector58083200002
    WHITEHORN, William Elliott
    31 Dents Road
    SW11 6JA London
    Director
    31 Dents Road
    SW11 6JA London
    United KingdomBritishDirector46878420002
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Director
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    United KingdomBritishAccountant147948820001
    WRIGHT, Dean Anthony
    c/o Msq Partners Limited
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Director
    c/o Msq Partners Limited
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector159138180001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de MSQ HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    06 abr 2016
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUk (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House (England And Wales)
    Número de registro07745643
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene MSQ HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 16 jul 2014
    Entregado el 21 jul 2014
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Nvm Private Equity Limited
    Transacciones
    • 21 jul 2014Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 16 jul 2014
    Entregado el 18 jul 2014
    Pendiente
    Breve descripción
    Description of all registered intellectual property rights subject to this security can be found in schedule 5 of the debenture.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Agent for National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 jul 2014Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 27 sept 2013
    Entregado el 04 oct 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transacciones
    • 04 oct 2013Registro de una carga (MR01)
    • 02 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Hong kong law share charge
    Creado el 07 sept 2012
    Entregado el 19 sept 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The charged assets meaning the shares and derivative assets and includes all rights benefits and sums now or in the future accruing as a result of or in connection with any of the shares or the derivative assets see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 19 sept 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 02 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental debenture
    Creado el 06 feb 2012
    Entregado el 23 feb 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 23 feb 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 02 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    New york law stock pledge agreement
    Creado el 06 feb 2012
    Entregado el 17 feb 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and the other obligors to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Right title and interest in the pledged shares and additional collateral and any certificates and instruments see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 17 feb 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 02 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Share charge
    Creado el 06 feb 2012
    Entregado el 14 feb 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All interest in the existing shares, any additional shares, any derived assets and any dividends see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 14 feb 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 02 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 08 dic 2011
    Entregado el 20 dic 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 dic 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 02 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Share mortgage
    Creado el 20 ene 2006
    Entregado el 01 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right title and interest in the securities being the original securities and additional securities including dividends,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Parties(As Security Trustee)
    Transacciones
    • 01 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Share charge
    Creado el 16 ene 2006
    Entregado el 01 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the company's interest in the shares being 100 ordinary shares of £1.00 each in the company and related rights,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    Transacciones
    • 01 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Cession and pledge in security
    Creado el 09 nov 2005
    Entregado el 17 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly k/a coutts holdings limited to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of the shares and ceded rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Acting as Security Trustee)
    Transacciones
    • 17 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 04 nov 2005
    Entregado el 17 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 17 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Share pledge agreement
    Creado el 04 nov 2005
    Entregado el 17 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly k/a coutts holdings limited, the borrower or other obligors and their subsidiaries to the chargee and future pledgees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The existing share in the nominal amount of 25,000 euro in the pledged company being citigate group holdings gmbh as well as any and all other shares in the pledged company which the pledgor may acquire in the future by contribution or otherwise and the security collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    Transacciones
    • 17 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Share pledge agreement
    Creado el 04 nov 2005
    Entregado el 17 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly k/a coutts holdings limited, the borrower or other obligors and their subsidiaries to the chargee and future pledgees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The existing share in the nominal amount of 25,000 euro in the pledged company being citigate gmbh as well as any and all other shares in the pledged company which the pledgor may acquire in the future by contribution or otherwise and the security collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    Transacciones
    • 17 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Share pledge agreement
    Creado el 04 nov 2005
    Entregado el 17 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly k/a coutts holdings limited, the borrower or other obligors and their subsidiaries to the chargee and future pledgees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The existing share in the aggregate nominal amount of 20,000 euro in the pledged company being hoffmann schalt werbeagentur gmbh as well as any and all other shares in the pledged company which the pledgor may acquire in the future by contribution or otherwise and the security collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    Transacciones
    • 17 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Pledge agreement
    Creado el 04 nov 2005
    Entregado el 17 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The right, title and interest in and to its pledged stock and a senior, first priority lien in all of the pledgor's right, title and interest in the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    Transacciones
    • 17 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Share pledge
    Creado el 04 nov 2005
    Entregado el 17 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The existing shares and related rights and any additional shares and related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    Transacciones
    • 17 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 15 oct 2004
    Entregado el 22 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 22 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 13 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 15 feb 1984
    Entregado el 07 mar 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property known as bakery premises forming part of the borough of chelmsford's widford industrial estate at robyohns road chelmsford and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 07 mar 1984Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0