MILLETS SHOPS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | MILLETS SHOPS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01389207 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MILLETS SHOPS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra MILLETS SHOPS LIMITED?
Dirección de la sede social | 440-450 Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MILLETS SHOPS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
MILLETTS SHOPS (MSS) LIMITED | 05 jun 1995 | 05 jun 1995 |
OLYMPUS SPORTSWORLD LIMITED | 30 jun 1993 | 30 jun 1993 |
MILLETTS SHOPS SCOTLAND LIMITED | 31 dic 1978 | 31 dic 1978 |
GARRYGLASS LIMITED | 15 sept 1978 | 15 sept 1978 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MILLETS SHOPS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 26 feb 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MILLETS SHOPS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Derrick Beacham como secretario el 03 feb 2012 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Julia Reynolds como director el 03 feb 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Dominic Joseph Lavelle como director el 03 feb 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Derrick Beacham como director el 03 feb 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Marcello Lombardo como director el 16 dic 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Dominic Joseph Lavelle como director el 21 nov 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 oct 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 feb 2011 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Ms Julia Reynolds como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 39 páginas | MA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Hitt como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Derrick Beacham como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||||||
Detalles de la variación de los derechos vinculados a las acciones | 2 páginas | SH10 | ||||||||||||||
Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones | 2 páginas | SH08 | ||||||||||||||
Consolidación de acciones el 05 nov 2010 | 9 páginas | SH02 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 40 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 oct 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 feb 2010 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 oct 2009 avec liste complète des actionnaires | 14 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 oct 2009 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Richard John Hitt el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MILLETS SHOPS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEACHAM, Mark Derrick | Secretario | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 United Kingdom | British | 135313320001 | ||||||
FOOT, Peter John Lewis | Secretario | 1 Normanton Lane Stanford On Soar LE12 5PZ Loughborough Leicestershire | British | 51176110002 | ||||||
HALL, Vikki | Secretario | 28 Burman Drive Coleshill B46 3NB Birmingham | British | 82602670001 | ||||||
O'KEEFFE, Mark John | Secretario | 5 Fowey Close NN8 5WW Wellingborough Northamptonshire | British | 57880430001 | ||||||
PILLAY, Paul Vijayasingam | Secretario | 69 Lilleshall Avenue Monkston MK10 9HU Milton Keynes | Other | Head Of Finance & Company Secr | 79416150001 | |||||
QUINLAN, Diane | Secretario | 40 Duke Street W1A 2HP London | British | 38760910001 | ||||||
SEARS SPORTS AND LEISUREWEAR PLC | Secretario corporativo | Sunningdale Road LE3 1TP Leicester | 16600870001 | |||||||
ASTLEY, Brian Martin | Director | 25 Marjorie Grove SW11 5SH London | British | Director | 75795040001 | |||||
BEACHAM, Mark Derrick | Director | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 160095260001 | ||||
CHAMBERLAIN, Adrian | Director | Butlers Hall Wareside SG12 7QL Ware Hertfordshire | British | Director | 117106730001 | |||||
CROSLAND, Roy Nicholson | Director | 35 Addison Avenue W11 4QS London | British | Director | 30882970002 | |||||
DRUM, John David Francis | Director | 1 Garrick Road Hendon NW9 6AU London | British | Company Secretary | 13103440003 | |||||
FALLON, John Edward | Director | Gardeners Cottage Old Hall Drive Widmerpool Keyworth NG12 5PZ Nottingham | British | Director | 52124910001 | |||||
FLEMING, Keith | Director | Brookmead House The Warren, East Horsley KT24 5RH Leatherhead Surrey | England | British | Director | 112723440002 | ||||
FOOT, Peter John Lewis | Director | 1 Normanton Lane Stanford On Soar LE12 5PZ Loughborough Leicestershire | British | Company Director | 51176110002 | |||||
HARDY, Russell Stephen Mons | Director | The Reddings Langley Road, Claverdon CV35 8P Warwick Warwickshire | England | British | Chief Executive | 45844210003 | ||||
HARTLEY, Peter Christopher | Director | 17 Jacobean Lane Knowle B93 9LP Solihull | United Kingdom | British | Finance Director | 96458190001 | ||||
HITT, Richard John | Director | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 United Kingdom | United Kingdom | British | Business Analysis & Insight | 127468180001 | ||||
JONES, Anthony David | Director | 32 Cross Lane Mountsorrel LE12 7BY Loughborough Leicestershire | British | Director | 41640680001 | |||||
LAVELLE, Dominic Joseph | Director | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 137285750001 | ||||
LIS, Andrew Richard | Director | 139 Clapham Road SW99 0HR London | British | Group Tax Manager | 62660110001 | |||||
LOASBY, Andrew | Director | 3 The Banks NN9 5YX Wellingborough Northamptonshire | British | Director | 48081840002 | |||||
LOMBARDO, Marcello | Director | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 United Kingdom | England | British | Finance Director | 135699240001 | ||||
MALONE, Desmond Philip | Director | 1 Morpeth B77 1JF Tamworth Staffordshire | England | British | Director | 87170450001 | ||||
MAYWOOD, Terry Osborn | Director | Longston House School Lane Islip NN14 3LQ Kettering Northamptonshire | British | Retail Director | 39631730004 | |||||
MEEHAN, Andrew David | Director | Southview Church Lane Lighthorne CV35 0AT Warwick | England | British | Director | 62737150001 | ||||
REYNOLDS, Julia | Director | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 United Kingdom | England | British | Chief Executive | 127468460001 | ||||
SHEATH, Christopher Gordon | Director | Avonlea Hop Gardens, Whiteparish SP5 2SS Salisbury Wiltshire | British | Finance Director | 69543550002 | |||||
STAINES, Michael John | Director | 4 Fleetwind Drive NN4 0ST Northampton Northamptonshire | British | Director | 16626330001 | |||||
VICKERS, Alan Christopher | Director | The Ashes 8 Cross Hedge Rothley LE7 7RR Leicester Leicestershire | British | Director | 1971520001 |
¿Tiene MILLETS SHOPS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and debenture | Creado el 04 mar 1996 Entregado el 13 mar 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All liabilities and obligations due or to become due from the company and any group company to the chargees pursuant to the terms of the hedging arrangements and the finance documents (as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Charges | Creado el 13 sept 1985 Entregado el 16 sept 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixied & floating charges over goodwill & book debt & other debts.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0