TAYLOR WIMPEY UK LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | TAYLOR WIMPEY UK LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01392762 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TAYLOR WIMPEY UK LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra TAYLOR WIMPEY UK LIMITED?
| Dirección de la sede social | Gate House Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Buckinghamshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TAYLOR WIMPEY UK LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GEORGE WIMPEY UK LIMITED | 02 abr 2001 | 02 abr 2001 |
| WIMPEY HOMES HOLDINGS LIMITED | 31 dic 1978 | 31 dic 1978 |
| CASHSUB LIMITED | 06 oct 1978 | 06 oct 1978 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TAYLOR WIMPEY UK LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para TAYLOR WIMPEY UK LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 05 ene 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 19 ene 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 05 ene 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TAYLOR WIMPEY UK LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registro de la carga 013927621063, creada el 20 mar 2026 | 23 páginas | MR01 | ||||||
Registro de la carga 013927621061, creada el 27 feb 2026 | 64 páginas | MR01 | ||||||
Registro de la carga 013927621062, creada el 27 feb 2026 | 64 páginas | MR01 | ||||||
Cancelación total de la carga 013927620889 | 1 páginas | MR04 | ||||||
Registro de la carga 013927621060, creada el 11 feb 2026 | 28 páginas | MR01 | ||||||
Cancelación total de la carga 013927621052 | 4 páginas | MR04 | ||||||
Cancelación total de la carga 013927621033 | 1 páginas | MR04 | ||||||
Cancelación total de la carga 013927621022 | 1 páginas | MR04 | ||||||
Nombramiento de Ms Maria Cristina Perez Sebastian como director el 03 feb 2026 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Cancelación total de la carga 013927621007 | 4 páginas | MR04 | ||||||
Registro de la carga 013927621059, creada el 09 ene 2026 | 24 páginas | MR01 | ||||||
Registro de la carga 013927621058, creada el 09 ene 2026 | 25 páginas | MR01 | ||||||
Cancelación total de la carga 013927620945 | 1 páginas | MR04 | ||||||
Cancelación total de la carga 013927620984 | 1 páginas | MR04 | ||||||
Registro de la carga 013927621057, creada el 24 dic 2025 | 17 páginas | MR01 | ||||||
Registro de la carga 013927621056, creada el 05 ene 2026 | 7 páginas | MR01 | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 ene 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cese del nombramiento de Ingrid Ruth Osborne como director el 31 dic 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Registro de la carga 013927621055, creada el 19 dic 2025 | 25 páginas | MR01 | ||||||
Registro de la carga 013927621054, creada el 27 nov 2025 | 50 páginas | MR01 | ||||||
| ||||||||
Registro de la carga 013927621053, creada el 26 nov 2025 | 32 páginas | MR01 | ||||||
Registro de la carga 013927621052, creada el 25 nov 2025 | 23 páginas | MR01 | ||||||
Cancelación total de la carga 013927621046 | 1 páginas | MR04 | ||||||
Registro de la carga 013927621051, creada el 31 oct 2025 | 25 páginas | MR01 | ||||||
Registro de la carga 013927621050, creada el 10 oct 2025 | 42 páginas | MR01 | ||||||
¿Quiénes son los directivos de TAYLOR WIMPEY UK LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAYANI, Muhammed Ishaq | Secretario | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | 305846670001 | |||||||
| BILLSON-ROSS, Katherine Anne | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 163343100001 | |||||
| BISHOP, Lee Michael | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 34373800003 | |||||
| CARNEY, Christopher | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 125216670002 | |||||
| DALY, Jennifer, Ms. | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 197094000002 | |||||
| DRUMMOND, Ian Scott | Director | Masterton Park KY11 8NX Dumfermline 1 Fife United Kingdom | United Kingdom | British | 247163520001 | |||||
| KAYANI, Muhammed Ishaq | Director | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | United Kingdom | British | 305846700001 | |||||
| SEBASTIAN, Maria Cristina Perez | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | United Kingdom | British | 340576560001 | |||||
| SIDHU, Novraj | Director | The Arc Office Park Springfield Drive KT22 7LP Leatherhead Taylor Wimpey United Kingdom | United Kingdom | British | 318611010001 | |||||
| WHITE, Shaun Roland | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 138592590001 | |||||
| BLACK, Alice Hannah | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 264031140002 | |||||||
| BORT, Stefan Edward | Secretario | 126 Grove Park SE5 8LD London | British | 32824200005 | ||||||
| BORT, Stefan Edward | Secretario | 126 Grove Park SE5 8LD London | British | 32824200005 | ||||||
| CARR, Peter Anthony | Secretario | 551 Avebury Boulevard MK9 3DR Milton Keynes Beech House Buckinghamshire England | British | 130306120001 | ||||||
| HASTIE, Nicola Amanda Eleanor | Secretario | 97 Yew Tree Lane Tettenhall WV6 8UN Wolverhampton | British | 76844970003 | ||||||
| INGRAM, Peter William Irving | Secretario | 40 Landford Road SW15 1AG London | British | 1359100001 | ||||||
| JORDAN, James John | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 162553580001 | |||||||
| JORDAN, James John | Secretario | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||
| LONNON, Michael Andrew, Mr. | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 299517620001 | |||||||
| PHILLIPS, James | Secretario | Stallworth 6 Wood Road Tettenhall WV6 8LS Wolverhampton West Midlands | British | 8364990001 | ||||||
| WHEATLEY, Catherine Bernadette | Secretario | 138 Jerningham Road Telegraph Hill SE14 5NL London | British | 47834500001 | ||||||
| ANDREW, Peter Robert | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 113503830003 | |||||
| ANDREW, Richard Arnold | Director | Cornwell Hill Farm Worcester Road OX7 5YG Chipping Norton Oxfordshire | British | 61786350003 | ||||||
| ATHORN, Neil | Director | Hideaway 81 Shrigley Road South SK12 1TF Poynton Cheshire | British | 75754050004 | ||||||
| BERNARD, Peter David | Director | 16 Avenue Road TW11 0BT Teddington Middlesex | United Kingdom | British | 34673830001 | |||||
| BLACK, Alice Hannah | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 264031110002 | |||||
| BLACKER, Michael | Director | 46 Ridgeway RG10 8AS Wargrave Berkshire | England | British | 120377750001 | |||||
| BRANT, Dennis | Director | 11 Ranelagh Drive North Grassenoale L19 9DS Liverpool | British | 79472910001 | ||||||
| BRIDGES, David Crawford | Director | Doric House 24a Amersham Road HP13 6QU High Wycombe Buckinghamshire | England | British | 94982860001 | |||||
| BULLOUGH, Rodney Howard | Director | 22 Oakdene SL5 0BU Ascot Berkshire | British | 56465560001 | ||||||
| CARNEY, Christopher | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 125216670001 | |||||
| COWIE, Brian Henry | Director | Century Lodge 100 Shenfield Road Shenfield CM15 8ET Brentwood Essex | British | 32832000001 | ||||||
| CUSHEN, Keith Morgan | Director | Buddleia Cottage High Street TW12 2SX Hampton Middlesex | British | 37763770002 | ||||||
| CUSHEN, Keith Morgan | Director | Six Oaks 4 Rainsford Close Clifford Chambers CV37 8HY Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 37763770001 | ||||||
| DODDS, Graeme James | Director | 16 Second Avenue CO13 9ER Frinton On Sea Essex | England | British | 146495490001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TAYLOR WIMPEY UK LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Wimpey Developments Limited | 06 abr 2016 | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0