DST INNOVIS INTERNATIONAL LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | DST INNOVIS INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01394433 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DST INNOVIS INTERNATIONAL LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra DST INNOVIS INTERNATIONAL LIMITED?
| Dirección de la sede social | Seventh Floor 90 High Holborn WC1V 6XX London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DST INNOVIS INTERNATIONAL LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DST INNOVIS INTERNATIONAL PLC | 08 oct 1999 | 08 oct 1999 |
| CUSTIMA INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | 12 dic 1994 | 12 dic 1994 |
| CREATIVE COMPUTER SYSTEMS LIMITED | 17 oct 1978 | 17 oct 1978 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DST INNOVIS INTERNATIONAL LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DST INNOVIS INTERNATIONAL LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 abr 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 abr 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Olswang Cosec Limited como secretario | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 abr 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Michael Joseph Saeger el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Olswang Cosec Limited el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008 | 10 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 4 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 288a | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2007 | 10 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 288a | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2006 | 11 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 4 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 7 páginas | 363s | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de DST INNOVIS INTERNATIONAL LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAEGER, Michael Joseph | Director | 1118 Spring Orchard Dr O'Fallon Mo 63368 Usa | Usa | American | 132979460001 | |||||||||
| CATER, Anthony Ralph | Secretario | 168 Lodge Lane RM16 2TS Grays Essex | British | 58166010001 | ||||||||||
| CATER, Anthony Ralph | Secretario | 168 Lodge Lane RM16 2TS Grays Essex | British | 58166010001 | ||||||||||
| LACEY, Oliver Blomfield | Secretario | The White Cottage Norcott Hall HP4 1LB Northchurch Hertfordshire | British | 76927620002 | ||||||||||
| REEDER, Tracy | Secretario | 12 Partridge Road The Avenue TW12 3SB Hampton Middlesex | British | 67016660002 | ||||||||||
| SCOTT, Roderick Frank | Secretario | 89 Cottenham Park Road Wimbledon SW20 0DS London | British | 3758800003 | ||||||||||
| STEELE, Anne | Secretario | 25 The Avenue Chiswick W4 1HA London | British | 77624110001 | ||||||||||
| MASONS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 30 Aylesbury Street EC1R 0ER London | 32643220001 | |||||||||||
| OLSWANG COSEC LIMITED | Secretario corporativo | High Holborn WC1V 6XX London Seventh Floor, 90 United Kingdom |
| 83864780002 | ||||||||||
| REED SMITH CORPORATE SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Minerva House 5 Montague Close SE1 9BB London | 80748880001 | |||||||||||
| CAPAL, Barry | Director | 30 Church Lane IG10 1PD Loughton Essex | British | 13121900001 | ||||||||||
| CATER, Anthony Ralph | Director | 168 Lodge Lane RM16 2TS Grays Essex | England | British | 58166010001 | |||||||||
| COPELLO, Philippe Pierre Alain | Director | 96 Rue Du President Wilson 92300 Levallois France | French | 37755670001 | ||||||||||
| DARBY, Peter William | Director | 20 Herdson Road CT20 2PB Folkestone Kent | British | 42644160001 | ||||||||||
| DELL, Susan Ursula | Director | 15118 De La Cruz Rancho Murieta Ca 95683 Usa | Usa | 73814290001 | ||||||||||
| EWAN, James Gordon | Director | 16 The Winery Regents Bridge Gardens Rita Road SW8 1RJ London | British | 46387310001 | ||||||||||
| FRAMPTON, Michael David | Director | 5670 Stone Haven Court CA 95746 Granite Bay California Usa | British | 54352500003 | ||||||||||
| FRANK, Peter Henry Edmund | Director | 2 Butt Lane Allesley CV5 9EU Coventry West Midlands | British | 29010440001 | ||||||||||
| GASCHIGNARD, Pierre Etienne | Director | 2 Petite Rue De Refuge FOREIGN Versailles 78000 France | French | 13121920002 | ||||||||||
| GRACIE, Anita Elizabeth | Director | 28 Windsor Road Holloway N7 6JG London | United Kingdom | British | 57619410001 | |||||||||
| HARTNELL, Nigel Raymond | Director | 7 North Avenue Ealing W13 8AP London | England | British | 13121930001 | |||||||||
| HATCH, Brett | Director | 26 Pitman Hill Road St Charles Missouri 63304 Usa | American | 106338680001 | ||||||||||
| HORGAN, John J | Director | 319 Tulip Drive FOREIGN St Louis Missouri 63119 Usa | United States | 106338760001 | ||||||||||
| HORGAN, John J | Director | 319 Tulip Drive FOREIGN St Louis Missouri 63119 Usa | United States | 106338760001 | ||||||||||
| KLEIN, Zaida Avila | Director | 9555 Golf Course Lane Elk Grove Ca 95758 Usa | Us Citizen | 82335640003 | ||||||||||
| KNIGHT, Jane Elizabeth | Director | 1 Rectory Lane ME16 9BE Maidstone Kent | England | British | 106193590001 | |||||||||
| MCGRAIL, Michael | Director | 86 Sigrist Square KT2 6JY Kingston Upon Thames Surrey | British | 24508960002 | ||||||||||
| MCGUIRK, Kieran | Director | 13 The Park AL1 4SE St Albans Hertfordshire | England | British | 167992250001 | |||||||||
| MUIR, George Watson | Director | 32 Hestercombe Avenue SW6 5LG London | United Kingdom | British | 12446270001 | |||||||||
| NAULT, Peter J | Director | 10518 Kenlauren Terrace Charlotte North Carolina 28210 Usa | Us Citizen | 82335670001 | ||||||||||
| PATEL, Kiran Dayalji | Director | 11 St Johns Terrace Road Earlswood RH1 6HS Redhill Surrey | British | 77621760001 | ||||||||||
| POWELL, Patricia Margaret | Director | 23 Mansard Close RM12 4HS Hornchurch Essex | British | 44922510001 | ||||||||||
| RIDDLE, Richard John Smillie | Director | 25 Connel Road Blairgowrie Randburg FOREIGN South Africa | British | 42052310002 | ||||||||||
| TEAGUE, David John | Director | 107 Queens Road TW11 0LZ Teddington Woodborough House Middlesex Uk | United Kingdom | British | 144848790001 | |||||||||
| WHITTAKER, Martyn Richard | Director | 7 Childsbridge Way Seal TN15 0DG Sevenoaks Kent | British | 50406940002 |
¿Tiene DST INNOVIS INTERNATIONAL LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Creado el 16 jul 1996 Entregado el 24 jul 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over credit balances | Creado el 25 may 1993 Entregado el 09 jun 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a guarantee dated 25/5/93 in favour of deutsche gesellschaft fur technische zusannenarbeit (gtz) gmbh for £9200 | |
Breve descripción The sum of £9200 together with interest held by national westminster bank PLC on an account no. 95313710 and designated by reference to the company. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0