COOPER SECURITY LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | COOPER SECURITY LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01396471 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de COOPER SECURITY LIMITED?
- fabricación de equipos de comunicación, excepto aparatos y equipos de telégrafo y teléfono (26309) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra COOPER SECURITY LIMITED?
Dirección de la sede social | Jephson Court Tancred Close Queensway CV31 3RZ Royal Leamington Spa Warwickshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COOPER SECURITY LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
SCANTRONIC LIMITED | 31 dic 1979 | 31 dic 1979 |
BROOKEXPRESS LIMITED | 27 oct 1978 | 27 oct 1978 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de COOPER SECURITY LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para COOPER SECURITY LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Retiro de la solicitud de exclusión de la empresa | 1 páginas | DS02 | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 jul 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 jul 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cessation de Scantronic Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 jul 2016 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Notification de Eaton Electrical Products Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 jun 2016 | 1 páginas | PSC02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Andrew Jackson como director el 08 may 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Anthony Walsh como director el 08 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 24 páginas | AA | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 100 New Bridge Street London EC4V 6JA a Jephson Court Tancred Close Leamington Spa CV31 3RZ | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 jul 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Estado de capital el 04 ago 2016
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Abogado Nominees Limited como secretario el 10 feb 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr. Richard Howes como director el 28 may 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr. Anthony Walsh como director el 28 may 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Martin Gerard Mullin como director el 28 may 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de COOPER SECURITY LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOWES, Richard Paul | Director | Tancred Close CV31 3RZ Leamington Spa Jephson Court Warwickshire England | United Kingdom | British | Operations Director | 198769780001 | ||||||||
JACKSON, Andrew | Director | Jephson Court Tancred Close Queensway CV31 3RZ Royal Leamington Spa Warwickshire | England | British | Finance Director | 199276600001 | ||||||||
DIAS, Raymond | Secretario | 1 Castlereagh House Lady Aylesford Avenu HA7 4FP Stanmore Middlesex | British | 102027890001 | ||||||||||
DICKS, Karen Dawn | Secretario | 39 Orchard Way Churchdown GL3 2AP Gloucester Gloucestershire | British | Financial Controller | 42695110001 | |||||||||
HELZ, Terrance Valentine | Secretario | 11 China Rose Court The Woodlands Texas 77381 Usa | American | 61652840001 | ||||||||||
HERBERT, Karen Elizabeth | Secretario | 10 Aylesbury Court 77479 Sugarland Texas America | British | 37383450001 | ||||||||||
JAMES, Gavin Keith | Secretario | Gable House Church End CV23 8SN Priors Hardwick Warwickshire | British | Director | 44173560002 | |||||||||
JARRETT, Marilyn Frances | Secretario | 47 Warkworth Close OX16 1BD Banbury Oxfordshire | British | 64181020001 | ||||||||||
JENKINS, Hywel Probert | Secretario | 9 Ross Court Cleveland Road Ealing W13 8ED London | British | Finance Director | 98800060001 | |||||||||
ABOGADO NOMINEES LIMITED | Secretario designado corporativo | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London |
| 900021150001 | ||||||||||
ALLEN, Anthony Thaddeus | Director | Hillside Llansoy NP15 1DF Usk Gwent | Wales | British | Company Director | 64198880001 | ||||||||
BEYEN, Kris Maria August | Director | Tancred Close Queensway CV31 3RZ Royal Leamington Spa Jephson Court Warwickshire | United Kingdom | Belgian | Business Executive | 157565820001 | ||||||||
BROOKES, Christopher | Director | Woodacres Nightingales Lane HP8 4SG Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | Company Director | 16102860001 | |||||||||
BROWN, David Edward | Director | 35 Hatchet Lane Stonely PE19 5EG St Neots Cambridgeshire | United Kingdom | British | Company Director | 16178630001 | ||||||||
CLEMENTSON, Mark Chris | Director | 2 Elliotts Orchard CV35 8ED Barford Warwickshire | Us | Company Director | 83533510001 | |||||||||
DAVIDSON, Gregory Paul | Director | 3 The Swallow Wellington Heath HR8 1NA Ledbury Herefordshire | British | Business Executive | 43114160003 | |||||||||
DIAS, Raymond | Director | 1 Castlereagh House Lady Aylesford Avenu HA7 4FP Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | Company Director | 102027890001 | ||||||||
DICKS, Karen Dawn | Director | 39 Orchard Way Churchdown GL3 2AP Gloucester Gloucestershire | British | Financial Controller | 42695110001 | |||||||||
FLETCHER, Michael Alistair | Director | 81 Thames Avenue SN25 3NS Swindon Wiltshire | British | Company Director | 70180240001 | |||||||||
FLETCHER, Roger Barrett | Director | The Knowle North Newington OX15 6AN Banbury Oxfordshire | British | Director | 16260890002 | |||||||||
FRASER, Michael Ashley | Director | Middle Barn Front Street Chedzoy TA7 8RE Bridgwater Somerset | British | Company Director | 6677020001 | |||||||||
GASCOIGNE, Alan John | Director | 1 Silver Birches Lincoln Hill HR9 7UX Ross On Wye Herefordshire | English | Accountant | 43087980002 | |||||||||
GAWRONSKI, Grant Lawrence | Director | 19 Hunters Crossing Court The Woodlands Texas 77381 Usa | Usa | American | Business Executive | 115387690001 | ||||||||
HAACK, Axel Gottfried Gunther | Director | 9 Haute Corniche 67210 Obernai France | German | Business Executive | 120071580001 | |||||||||
HURST, Barrie | Director | Norwood Chapel Lane Bodicote OX15 4DB Banbury Oxfordshire | England | British | Director | 16260900001 | ||||||||
JAMES, Gavin Keith | Director | Gable House Church End CV23 8SN Priors Hardwick Warwickshire | British | Director | 44173560002 | |||||||||
JENKINS, Hywel Probert | Director | 9 Ross Court Cleveland Road Ealing W13 8ED London | British | Finance Director | 98800060001 | |||||||||
KNEIS, Thomas David | Director | 5 Cranborne Close Belmont HR2 7SY Hereford | American | Sales Director | 53129310002 | |||||||||
KNOX, Kenneth George | Director | 13 Guinea Court Chineham RG24 8XJ Basingstoke Hampshire | British | Company Director | 14940570001 | |||||||||
LOWREY, David Henry Tyson | Director | The Granary Hazel Farm Barn HR8 2HT Ledbury | United Kingdom | British | Accountant | 122583430001 | ||||||||
LUNN, David William | Director | New House GL16 7PD English Bicknor Gloucestershire | England | British | Business Executive | 121935710001 | ||||||||
MULLIN, Martin Gerard | Director | Tancred Close CV31 3RZ Leamington Spa Jephson Court Warwickshire England | England | British | Vice President & Gm | 150271550001 | ||||||||
REES, James Warren | Director | Birchley House Birchley Road Battledown GL52 6NY Cheltenham Gloucestershire | British | Director | 59758530001 | |||||||||
RIPLEY, David Arthur | Director | 4 Lyme Park Chinley SK23 6AG High Peak Derbyshire | England | British | Business Executive | 83533780001 | ||||||||
SCRIMSHAW, James Eric | Director | Dove House Temple Grafton B49 6NT Alcester Warwickshire | British | Company Director | 60793220002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de COOPER SECURITY LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scantronic Holdings Limited | 28 jul 2016 | Tancred Close CV31 3RZ Leamington Spa Jephson Court England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Eaton Electrical Products Limited | 30 jun 2016 | Tancred Close CV31 3RZ Leamington Spa 6 Jephson Court England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene COOPER SECURITY LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Creado el 06 oct 1994 Entregado el 14 oct 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 13 oct 1993 Entregado el 21 oct 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 10 feb 1988 Entregado el 24 feb 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 06 jul 1980 Entregado el 16 jul 1980 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital. Together with all fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0