HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01400552 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Trinity House Riverside Road NR33 0SW Lowestoft England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| THE HOSEASONS GROUP HOLDINGS LIMITED | 30 jun 2011 | 30 jun 2011 |
| THE HOSEASONS GROUP LIMITED | 09 jun 2010 | 09 jun 2010 |
| HOLIDAY COTTAGES GROUP LIMITED | 15 feb 1996 | 15 feb 1996 |
| COUNTRY HOLIDAYS LIMITED | 27 feb 1987 | 27 feb 1987 |
| COUNTRY HOLIDAYS (SKIPTON) LIMITED | 17 nov 1978 | 17 nov 1978 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 08 feb 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 22 feb 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 08 feb 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2024 | 17 páginas | AA | ||
legacy | 2 páginas | AGREEMENT2 | ||
legacy | 116 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
Cese del nombramiento de Garry Clark Adam como director el 30 jul 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Trinity House Waveney Drive Lowestoft NR33 0SW England a Trinity House Riverside Road Lowestoft NR33 0SW el 08 jul 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Sunway House Raglan Road Lowestoft NR32 2LW England a Trinity House Waveney Drive Lowestoft NR33 0SW el 01 jul 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de The Triangle 5 - 17 Hammersmith Grove Hammersmith London W6 0LG England a Aviation House 125 Kingsway London WC2B 6NH | 1 páginas | AD02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 08 feb 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Matthew John Price como director el 07 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Henrik Vilhelm Kjellberg como director el 07 feb 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2023 | 18 páginas | AA | ||
legacy | 118 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 2 páginas | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 2 páginas | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 25 mar 2024
| 3 páginas | SH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 08 feb 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Notification de Awaze Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 sept 2023 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessation de Compass Bidco Ii Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 sept 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||
Comptes annuels modifiés établis au 31 dic 2022 | 22 páginas | AAMD | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 22 páginas | AA | ||
Estado de capital el 19 abr 2023
| 5 páginas | SH19 | ||
¿Quiénes son los directivos de HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRICE, Matthew John | Director | Riverside Road NR33 0SW Lowestoft Trinity House England | United Kingdom | British | 242597980001 | |||||
| ALDCROFT, Christopher Stuart | Secretario | 2 Thorn Lea Close BL1 5BE Bolton Lancashire | British | 63420360001 | ||||||
| BANKES, Henry Francis John | Secretario | 5-17 Hammersmith Grove W6 0LG London The Triangle United Kingdom | British | 102155820002 | ||||||
| BANKES, Henry Francis John | Secretario | 67 Blenheim Terrace NW8 0EJ London | British | 102155820001 | ||||||
| BANNISTER, Christopher Keith | Secretario | 535 Watford Road Chiswell Green AL2 3DU St. Albans Hertfordshire | British | 63470060001 | ||||||
| GIDLEY, Peter Robert | Secretario | Post Cottage 12 Wakerley Road NN17 3AH Harringworth Northamptonshire | British | 36431140002 | ||||||
| GOSTLING, Bryan Richard | Secretario | 18 Bircham Road Reepham NR10 4NQ Norwich Norfolk | British | 51954690001 | ||||||
| MCGOOKIN, Ann Elizabeth | Secretario | 9 Stamford Drive Whittle Le Woods PR6 7HP Chorley Lancashire | British | 67893790001 | ||||||
| NASTA, Marius Ion | Secretario | 44 Wynnstay Gardens Allen Street W8 6UT London | Belgian | 50087790005 | ||||||
| NASTA, Marius Ion | Secretario | 44 Wynnstay Gardens Allen Street W8 6UT London | Belgian | 50087790005 | ||||||
| PARKINSON, Ian | Secretario | 17 Fallowfield Avenue LA12 7XD Ulverston Cumbria | British | 72230040001 | ||||||
| PARRY, John Martin | Secretario | 4 The Coppice Middleton LS29 0EZ Ilkley West Yorkshire | British | 91431530001 | ||||||
| ADAM, Garry Clark | Director | Raglan Road NR32 2LW Lowestoft Sunway House England | England | British | 150460730002 | |||||
| ADAM, Garry | Director | The Pickerings Brixworth NN6 9XA Northampton 12 Northamptonshire United Kingdom | British | 135966620001 | ||||||
| AILLES, Ian Simon | Director | Beaumont Avenue AL1 4TP St. Albans 84 Hertfordshire | England | British | 128695490001 | |||||
| ALDCROFT, Christopher Stuart | Director | 2 Thorn Lea Close BL1 5BE Bolton Lancashire | British | 63420360001 | ||||||
| ALLAN, Leslie Stewart | Director | 78 Honor Oak Road SE23 3RR London | British | 1704690001 | ||||||
| BACK, Jonathan David | Director | Darland Hall Farm House Darland Lane, Rossett LL12 0BA Wrexham Clwyd | Wales | British | 113705840001 | |||||
| BANKES, Henry Francis John | Director | Earby BB94 0AA Barnoldswick Spring Mill Lancashire | United Kingdom | British | 102155820004 | |||||
| BARTON, Eric Anthony | Director | Glendale 9 Harebell Hill KT11 2RS Cobham Surrey | England | British | 1323220001 | |||||
| BRENNAN, William Joseph | Director | 28 Priory Road Kew TW9 3DH London | United States | 97989400002 | ||||||
| BRETT, Paul | Director | 2 Brookside Road NW11 9NE London | United Kingdom | British | 68902240001 | |||||
| CHAPPELOW, Peter Raymond | Director | Settlebeck 109 Curly Hill LS29 0DT Ilkley West Yorkshire | England | British | 71153170002 | |||||
| COWLEY, Geoffrey John | Director | Barnoldswick BB94 0AA Earby Spring Mill Lancashire England | United Kingdom | British | 45049290004 | |||||
| DEUTSCH, Franz Markus | Director | Academy Gardens Apartment 21 Duchess Of Bedfords Walk W8 7QQ London | British | 78643290004 | ||||||
| FORBES, Scott Edward | Director | Flat 1 44 Cranley Gardens SW7 3DE London | England | British | 106973270001 | |||||
| FOSTER, Stephen Albert | Director | The Lymes 295 Gisburn Road BB9 6AW Barrowford Lancashire | United Kingdom | British | 94033560001 | |||||
| FRITH, Michael | Director | Upper Bennetts Penn Road Knotty Green HP9 2TS Beaconsfield Buckinghamshire | British | 16669400001 | ||||||
| GIAMALVA, Frank Peter | Director | 46 Cheval Place SW7 1ER London | American | 104404420003 | ||||||
| GIDLEY, Peter Robert | Director | Copy Nook Lothersdale BD20 8EQ Keighley West Yorkshire | England | British | 36431140004 | |||||
| HUGHES, Andrew Lawrence | Director | 7 Brooke Close LE15 6GD Oakham Leicestershire | England | British | 109749210001 | |||||
| HUSSAIN, Sadat | Director | Earby BB94 0AA Barnoldswick Spring Mill Lancashire England | England | British | 176593840001 | |||||
| KJELLBERG, Henrik Vilhelm | Director | Raglan Road NR32 2LW Lowestoft Sunway House England | United Kingdom | Swedish | 244090880001 | |||||
| LEE, John Robert Louis, Lord Lee Of Trafford | Director | 49 Langham Road Bowdon WA14 3NS Altrincham Cheshire | British | 2950910001 | ||||||
| LEPPARD, Martin Neal | Director | Claverdon Manor Manor Lane CV35 8NH Claverdon Warwickshire | England | British | 155863600001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Awaze Limited | 29 sept 2023 | Bishopsgate EC2M 4RB London 280 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Compass Bidco Ii Limited | 09 may 2018 | New Bridge Street EC4V 6JA London 100 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Wyndham Destination Network Europe Limited | 06 abr 2016 | Hammersmith Grove W6 0LG London The Triangle England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0