HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED

HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHOSEASONS HOLIDAYS LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01400552
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Trinity House
    Riverside Road
    NR33 0SW Lowestoft
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    THE HOSEASONS GROUP HOLDINGS LIMITED30 jun 201130 jun 2011
    THE HOSEASONS GROUP LIMITED09 jun 201009 jun 2010
    HOLIDAY COTTAGES GROUP LIMITED15 feb 199615 feb 1996
    COUNTRY HOLIDAYS LIMITED27 feb 198727 feb 1987
    COUNTRY HOLIDAYS (SKIPTON) LIMITED17 nov 197817 nov 1978

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2025
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta08 feb 2026
    Próxima declaración de confirmación vence22 feb 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta08 feb 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2024

    17 páginasAA

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    legacy

    116 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Cese del nombramiento de Garry Clark Adam como director el 30 jul 2025

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Trinity House Waveney Drive Lowestoft NR33 0SW England a Trinity House Riverside Road Lowestoft NR33 0SW el 08 jul 2025

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de Sunway House Raglan Road Lowestoft NR32 2LW England a Trinity House Waveney Drive Lowestoft NR33 0SW el 01 jul 2025

    1 páginasAD01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de The Triangle 5 - 17 Hammersmith Grove Hammersmith London W6 0LG England a Aviation House 125 Kingsway London WC2B 6NH

    1 páginasAD02

    Declaración de confirmación presentada el 08 feb 2025 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Matthew John Price como director el 07 feb 2025

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Henrik Vilhelm Kjellberg como director el 07 feb 2025

    1 páginasTM01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2023

    18 páginasAA

    legacy

    118 páginasPARENT_ACC

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 25 mar 2024

    • Capital: GBP 17,039,334
    3 páginasSH01

    Declaración de confirmación presentada el 08 feb 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Notification de Awaze Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 sept 2023

    2 páginasPSC02

    Cessation de Compass Bidco Ii Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 sept 2023

    1 páginasPSC07

    Comptes annuels modifiés établis au 31 dic 2022

    22 páginasAAMD

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022

    22 páginasAA

    Estado de capital el 19 abr 2023

    • Capital: GBP 15,030,010
    5 páginasSH19

    ¿Quiénes son los directivos de HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PRICE, Matthew John
    Riverside Road
    NR33 0SW Lowestoft
    Trinity House
    England
    Director
    Riverside Road
    NR33 0SW Lowestoft
    Trinity House
    England
    United KingdomBritish242597980001
    ALDCROFT, Christopher Stuart
    2 Thorn Lea Close
    BL1 5BE Bolton
    Lancashire
    Secretario
    2 Thorn Lea Close
    BL1 5BE Bolton
    Lancashire
    British63420360001
    BANKES, Henry Francis John
    5-17 Hammersmith Grove
    W6 0LG London
    The Triangle
    United Kingdom
    Secretario
    5-17 Hammersmith Grove
    W6 0LG London
    The Triangle
    United Kingdom
    British102155820002
    BANKES, Henry Francis John
    67 Blenheim Terrace
    NW8 0EJ London
    Secretario
    67 Blenheim Terrace
    NW8 0EJ London
    British102155820001
    BANNISTER, Christopher Keith
    535 Watford Road
    Chiswell Green
    AL2 3DU St. Albans
    Hertfordshire
    Secretario
    535 Watford Road
    Chiswell Green
    AL2 3DU St. Albans
    Hertfordshire
    British63470060001
    GIDLEY, Peter Robert
    Post Cottage
    12 Wakerley Road
    NN17 3AH Harringworth
    Northamptonshire
    Secretario
    Post Cottage
    12 Wakerley Road
    NN17 3AH Harringworth
    Northamptonshire
    British36431140002
    GOSTLING, Bryan Richard
    18 Bircham Road
    Reepham
    NR10 4NQ Norwich
    Norfolk
    Secretario
    18 Bircham Road
    Reepham
    NR10 4NQ Norwich
    Norfolk
    British51954690001
    MCGOOKIN, Ann Elizabeth
    9 Stamford Drive
    Whittle Le Woods
    PR6 7HP Chorley
    Lancashire
    Secretario
    9 Stamford Drive
    Whittle Le Woods
    PR6 7HP Chorley
    Lancashire
    British67893790001
    NASTA, Marius Ion
    44 Wynnstay Gardens
    Allen Street
    W8 6UT London
    Secretario
    44 Wynnstay Gardens
    Allen Street
    W8 6UT London
    Belgian50087790005
    NASTA, Marius Ion
    44 Wynnstay Gardens
    Allen Street
    W8 6UT London
    Secretario
    44 Wynnstay Gardens
    Allen Street
    W8 6UT London
    Belgian50087790005
    PARKINSON, Ian
    17 Fallowfield Avenue
    LA12 7XD Ulverston
    Cumbria
    Secretario
    17 Fallowfield Avenue
    LA12 7XD Ulverston
    Cumbria
    British72230040001
    PARRY, John Martin
    4 The Coppice
    Middleton
    LS29 0EZ Ilkley
    West Yorkshire
    Secretario
    4 The Coppice
    Middleton
    LS29 0EZ Ilkley
    West Yorkshire
    British91431530001
    ADAM, Garry Clark
    Raglan Road
    NR32 2LW Lowestoft
    Sunway House
    England
    Director
    Raglan Road
    NR32 2LW Lowestoft
    Sunway House
    England
    EnglandBritish150460730002
    ADAM, Garry
    The Pickerings
    Brixworth
    NN6 9XA Northampton
    12
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Director
    The Pickerings
    Brixworth
    NN6 9XA Northampton
    12
    Northamptonshire
    United Kingdom
    British135966620001
    AILLES, Ian Simon
    Beaumont Avenue
    AL1 4TP St. Albans
    84
    Hertfordshire
    Director
    Beaumont Avenue
    AL1 4TP St. Albans
    84
    Hertfordshire
    EnglandBritish128695490001
    ALDCROFT, Christopher Stuart
    2 Thorn Lea Close
    BL1 5BE Bolton
    Lancashire
    Director
    2 Thorn Lea Close
    BL1 5BE Bolton
    Lancashire
    British63420360001
    ALLAN, Leslie Stewart
    78 Honor Oak Road
    SE23 3RR London
    Director
    78 Honor Oak Road
    SE23 3RR London
    British1704690001
    BACK, Jonathan David
    Darland Hall Farm House
    Darland Lane, Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    Clwyd
    Director
    Darland Hall Farm House
    Darland Lane, Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    Clwyd
    WalesBritish113705840001
    BANKES, Henry Francis John
    Earby
    BB94 0AA Barnoldswick
    Spring Mill
    Lancashire
    Director
    Earby
    BB94 0AA Barnoldswick
    Spring Mill
    Lancashire
    United KingdomBritish102155820004
    BARTON, Eric Anthony
    Glendale 9 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    Director
    Glendale 9 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    EnglandBritish1323220001
    BRENNAN, William Joseph
    28 Priory Road
    Kew
    TW9 3DH London
    Director
    28 Priory Road
    Kew
    TW9 3DH London
    United States97989400002
    BRETT, Paul
    2 Brookside Road
    NW11 9NE London
    Director
    2 Brookside Road
    NW11 9NE London
    United KingdomBritish68902240001
    CHAPPELOW, Peter Raymond
    Settlebeck 109 Curly Hill
    LS29 0DT Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    Settlebeck 109 Curly Hill
    LS29 0DT Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish71153170002
    COWLEY, Geoffrey John
    Barnoldswick
    BB94 0AA Earby
    Spring Mill
    Lancashire
    England
    Director
    Barnoldswick
    BB94 0AA Earby
    Spring Mill
    Lancashire
    England
    United KingdomBritish45049290004
    DEUTSCH, Franz Markus
    Academy Gardens Apartment 21
    Duchess Of Bedfords Walk
    W8 7QQ London
    Director
    Academy Gardens Apartment 21
    Duchess Of Bedfords Walk
    W8 7QQ London
    British78643290004
    FORBES, Scott Edward
    Flat 1
    44 Cranley Gardens
    SW7 3DE London
    Director
    Flat 1
    44 Cranley Gardens
    SW7 3DE London
    EnglandBritish106973270001
    FOSTER, Stephen Albert
    The Lymes
    295 Gisburn Road
    BB9 6AW Barrowford
    Lancashire
    Director
    The Lymes
    295 Gisburn Road
    BB9 6AW Barrowford
    Lancashire
    United KingdomBritish94033560001
    FRITH, Michael
    Upper Bennetts
    Penn Road Knotty Green
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Upper Bennetts
    Penn Road Knotty Green
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British16669400001
    GIAMALVA, Frank Peter
    46 Cheval Place
    SW7 1ER London
    Director
    46 Cheval Place
    SW7 1ER London
    American104404420003
    GIDLEY, Peter Robert
    Copy Nook
    Lothersdale
    BD20 8EQ Keighley
    West Yorkshire
    Director
    Copy Nook
    Lothersdale
    BD20 8EQ Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritish36431140004
    HUGHES, Andrew Lawrence
    7 Brooke Close
    LE15 6GD Oakham
    Leicestershire
    Director
    7 Brooke Close
    LE15 6GD Oakham
    Leicestershire
    EnglandBritish109749210001
    HUSSAIN, Sadat
    Earby
    BB94 0AA Barnoldswick
    Spring Mill
    Lancashire
    England
    Director
    Earby
    BB94 0AA Barnoldswick
    Spring Mill
    Lancashire
    England
    EnglandBritish176593840001
    KJELLBERG, Henrik Vilhelm
    Raglan Road
    NR32 2LW Lowestoft
    Sunway House
    England
    Director
    Raglan Road
    NR32 2LW Lowestoft
    Sunway House
    England
    United KingdomSwedish244090880001
    LEE, John Robert Louis, Lord Lee Of Trafford
    49 Langham Road
    Bowdon
    WA14 3NS Altrincham
    Cheshire
    Director
    49 Langham Road
    Bowdon
    WA14 3NS Altrincham
    Cheshire
    British2950910001
    LEPPARD, Martin Neal
    Claverdon Manor
    Manor Lane
    CV35 8NH Claverdon
    Warwickshire
    Director
    Claverdon Manor
    Manor Lane
    CV35 8NH Claverdon
    Warwickshire
    EnglandBritish155863600001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Awaze Limited
    Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    280
    England
    29 sept 2023
    Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    280
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroUk Companies House
    Número de registro11184954
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    England
    09 may 2018
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    England
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUk
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro11188307
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Hammersmith Grove
    W6 0LG London
    The Triangle
    England
    06 abr 2016
    Hammersmith Grove
    W6 0LG London
    The Triangle
    England
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro07149144
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0