PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED

PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01401160
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED?

    • construcción de barcos y estructuras flotantes (30110) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    32 Threadneedle Street
    EC2R 8AY London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SLINGSBY ENGINEERING LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    BUSTINO INVESTMENTS LIMITED22 nov 197822 nov 1978

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Nombramiento de Burness Paull Llp como secretario el 19 ago 2013

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Paull & Williamsons Llp como secretario el 19 ago 2013

    1 páginasTM02

    Nombramiento de James Lawrence Mcculloch como secretario el 19 ago 2013

    2 páginasAP03

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Hazel Hunter como secretario el 26 abr 2013

    1 páginasTM02

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS16(SOAS)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Domicilio social registrado cambiado de One London Wall London EC2Y 5AB el 11 sept 2012

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 20 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 sept 2012

    Estado de capital el 04 sept 2012

    • Capital: GBP 2,695,347
    SH01

    legacy

    5 páginasMG01

    Cambio de datos del director Mr James Whelan Harris el 11 nov 2011

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Hazel Hunter como secretario el 01 dic 2011

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Paull & Williamsons Llp como secretario el 11 nov 2011

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de un director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Euan Alexander Edmondston Leask como secretario el 30 sept 2011

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Jarrod Stephen Marsden como secretario el 11 nov 2011

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Maclay Murray & Spens Llp como secretario el 11 nov 2011

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 20 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Mr Euan Alexander Edmondston Leask el 19 jun 2011

    2 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Euan Alexander Edmondston Leask el 19 jun 2011

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Maclay Murray & Spens Llp el 29 mar 2011

    2 páginasCH04

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    25 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MCCULLOCH, James Lawrence
    920 Memorial City Way
    Suite 1000
    TX 770224 Houston
    Forum Energy Technologies Inc.
    Texas
    Usa
    Secretario
    920 Memorial City Way
    Suite 1000
    TX 770224 Houston
    Forum Energy Technologies Inc.
    Texas
    Usa
    180949830001
    BURNESS PAULL LLP
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    Forma jurídicaLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Tipo de identificaciónNo EEE
    Autoridad legalSCOTLAND, SCOTS LAW
    Número de registroSO300380
    99448920005
    HARRIS, James Whelan
    (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Union Plaza
    Scotland
    Director
    (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Union Plaza
    Scotland
    United StatesAmericanCfo159701740001
    TAYLOR, Kevin
    Ings Lane
    YO62 6EZ Kirkbymoorside
    Perry Slingsby Systems Limited
    York
    United Kingdom
    Director
    Ings Lane
    YO62 6EZ Kirkbymoorside
    Perry Slingsby Systems Limited
    York
    United Kingdom
    BritishGeneral Manager74777230002
    BERRY, David William
    Derwent House 137 Scarborough Road
    Norton
    YO17 8AD Malton
    North Yorkshire
    Secretario
    Derwent House 137 Scarborough Road
    Norton
    YO17 8AD Malton
    North Yorkshire
    BritishAccountant1415970002
    COOPER, Simon Astley
    The Grey Horse Great Edstone
    YO62 6PD York
    Secretario
    The Grey Horse Great Edstone
    YO62 6PD York
    British6172510002
    COOPER, Simon Astley
    30 Knapton Close
    Strensall
    YO3 5ZF York
    North Yorkshire
    Secretario
    30 Knapton Close
    Strensall
    YO3 5ZF York
    North Yorkshire
    British6172510001
    CORRAY, Pamela Jane
    146 Hamilton Place
    AB15 5BB Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secretario
    146 Hamilton Place
    AB15 5BB Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishAccountant83551930001
    FRENCH, Wayne Ian
    3 Oakfields
    Allbrook
    SO50 4RP Eastleigh
    Hampshire
    Secretario
    3 Oakfields
    Allbrook
    SO50 4RP Eastleigh
    Hampshire
    BritishFinance Director104188800001
    HUNTER, Hazel
    Woodburn Road
    Blackburn
    AB21 0PS Aberdeen
    Forum Energy Technologies (Uk) Limited
    Scotland
    Secretario
    Woodburn Road
    Blackburn
    AB21 0PS Aberdeen
    Forum Energy Technologies (Uk) Limited
    Scotland
    165470940001
    LEASK, Euan Alexander Edmondston
    Woodburn Road
    Blackburn
    AB21 OPS Aberdeen
    Tgh (Uk) Limited
    United Kingdom
    Secretario
    Woodburn Road
    Blackburn
    AB21 OPS Aberdeen
    Tgh (Uk) Limited
    United Kingdom
    BritishAccountant129769730001
    LOVERIDGE, James Douglas
    10 Redding Drive
    HP6 5PX Amersham
    Buckinghamshire
    Secretario
    10 Redding Drive
    HP6 5PX Amersham
    Buckinghamshire
    British2641580001
    MARSDEN, Jarrod Stephen
    Ings Lane
    YO62 6EZ Kirkbymoorside
    Perry Slingsby Systems Limited
    York
    United Kingdom
    Secretario
    Ings Lane
    YO62 6EZ Kirkbymoorside
    Perry Slingsby Systems Limited
    York
    United Kingdom
    British68707320003
    MONTEL, Aline
    44 Rue Didot
    75014 Paris
    France
    Secretario
    44 Rue Didot
    75014 Paris
    France
    FrenchLegal Counsel44495200001
    PIRIE, William Allan
    Skene
    AB32 6RP Westhill
    Sunnybrae House
    Aberdeenshire
    Secretario
    Skene
    AB32 6RP Westhill
    Sunnybrae House
    Aberdeenshire
    British139601340001
    WALTERS, Logan
    5534 Schumacher
    Houston
    Texas 77056
    Usa
    Secretario
    5534 Schumacher
    Houston
    Texas 77056
    Usa
    British124901190001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    United Kingdom
    Secretario designado corporativo
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    United Kingdom
    900003400001
    PAULL & WILLIAMSONS LLP
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    6th Floor Union Plaza
    Scotland
    Secretario corporativo
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    6th Floor Union Plaza
    Scotland
    Forma jurídicaLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Tipo de identificaciónNo EEE
    Autoridad legalCOMPANIES ACT 2006
    Número de registroSO302228
    137701650001
    ADDIS, Robert Campbell
    57 Schoolhill
    AB41 9AJ Ellon
    Aberdeenshire
    Director
    57 Schoolhill
    AB41 9AJ Ellon
    Aberdeenshire
    BritishManaging Director60172730003
    ANDERSON, Martin Taylor
    Sambaiba
    Kinstair Farm
    AB33 8HL Alford
    Aberdeenshire
    Director
    Sambaiba
    Kinstair Farm
    AB33 8HL Alford
    Aberdeenshire
    United KingdomBritishDirector151543830001
    BERRY, David William
    Derwent House 137 Scarborough Road
    Norton
    YO17 8AD Malton
    North Yorkshire
    Director
    Derwent House 137 Scarborough Road
    Norton
    YO17 8AD Malton
    North Yorkshire
    BritishFinancial Director1415970002
    BOE, Knut
    Nesaasen 18b
    Nesbru
    1394
    Norway
    Director
    Nesaasen 18b
    Nesbru
    1394
    Norway
    NorwayNorwegianExecutive Vice President Surf84068980001
    BRYSON, John Macdonald
    Edgton Little Tangley
    Wonersh
    GU5 0PW Guildford
    Surrey
    Director
    Edgton Little Tangley
    Wonersh
    GU5 0PW Guildford
    Surrey
    BritishGroup Finance Director10076550001
    CASSIE, David
    32 Westholme Avenue
    AB15 6AB Aberdeen
    Director
    32 Westholme Avenue
    AB15 6AB Aberdeen
    ScotlandBritishManaging Director50942380001
    CLARK, Robin Hartley Ledgerd
    Glebe Cottage
    Rockbourne
    SP6 3NA Fordingbridge
    Hampshire
    Director
    Glebe Cottage
    Rockbourne
    SP6 3NA Fordingbridge
    Hampshire
    BritishManaging Director73934900001
    COOPER, Simon Astley
    30 Knapton Close
    Strensall
    YO3 5ZF York
    North Yorkshire
    Director
    30 Knapton Close
    Strensall
    YO3 5ZF York
    North Yorkshire
    BritishChartered Engineer6172510001
    CORRAY, Pamela Jane
    146 Hamilton Place
    AB15 5BB Aberdeen
    Aberdeenshire
    Director
    146 Hamilton Place
    AB15 5BB Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishFinance Director83551930001
    COYARD, Ivan Roland
    Tour Technip-Coflexip
    La Defense 6 170 Place Henri
    Regnault Paris La Defense
    92973
    France
    Director
    Tour Technip-Coflexip
    La Defense 6 170 Place Henri
    Regnault Paris La Defense
    92973
    France
    FrenchController Offshore Branch84562970001
    DELMOTTE, Alain-Hugues
    2 Avenue Lenotre
    78160 Marly Le Roi
    Paris
    France
    Director
    2 Avenue Lenotre
    78160 Marly Le Roi
    Paris
    France
    FranceFrenchFinance Controller Offshore Br116419150001
    FABY, Michael Joseph
    139 Fairview West
    33469 Tequesta
    Florida
    Usa
    Director
    139 Fairview West
    33469 Tequesta
    Florida
    Usa
    AmericanChief Financial Officer Pssi59698200002
    FRENCH, Wayne Ian
    3 Oakfields
    Allbrook
    SO50 4RP Eastleigh
    Hampshire
    Director
    3 Oakfields
    Allbrook
    SO50 4RP Eastleigh
    Hampshire
    United KingdomBritishAccountant104188800001
    LANNON-DECLERCQ, Christine
    44 Rue Du Commerce
    FOREIGN Paris
    75015
    France
    Director
    44 Rue Du Commerce
    FOREIGN Paris
    75015
    France
    FrenchGroup Controller70700980001
    LEASK, Euan Alexander Edmondston
    Woodburn Road
    Blackburn
    AB21 OPS Aberdeen
    Tgh (Uk) Limited
    United Kingdom
    Director
    Woodburn Road
    Blackburn
    AB21 OPS Aberdeen
    Tgh (Uk) Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer129769730001
    LEATT, Allen Frederick
    1 Allee Zenaga
    Vaucresson
    92420
    France
    Director
    1 Allee Zenaga
    Vaucresson
    92420
    France
    BritishChief Executive Officer58322980005
    LOVERIDGE, James Douglas
    10 Redding Drive
    HP6 5PX Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    10 Redding Drive
    HP6 5PX Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishSolicitor2641580001

    ¿Tiene PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 29 ago 2012
    Entregado el 31 ago 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 31 ago 2012Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 02 feb 2007
    Entregado el 09 feb 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and for and on Behalf of Thefinance Parties
    Transacciones
    • 09 feb 2007Registro de un cargo (395)
    • 07 ago 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee and debenture
    Creado el 07 ago 1992
    Entregado el 17 ago 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 ago 1992Registro de un cargo (395)
    • 07 abr 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 25 ene 1985
    Entregado el 06 feb 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land at ingslane, kirbymoorside, north yorkshire.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 feb 1985Registro de una carga
    • 05 ago 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 25 ene 1985
    Entregado el 06 feb 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 feb 1985Registro de una carga
    • 05 ago 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 12 mar 1984
    Entregado el 20 mar 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All book debts and other debts present and future.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 20 mar 1984Registro de una carga
    • 04 oct 1988Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0