O I E SERVICES LIMITED

O I E SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaO I E SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01418001
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de O I E SERVICES LIMITED?

    • Otras actividades de ingeniería (71129) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
    • Otras actividades de las agencias de colocación (78109) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra O I E SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    361-366 Buckingham Avenue
    SL1 4LU Slough
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de O I E SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    OPTIMA INTEGRATED ENERGY SERVICES LIMITED07 dic 200107 dic 2001
    INTEGRATED ENERGY SERVICES LIMITED24 oct 200124 oct 2001
    DIETSMANN MORGAN MOORE LIMITED31 dic 199831 dic 1998
    DIETSMANN (U.K.) LIMITED01 sept 198201 sept 1982
    MAC FELLOW LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    METVENUS LIMITED08 may 197908 may 1979

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de O I E SERVICES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 jul 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para O I E SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    3 páginasSH20

    Estado de capital el 23 abr 2019

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    3 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 19 ene 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2017

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 19 ene 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Bond Dickinson Llp St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX England a 361-366 Buckingham Avenue Slough SL1 4LU el 19 ene 2018

    1 páginasAD01

    Cambio de datos del secretario Mr Murray Jamieson Crane el 15 dic 2017

    1 páginasCH03

    Cese del nombramiento de Adam Powell como secretario el 15 dic 2017

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Murray Jamieson Crane como secretario el 15 dic 2017

    2 páginasAP03

    Nombramiento de John Ritchie Morrison como director el 15 jun 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Florin Ianul como director el 15 jun 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2016

    17 páginasAA

    Nombramiento de Florin Ianul como director el 31 mar 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Adam David Powell como director el 31 mar 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Richard John Paddison como director el 31 mar 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 12 ene 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    23 páginasAA

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Resoluciones

    Resolutions
    10 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    ¿Quiénes son los directivos de O I E SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CARNE, Murray Jamieson
    Centurion Court
    North Esplanade West
    AB11 5QH Aberdeen
    Centurion Court
    Scotland
    Secretario
    Centurion Court
    North Esplanade West
    AB11 5QH Aberdeen
    Centurion Court
    Scotland
    241237780002
    DONATIELLO, John
    c/o John Crane Group Corporation
    W. Monroe Street
    Chicago
    227
    Il 60606
    United States
    Director
    c/o John Crane Group Corporation
    W. Monroe Street
    Chicago
    227
    Il 60606
    United States
    United StatesAmerican202354100001
    MORRISON, John Ritchie
    North Esplanade West
    AB11 5QH Aberdeen
    Centurion Court
    United Kingdom
    Director
    North Esplanade West
    AB11 5QH Aberdeen
    Centurion Court
    United Kingdom
    United KingdomBritish236416530001
    POWELL, Adam David
    Buckingham Avenue
    SL1 4LU Slough
    361-366
    England
    Director
    Buckingham Avenue
    SL1 4LU Slough
    361-366
    England
    United KingdomBritish229623250001
    DAWSON, Anthony Robert
    Huntington
    Upper Ickneild Way Whiteleaf
    HP27 0LL Princes Risborough Aylesbury
    Bucks
    Secretario
    Huntington
    Upper Ickneild Way Whiteleaf
    HP27 0LL Princes Risborough Aylesbury
    Bucks
    British16917220001
    KROMBEEN, Leendert
    2 Fernbank
    CM12 9XH Billericay
    Essex
    Secretario
    2 Fernbank
    CM12 9XH Billericay
    Essex
    British7875650001
    POWELL, Adam
    c/o Bond Dickinson Llp
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    Secretario
    c/o Bond Dickinson Llp
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    202356300001
    PAULL & WILLIAMSONS
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Secretario corporativo
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    24280001
    PETERKINS SERVICES LIMITED
    Union Street
    AB10 1QR Aberdeen
    100
    Scotland
    Secretario corporativo
    Union Street
    AB10 1QR Aberdeen
    100
    Scotland
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroSC184957
    154002830001
    BUCHANAN, George
    Mill Of Mondynes
    Fordoun
    AB30 1LB Laurencekirk
    Kincardineshire
    Director
    Mill Of Mondynes
    Fordoun
    AB30 1LB Laurencekirk
    Kincardineshire
    ScotlandBritish44846630001
    CAVANAGH, Mark James
    Rubislaw Den South
    AB15 4BB Aberdeen
    32
    Scotland
    Director
    Rubislaw Den South
    AB15 4BB Aberdeen
    32
    Scotland
    United KingdomBritish43031460003
    CAVANAGH, Victoria
    Rubislaw Den South
    AB15 4BB Aberdeen
    32
    Scotland
    Director
    Rubislaw Den South
    AB15 4BB Aberdeen
    32
    Scotland
    ScotlandBritish159055800001
    DAWSON, Anthony Robert
    Huntington
    Upper Ickneild Way Whiteleaf
    HP27 0LL Princes Risborough Aylesbury
    Bucks
    Director
    Huntington
    Upper Ickneild Way Whiteleaf
    HP27 0LL Princes Risborough Aylesbury
    Bucks
    EnglandBritish16917220001
    DELPECH, Pierre
    18 Chemin D'Orange
    13100 Aix En Provence
    Marsielle
    France
    Director
    18 Chemin D'Orange
    13100 Aix En Provence
    Marsielle
    France
    French75213150001
    IANUL, Florin
    c/o Bond Dickinson Llp
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    Director
    c/o Bond Dickinson Llp
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    RomaniaRomanian229632930001
    KUTEMANN, Peter Renhart Gunnar
    3 Avenue Princess Grace
    FOREIGN Monaco 98000
    Director
    3 Avenue Princess Grace
    FOREIGN Monaco 98000
    Dutch40690770002
    MAIN, Michael Robert
    2 Kirkton Road
    Westhill
    AB32 6LF Aberdeen
    Aberdeenshire
    Director
    2 Kirkton Road
    Westhill
    AB32 6LF Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish109530520001
    PADDISON, Richard John
    c/o Bond Dickinson Llp
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    Director
    c/o Bond Dickinson Llp
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    EnglandBritish63501590001
    RICHMOND, Robert Campbell Connor
    29 Burns Road
    AB15 4NT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Director
    29 Burns Road
    AB15 4NT Aberdeen
    Aberdeenshire
    British1009910001
    THAIN, Walter
    26 S Riverside View
    Riverside Drive
    AB11 7DF Aberdeen
    Director
    26 S Riverside View
    Riverside Drive
    AB11 7DF Aberdeen
    British78371700001
    VAN DEN BERGE, Johan Herman Bernhard
    Oude Galgenstraat 132
    Kapellen
    2950
    Belgium
    Director
    Oude Galgenstraat 132
    Kapellen
    2950
    Belgium
    Dutch75269810001
    VELTMAN, Willem Jan Petrus
    Casa Capricornio
    Valle Hermoso
    Al Havrin El Grande
    Apartado 36
    Espana
    Director
    Casa Capricornio
    Valle Hermoso
    Al Havrin El Grande
    Apartado 36
    Espana
    Dutch25005180001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de O I E SERVICES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    John Crane Group Ltd
    Buckingham Avenue
    SL1 4LU Slough
    Buckingham House
    England
    06 abr 2016
    Buckingham Avenue
    SL1 4LU Slough
    Buckingham House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House Cardiff
    Número de registro05137825
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene O I E SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 07 may 2015
    Entregado el 11 may 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 11 may 2015Registro de una carga (MR01)
    • 17 ago 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creado el 17 dic 2004
    Entregado el 22 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transacciones
    • 22 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 17 ago 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Fixed charge on purchase debts and floating charge on bank proceeds of debts
    Creado el 08 oct 2001
    Entregado el 12 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the invoice discounting agreement or otherwise
    Breve descripción
    By way of fixed equitable charge (1) all receivables purchased or purported to be purchased by the security holder from the company pursuant to a discounting agreement between the security holder and the company which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason (2) all other debts of the company and (3) the benefit of all guarantees indemnities, instruments and securities given to or held by the company in relation to any such receivable or other debt and the right to other records and documents on or by which any such receivable or other debt is recorded or evidenced 3 (1) fixed equitable charge all purchased debts and the other debts etc (2) floating charge such of the monies received etc.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transacciones
    • 12 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 17 ago 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge
    Creado el 04 oct 2001
    Entregado el 18 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from searosa limited to the chargee and dietsmann holding (cyprus) limited under the terms of a loan and security agreement of even date
    Breve descripción
    The whole property (including uncalled capital) property and undertaking of the company.
    Personas con derecho
    • Dietsmann N.V.
    Transacciones
    • 18 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 17 ago 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Letter of offset.
    Creado el 24 abr 1992
    Entregado el 11 may 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from linbide (G.B.)limited /and or dietsmann management services limited on any account whatsoever.
    Breve descripción
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of the bank of scotland in the name of dietsmann (U.K.) limited.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland .
    Transacciones
    • 11 may 1992Registro de un cargo (395)
    • 16 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignation of contract monies
    Creado el 05 oct 1990
    Entregado el 16 oct 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All rights arising from contract no. C/45985/89/AO2 for ship manning of the msv stadive between shell UK limited (shell UK exploration and production) & dietsmann (UK) limited.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 16 oct 1990Registro de una carga
    • 16 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture containing fixed and floating charge
    Creado el 12 sept 1990
    Entregado el 21 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 21 sept 1990Registro de una carga
    • 16 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of. Offset
    Creado el 06 ago 1990
    Entregado el 27 ago 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from dietsmann management systems limitedunder the terms of the charge.
    Breve descripción
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in name of dietsmann (UK) LTD.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 27 ago 1990Registro de una carga
    • 16 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of assignment
    Creado el 28 sept 1983
    Entregado el 18 oct 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All monies due to dietsmann (UK) limited under the contract no c/42196/83/OA7 between dietsmann (UK) limited and shell (U.K.) limited.
    Personas con derecho
    • Banque Indosuez.
    Transacciones
    • 18 oct 1983Registro de una carga
    • 12 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene O I E SERVICES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    08 sept 2010Fecha de finalización o terminación del CVA
    27 may 2008Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Steven Mark Draine
    Moore Stephens
    3/5 Rickmansworth Road
    WD18 0GX Watford
    Hertfordshire
    Profesional
    Moore Stephens
    3/5 Rickmansworth Road
    WD18 0GX Watford
    Hertfordshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0