WALLSIDE HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | WALLSIDE HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01418843 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WALLSIDE HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra WALLSIDE HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Courtwood House Silver Street Head S1 2DD Sheffield South Yorkshire United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WALLSIDE HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| FRISKART LIMITED | 10 may 1979 | 10 may 1979 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WALLSIDE HOLDINGS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 ene 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 oct 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 ene 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para WALLSIDE HOLDINGS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 31 dic 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 ene 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 31 dic 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WALLSIDE HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Mr David Dennis Cuby en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 ago 2024 | 2 páginas | PSC04 | ||
Modification des détails de Mr Subash Malkani en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 ago 2024 | 2 páginas | PSC04 | ||
Modification des détails de Mr William Damian Cid De La Paz en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 ago 2024 | 2 páginas | PSC04 | ||
Modification des détails de Mr Maurice Albert Perera en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 ago 2024 | 2 páginas | PSC04 | ||
Modification des détails de Mr David Dennis Cuby en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 ago 2024 | 2 páginas | PSC04 | ||
Cessation de Adrian Gerard Olivero en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 sept 2020 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ene 2025 | 9 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2024 au 31 ene 2025 | 1 páginas | AA01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2023 | 10 páginas | AA | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2022 | 11 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de Warranty House Savile Street East Sheffield South Yorkshire S4 7UQ a Courtwood House Silver Street Head Sheffield South Yorkshire S1 2DD el 28 jul 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Cambio de datos del director Mr David Antcliff el 26 jul 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cessation de James David Hassan en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mar 2022 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2021 | 18 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2020 | 14 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS40 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2019 | 14 páginas | AA | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||
Cese del nombramiento de Paul Nigel Pinkney como director el 08 abr 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de WALLSIDE HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTCLIFF, David | Secretario | Silver Street Head S1 2DD Sheffield Courtwood House South Yorkshire United Kingdom | British | 51305300004 | ||||||
| ANTCLIFF, David | Director | Silver Street Head S1 2DD Sheffield Courtwood House South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 51305300013 | |||||
| BREEN, Martin Gerard | Secretario | Willow Tree Barn Grange Road TN30 6EE Tenterden Kent | British | 101681770001 | ||||||
| HENDERSON, William Richard | Secretario | 32 Harvest Bank Hyde Heath HP6 5RD Amersham Buckinghamshire | British | 68153090001 | ||||||
| IVES, Deborah Ann | Secretario | Chukwani The Friary Old Windsor SL4 2NS Windsor Berkshire | British | 61720060001 | ||||||
| MOORE, Glyn Kerry | Secretario | Longreach 69 Lower Cookham Road SL6 8JY Maidenhead Berkshire | British | 56595670003 | ||||||
| PINKNEY, Paul Nigel | Secretario | 50 Ampthill Road Silsoe MK45 4DX Bedford Bedfordshire | British | 74945960001 | ||||||
| BREEN, Martin Gerard | Director | Willow Tree Barn Grange Road TN30 6EE Tenterden Kent | United Kingdom | British | 101681770001 | |||||
| BRINN, Nigel James | Director | 13 Marlow Mill Mill Road SL7 1QD Marlow Buckinghamshire | British | 56096980003 | ||||||
| HENDERSON, William Richard | Director | 32 Harvest Bank Hyde Heath HP6 5RD Amersham Buckinghamshire | British | 68153090001 | ||||||
| JOHNSON, Neil Anthony | Director | 10 Granard Road Wandsworth Common SW12 8UL London | United Kingdom | British | 62577160002 | |||||
| MILLER, Alastair | Director | 42 Kinghorn Park SL6 7TX Maidenhead Berkshire | British | 68200790001 | ||||||
| MOORE, Glyn Kerry | Director | Longreach 69 Lower Cookham Road SL6 8JY Maidenhead Berkshire | British | 56595670003 | ||||||
| PINKNEY, David Lee | Director | Savile Street East S4 7UQ Sheffield Warranty House South Yorkshire | United Kingdom | British | 59683550003 | |||||
| PINKNEY, Frederick Donald | Director | Savile Street East S4 7UQ Sheffield Warranty House South Yorkshire | England | British | 48779110003 | |||||
| PINKNEY, Paul Nigel | Director | 50 Ampthill Road Silsoe MK45 4DX Bedford Bedfordshire | England | British | 74945960001 | |||||
| ROGERS, Richard Thomas | Director | Shadi 12 The Drive BR4 0EP West Wickham Kent | British | 3041080001 | ||||||
| ROSE, Jeffrey David | Director | I 2 Albany Piccadilly W1J 0AX London | England | British | 81772740001 | |||||
| SPELLINS, Gary Wade | Director | Oak Tree Cottage Hadley Green West EN5 4PP Barnet Hertfordshire | British | 61788120002 | ||||||
| TENNYSON, Simon Jeremy | Director | Cobblers Cottage 74 Slack Lane WF2 7SW New Millerdam Wakefield | United Kingdom | British | 88719960002 | |||||
| WILLIAMS, John Alan | Director | Hanworth Sole Street DA12 3AY Gravesend Kent | British | 3608190001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de WALLSIDE HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr James David Hassan | 06 abr 2016 | 50 Town Range Gibraltar Suites 7b & 8b Gibraltar | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Gibraltar | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Adrian Gerard Olivero | 06 abr 2016 | 50 Town Range Gibraltar Suites 7b & 8b Gibraltar | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Gibraltar | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr David Dennis Cuby | 06 abr 2016 | 32 Line Wall Road GX11 1AA Gibraltar Finsbury House Gibraltar | No |
Nacionalidad: British País de residencia: Gibraltar | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Subash Malkani | 06 abr 2016 | 32 Line Wall Road GX11 1AA Gibraltar Finsbury House Gibraltar | No |
Nacionalidad: British País de residencia: Gibraltar | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Maurice Albert Perera | 06 abr 2016 | 32 Line Wall Road GX11 1AA Gibraltar Finsbury House Gibraltar | No |
Nacionalidad: British País de residencia: Gibraltar | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr William Damian Cid De La Paz | 06 abr 2016 | 32 Line Wall Road GX11 1AA Gibraltar Finsbury House Gibraltar | No |
Nacionalidad: British País de residencia: Gibraltar | |||
Naturaleza del control
| |||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0