KEENPAC LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKEENPAC LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01418926
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KEENPAC LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra KEENPAC LIMITED?

    Dirección de la sede social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KEENPAC LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    KEENPAC POLYTHENE SUPPLIES LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    KEEPAC POLYTHENE SUPPLIES LIMITED10 may 197910 may 1979

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KEENPAC LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KEENPAC LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 25 feb 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Déclaration annuelle établie au 25 feb 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital26 feb 2016

    Estado de capital el 26 feb 2016

    • Capital: GBP 23,776
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 feb 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 mar 2015

    Estado de capital el 04 mar 2015

    • Capital: GBP 23,776
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    2 páginasAA

    Nombramiento de Mr Paul Nicholas Hussey como director el 03 nov 2014

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Brian Michael May como director el 03 nov 2014

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Andrew James Ball como director el 03 nov 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Lindsay Alexander Wilkie como director el 03 nov 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Helen Ruth Cockerham como director el 03 nov 2014

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    10 páginasAA

    Misceláneos

    Section 519
    3 páginasMISC

    Déclaration annuelle établie au 28 feb 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 abr 2014

    Estado de capital el 14 abr 2014

    • Capital: GBP 23,776
    SH01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2012

    11 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 feb 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Andrew Mooney como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nancy Lester como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Helen Ruth Cockerham como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Lindsay Alexander Wilkie como director

    2 páginasAP01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2011

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 feb 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2010

    12 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de KEENPAC LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HUSSEY, Paul Nicholas
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    Secretario
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    British28010290009
    BALL, Andrew James
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    EnglandBritish95118620004
    HUSSEY, Paul Nicholas
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    EnglandBritish28010290009
    MAY, Brian Michael
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    EnglandBritish49698960004
    BRADSHAW, Glynn Laurence
    34 Warren Hill
    Newtown Linford
    LE6 0AL Leicester
    Bedch Tree Cottage
    Leicestershire
    Secretario
    34 Warren Hill
    Newtown Linford
    LE6 0AL Leicester
    Bedch Tree Cottage
    Leicestershire
    British131211250001
    MUIR, David Scott
    29 Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    Secretario
    29 Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    British21883690003
    BRADSHAW, Glynn Laurence
    34 Warren Hill
    Newtown Linford
    LE6 0AL Leicester
    Bedch Tree Cottage
    Leicestershire
    Director
    34 Warren Hill
    Newtown Linford
    LE6 0AL Leicester
    Bedch Tree Cottage
    Leicestershire
    British131211250001
    BUDGE, Charles Paul
    Chandlers
    Lower Ham Lane Elstead
    GU8 6HQ Godalming
    Surrey
    Director
    Chandlers
    Lower Ham Lane Elstead
    GU8 6HQ Godalming
    Surrey
    EnglandBritish49031660003
    COCKERHAM, Helen Ruth
    Centurion Way
    Meridian Business Park
    LE19 1WH Leicester
    Keenpac
    United Kingdom
    Director
    Centurion Way
    Meridian Business Park
    LE19 1WH Leicester
    Keenpac
    United Kingdom
    EnglandBritish172707800001
    CUNNINGHAM, James Alan
    115 Broomwood Road
    SW11 6JU London
    Director
    115 Broomwood Road
    SW11 6JU London
    EnglandBritish51864840002
    JOHNSON, Alexander Kitson
    Lillington Road
    CV32 6LN Leamington Spa
    134
    Warwickshire
    Director
    Lillington Road
    CV32 6LN Leamington Spa
    134
    Warwickshire
    United KingdomEnglish216172110001
    LESTER, Nancy Emma Sophia
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    EnglandBritish67008510002
    LOCKYER, Robert Peter
    26 Elm Tree Road
    Cosby
    LE9 1SR Leicester
    Leicestershire
    Director
    26 Elm Tree Road
    Cosby
    LE9 1SR Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish109919510002
    MOONEY, Andrew John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    United KingdomBritish34345860002
    MUIR, David Scott
    29 Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    Director
    29 Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    UkBritish21883690003
    SLAVIN, Desmond
    259 Markfield Lane
    LE67 9PR Markfield
    Leicestershire
    Director
    259 Markfield Lane
    LE67 9PR Markfield
    Leicestershire
    EnglandBritish45492620001
    THOMPSON, Darren
    9 Eastgate
    Hallaton
    LE16 8UB Market Harborough
    Leicestershire
    Director
    9 Eastgate
    Hallaton
    LE16 8UB Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish109919520001
    WALTERS, Andrew
    Home Farm
    Braybrooke Road
    LE16 8PF Dingley Market Harborough
    Leicestershire
    Director
    Home Farm
    Braybrooke Road
    LE16 8PF Dingley Market Harborough
    Leicestershire
    British118764310001
    WALTERS, Andrew
    Home Farm
    Braybrooke Road
    LE16 8PF Dingley Market Harborough
    Leicestershire
    Director
    Home Farm
    Braybrooke Road
    LE16 8PF Dingley Market Harborough
    Leicestershire
    British118764310001
    WELLS, Anthony Bernard
    28 Forest Rise
    Oadby
    LE2 4FH Leicester
    Director
    28 Forest Rise
    Oadby
    LE2 4FH Leicester
    British44612560001
    WILKIE, Lindsay Alexander
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    United KingdomBritish300728840001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de KEENPAC LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Yorse No. 2 Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    York House
    England
    06 abr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    York House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited By Shares
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene KEENPAC LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Share pledge
    Creado el 21 may 2002
    Entregado el 01 jun 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge the keenpac shares and all its rights, title, interests and benefits in and to the keenpac shares. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in It's Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 01 jun 2002Registro de un cargo (395)
    • 13 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Pledge agreement
    Creado el 21 may 2002
    Entregado el 01 jun 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The whole of the shares (the "shares") in keenpac north america limited , a new york corporation owned by the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 01 jun 2002Registro de un cargo (395)
    • 13 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 21 may 2002
    Entregado el 01 jun 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The freehold property known as plot 28B phase ii meridian business park braunstone blaby leicestershire title number LT299854. The freehold property known as 127 scudamore road leicester title number LT229493. The leasehold property known as 24A meridian business park braunstone blaby leicestershire.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in It's Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 01 jun 2002Registro de un cargo (395)
    • 13 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 may 2002
    Entregado el 01 jun 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in It's Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 01 jun 2002Registro de un cargo (395)
    • 13 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Pledge agreement
    Creado el 12 may 1999
    Entregado el 14 may 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £3,630,000 being the amount of a loan advanced to the company plus a maximum of £5,350,000 due or to become due from the company to the chargee under a multi option facility granted to the company and other companies within its group together with interest and costs for the benefit of the bank which are accepted by the company
    Breve descripción
    The whole of the shares (the "shares") in keenpac france sarl owned by the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 14 may 1999Registro de un cargo (395)
    • 13 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Pledge of quotas to secure own liabilities
    Creado el 12 may 1999
    Entregado el 14 may 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Ordinary quotas to the par value of lit 50,000,000 in keenpac italia S.R.L. plus all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 14 may 1999Registro de un cargo (395)
    • 13 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creado el 10 feb 1999
    Entregado el 03 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The life policy (policy taken by the company over the life of glynn laurence bradshaw in the sum of £1,000,000 with a period of cover 5 years) (the "policy"). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 03 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 13 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creado el 10 feb 1999
    Entregado el 03 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The life policy (policy taken by the company over the life of andrew walters in the sum of £500,000 with a period of cover of 5 years) (the "policy"). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 03 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 13 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage of stocks and shares
    Creado el 10 feb 1999
    Entregado el 03 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    110 common stock shares in keenpac north america limited and 7000 ordinary shares in keenpac hong kong limited (the "securities"). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 03 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 13 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 10 feb 1999
    Entregado el 17 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 16 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 13 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Creado el 10 feb 1999
    Entregado el 17 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    127 scudamore rd,leicestershire; t/no LT229493. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 13 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Creado el 10 feb 1999
    Entregado el 17 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/Hold property known as plot 28 b phase ii meridian business park,braunstone,blaby,leicestershire; t/no LT299854. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 13 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 17 dic 1997
    Entregado el 31 dic 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property k/a plot 28B phase 2 meridian business park braunstone leicester. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 31 dic 1997Registro de un cargo (395)
    • 03 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 25 ene 1995
    Entregado el 27 ene 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee which have been advanced by way of loan credit or for the provision of letters of credit and the like included (but not limited to) advances made by virtue of a credit facility agreement dated 25 january 1995
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Overseas Sales Limited
    • British Markitex Limited
    Transacciones
    • 27 ene 1995Registro de un cargo (395)
    • 16 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 25 ene 1995
    Entregado el 27 ene 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All principal sums at any time advanced to the company by the chargees pursuant to an agreement dated 25 january 1995
    Breve descripción
    All that f/h land and property k/as 127 scudamore road,leicester.t/no.LT229493.
    Personas con derecho
    • Overseas Sales Limited
    • British Markitex LTD
    Transacciones
    • 27 ene 1995Registro de un cargo (395)
    • 16 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge
    Creado el 11 ago 1994
    Entregado el 19 ago 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the debenture dated 25TH july 1994
    Breve descripción
    Fixed charge all right title and interest of the company in or arising out of a factoring or discounting deed dated 11TH february 1994 and all book and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 ago 1994Registro de un cargo (395)
    • 03 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 11 ago 1994
    Entregado el 17 ago 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    127 scudamore road leicester leicestershire title no LT229493.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 ago 1994Registro de un cargo (395)
    • 03 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 25 jul 1994
    Entregado el 02 ago 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 ago 1994Registro de un cargo (395)
    • 03 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 15 abr 1991
    Entregado el 18 abr 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any monies standing to the credit of a designated account with lloyds bank PLC (please see form 395. reg m 519.C.).
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 18 abr 1991Registro de una carga
    • 14 oct 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 11 may 1990
    Entregado el 15 may 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a 127 scudamore road leicester and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 15 may 1990Registro de una carga
    • 14 oct 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge
    Creado el 31 ene 1989
    Entregado el 02 feb 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    First fixed charge on book and other debts present & future & proceeds thereof (see 395 M595C for details).
    Personas con derecho
    • Alex Lawre Receuable Financing Limited
    Transacciones
    • 02 feb 1989Registro de una carga
    • 27 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 07 jul 1988
    Entregado el 19 jul 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Including heritable property & assts in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 19 jul 1988Registro de una carga
    • 22 oct 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 17 ene 1985
    Entregado el 02 feb 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Book debts.
    Personas con derecho
    • H & H Factors Limited
    Transacciones
    • 02 feb 1985Registro de una carga
    • 13 jul 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 01 nov 1983
    Entregado el 08 nov 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all f/hand l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book and other debts.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 08 nov 1983Registro de una carga
    • 13 jul 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 08 jul 1981
    Entregado el 23 jul 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All moneys from time to time held to thecredit of the company by national westminster bank on any current deposit and/or other account which the company may now and/or hereafter have with that west bank or held by that west bank on an account earmarked re the company and/or underany deposit receipt.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 23 jul 1981Registro de una carga
    • 13 jul 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0