ENODICOM NUMBER 2 LIMITED

ENODICOM NUMBER 2 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaENODICOM NUMBER 2 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01422689
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ENODICOM NUMBER 2 LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra ENODICOM NUMBER 2 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    St Ann'S Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ENODICOM NUMBER 2 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TEMP-RITE INTERNATIONAL LIMITED 31 dic 197931 dic 1979

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ENODICOM NUMBER 2 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para ENODICOM NUMBER 2 LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ENODICOM NUMBER 2 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 14 mar 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital21 mar 2014

    Estado de capital el 21 mar 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Retiro de la solicitud de exclusión de la empresa

    2 páginasDS02

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Estado de capital el 14 jun 2013

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    3 páginasSH20

    legacy

    3 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Capital reserve cancelled 07/06/2013
    RES13

    Cese del nombramiento de Michael Kachmer como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 mar 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Nombramiento de Graham Philip Brisley Veal como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kevin Blades como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del director Maurice Delon Jones el 14 mar 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Prima Secretary Limited el 14 mar 2010

    2 páginasCH04

    Cese del nombramiento de Thomas Doerr como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de ENODICOM NUMBER 2 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro4363143
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Director
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritish146072380001
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Director
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmerican134328700001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    Director
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritish43215170003
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Secretario
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    SYMS, Rhonda Sneddon
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    Secretario
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    British16978550002
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Secretario designado corporativo
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    AIREY, Andrew Robert
    Heywood House
    Mark Way
    GU7 2BB Godalming
    Surrey
    Director
    Heywood House
    Mark Way
    GU7 2BB Godalming
    Surrey
    EnglandBritish54515590004
    ALLEN, Michael Philip
    6341 Bresslyn Road
    Nashville
    Tennessee 37205
    Usa
    Director
    6341 Bresslyn Road
    Nashville
    Tennessee 37205
    Usa
    American33460270001
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Director
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritish79449700002
    CUTHBERTSON, George Brian
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    Director
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish6996370001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Director
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United States134081280001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    Director
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    British45532880003
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Director
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    Director
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican136570610001
    LE CLERCQ, Michael Charles Antoine Gerard
    Strijbeekseweg 34b
    2328 Meerle - Hoogstraten
    Provincie Antwerpen
    Belgium
    Director
    Strijbeekseweg 34b
    2328 Meerle - Hoogstraten
    Provincie Antwerpen
    Belgium
    Dutchsh57828370001
    MULHALL, Denis Joseph
    Fitzgeorge House
    Fitzgeorge Avenue
    KT3 4SH New Malden
    Surrey
    Director
    Fitzgeorge House
    Fitzgeorge Avenue
    KT3 4SH New Malden
    Surrey
    EnglandBritish,Irish32235150003
    NICORVO, Richard Eugene
    101 Harvest Court
    Franklin
    Tennessee 37064
    Usa
    Director
    101 Harvest Court
    Franklin
    Tennessee 37064
    Usa
    American33460290001
    OAKES, Roger Kent
    5112 Hillsboro Road
    Nashville
    Tennessee 37215
    Usa
    Director
    5112 Hillsboro Road
    Nashville
    Tennessee 37215
    Usa
    American33460300001
    WISCHHUSEN, Heiner
    Osterhoizer Landstr 82b
    2800 Bremen 44
    Germany
    Director
    Osterhoizer Landstr 82b
    2800 Bremen 44
    Germany
    German33460310001
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Director corporativo
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Director corporativo
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006

    ¿Tiene ENODICOM NUMBER 2 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    Creado el 11 abr 2002
    Entregado el 25 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transacciones
    • 25 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    Creado el 20 feb 2002
    Entregado el 08 mar 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transacciones
    • 08 mar 2002Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    Creado el 20 nov 2001
    Entregado el 30 nov 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 30 nov 2001Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 06 jun 1995
    Entregado el 13 jun 1995
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over the deposit(s) being all sums of money in any currency deposited with the bank or held by the bank pursuant to the deposit being... Barclays bank PLC re temp-rire international limited business premium account number 30793108. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 jun 1995Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0