CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED

CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01428872
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Hillside Court Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CLARKBURGH MANAGEMENT LIMITED13 jun 197913 jun 1979

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 24 jul 2018

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 13 jun 2018 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Modification des détails de Jelf Group Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 sept 2017

    2 páginasPSC05

    Modification des détails d'une personne disposant d'un contrôle significatif

    2 páginasPSC05

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    6 páginasAA

    Nombramiento de Marsh Secretarial Services Limited como secretario el 10 jul 2017

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Dawn Jeanette Hodges como secretario el 10 jul 2017

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Paul Francis Clayden como director el 10 jul 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Caroline Wendy Godwin como director el 10 jul 2017

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 13 jun 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Nombramiento de Mr James Michael Pickford como director el 01 ene 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Paul Edward Barnes como director el 31 dic 2016

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 24 ago 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Renuncia del auditor

    2 páginasAUD

    Cese del nombramiento de Alexander Douglas Alway como director el 11 feb 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Alexander Douglas Alway como director el 11 feb 2016

    1 páginasTM01

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2016 au 31 dic 2016

    1 páginasAA01

    Cancelación total de la carga 4

    4 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2015

    1 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MARSH SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Tower Place West
    Tower Place
    EC3R 5BU London
    1
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Tower Place West
    Tower Place
    EC3R 5BU London
    1
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro555848
    187854670001
    GODWIN, Caroline Wendy
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    Director
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    United KingdomBritish224445640001
    PICKFORD, James Michael
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    Director
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    United KingdomBritish223405040001
    CLARK, Anne Rosemary
    Glengarry
    2 Ridgeway Road
    BS41 9EU Long Ashton
    North Somerset
    Secretario
    Glengarry
    2 Ridgeway Road
    BS41 9EU Long Ashton
    North Somerset
    British152529010001
    DAVIS, Helen Beatrice
    3 Tollbar Close
    Potterne
    SN10 5PD Devizes
    Wiltshire
    Secretario
    3 Tollbar Close
    Potterne
    SN10 5PD Devizes
    Wiltshire
    British77716400001
    HAYWARD, Michael David
    21 Jubilee Drive
    Bredon
    GL20 7QJ Tewkesbury
    Gloucestershire
    Secretario
    21 Jubilee Drive
    Bredon
    GL20 7QJ Tewkesbury
    Gloucestershire
    British61397720001
    HODGES, Dawn Jeanette
    Tower Place West
    EC3R 5BU London
    1
    England
    Secretario
    Tower Place West
    EC3R 5BU London
    1
    England
    203692000001
    ROXBURGH, Malcolm Stuart
    The Steppings Bosbury Road
    Cradley
    WR13 5JA Malvern
    Worcestershire
    Secretario
    The Steppings Bosbury Road
    Cradley
    WR13 5JA Malvern
    Worcestershire
    British7549820001
    ALWAY, Alexander Douglas
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    Director
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    EnglandBritish54126880001
    ALWAY, Alexander Douglas
    Lismore Cheltenham Road
    Bisley
    GL6 7BJ Stroud
    Gloucestershire
    Director
    Lismore Cheltenham Road
    Bisley
    GL6 7BJ Stroud
    Gloucestershire
    EnglandBritish54126880001
    ANDREWS, Timothy Lloyd
    4 The Hop Gardens
    Aldington
    WR11 5UB Evesham
    Worcestershire
    Director
    4 The Hop Gardens
    Aldington
    WR11 5UB Evesham
    Worcestershire
    British55942820001
    BARNES, Paul Edward
    Tower Place West
    EC3R 5BU London
    1
    England
    Director
    Tower Place West
    EC3R 5BU London
    1
    England
    EnglandBritish176370590001
    BARTON, Philip Andrew
    Church Road
    Yate
    BS37 5JB Bristol
    Fromeforde House
    Avon
    Director
    Church Road
    Yate
    BS37 5JB Bristol
    Fromeforde House
    Avon
    EnglandBritish12624970004
    CARTER, Robert Ross
    48 Albert Park Road
    WR14 1HP Malvern
    Worcestershire
    Director
    48 Albert Park Road
    WR14 1HP Malvern
    Worcestershire
    British94795980002
    CLARK, Anne Rosemary
    Glengarry
    2 Ridgeway Road
    BS41 9EU Long Ashton
    North Somerset
    Director
    Glengarry
    2 Ridgeway Road
    BS41 9EU Long Ashton
    North Somerset
    EnglandBritish152529010001
    CLARKE, Colin Raymond
    Westward House
    Hanley Swan
    WR8 0DN Worcester
    Director
    Westward House
    Hanley Swan
    WR8 0DN Worcester
    EnglandBritish11242610001
    CLARKE, Susan Margaret
    Westward House
    Hanley Swan
    WR8 0DN Worcester
    Director
    Westward House
    Hanley Swan
    WR8 0DN Worcester
    United KingdomBritish62400990001
    CLAYDEN, Paul Francis
    Tower Place West
    EC3R 5BU London
    1
    England
    Director
    Tower Place West
    EC3R 5BU London
    1
    England
    United KingdomBritish176795590001
    EGERTON, Simon David
    Drayton House
    62 Hall Green
    WR14 3QX Malvern
    Worcestershire
    Director
    Drayton House
    62 Hall Green
    WR14 3QX Malvern
    Worcestershire
    British11428940003
    HARDING, John Trevor
    Martindale
    Bridgewater Road
    BS25 1NN Sidcot
    North Somerset
    Director
    Martindale
    Bridgewater Road
    BS25 1NN Sidcot
    North Somerset
    EnglandBritish99783690002
    HAYWARD, Michael David
    21 Jubilee Drive
    Bredon
    GL20 7QJ Tewkesbury
    Gloucestershire
    Director
    21 Jubilee Drive
    Bredon
    GL20 7QJ Tewkesbury
    Gloucestershire
    EnglandBritish61397720001
    JAMES, Barrie Stuart
    3 Allsebrook Gardens
    Badsey
    WR11 5HJ Evesham
    Worcestershire
    Director
    3 Allsebrook Gardens
    Badsey
    WR11 5HJ Evesham
    Worcestershire
    British47100390002
    JENKINS, Brian Edward
    Oaklands Picken End
    Hanley Swan
    WR8 0DQ Worcester
    Worcestershire
    Director
    Oaklands Picken End
    Hanley Swan
    WR8 0DQ Worcester
    Worcestershire
    British11428950001
    NEVITT, Mark Christopher
    Stockcross
    RG20 8LH Newbury
    Wenlock House
    Berkshire
    Director
    Stockcross
    RG20 8LH Newbury
    Wenlock House
    Berkshire
    EnglandBritish138144910001
    RICHMOND, Charles Keenan
    10 Earlsdon Road
    Hanbury Park
    WR2 4PF Worcester
    Hereford & Worcestershire
    Director
    10 Earlsdon Road
    Hanbury Park
    WR2 4PF Worcester
    Hereford & Worcestershire
    British16688990002
    ROXBURGH, Kay Vanessa
    The Steppings, Bosbury Road
    WR13 5JA Cradley Malvern
    Worcestershire
    Director
    The Steppings, Bosbury Road
    WR13 5JA Cradley Malvern
    Worcestershire
    United KingdomBritish110138100001
    ROXBURGH, Malcolm Stuart
    The Steppings Bosbury Road
    Cradley
    WR13 5JA Malvern
    Worcestershire
    Director
    The Steppings Bosbury Road
    Cradley
    WR13 5JA Malvern
    Worcestershire
    EnglandBritish7549820001
    WILLIS, James
    Walkwood Farm
    Morton Lane Walkwood
    B97 5QA Redditch
    Worcestershire
    Director
    Walkwood Farm
    Morton Lane Walkwood
    B97 5QA Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish16677940002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Jelf Limited
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    England
    06 abr 2016
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUk
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro2975376
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Bowling Hill
    BS37 6JX Chipping Sodbury
    Hillside Court
    Bristol
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Bowling Hill
    BS37 6JX Chipping Sodbury
    Hillside Court
    Bristol
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro2975376
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 12 feb 2010
    Entregado el 18 feb 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Aviva Insurance UK Limited (Aviva), Sun Alliance Insurance Overseas Limited (Rsa), Allianz Holdings PLC (Allianz)
    Transacciones
    • 18 feb 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 27 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 02 abr 2008
    Entregado el 09 abr 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 abr 2008Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 24 jun 2003
    Entregado el 28 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 jun 2003Registro de un cargo (395)
    • 03 jun 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture by the company and kelquota limited
    Creado el 13 mar 1998
    Entregado el 20 mar 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the loan agreement (as therein defined) or otherwise
    Breve descripción
    The f/h property k/a 24 belle vue terrace malvern, 8 church green east redditch west midlands, 15 foregate street worcester (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Cornhill Insurance PLC
    Transacciones
    • 20 mar 1998Registro de un cargo (395)
    • 03 abr 2003Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 25 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0