CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01428872 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Hillside Court Bowling Hill Chipping Sodbury BS37 6JX Bristol |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CLARKBURGH MANAGEMENT LIMITED | 13 jun 1979 | 13 jun 1979 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 24 jul 2018
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 jun 2018 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Jelf Group Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 sept 2017 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Modification des détails d'une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Marsh Secretarial Services Limited como secretario el 10 jul 2017 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Dawn Jeanette Hodges como secretario el 10 jul 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Francis Clayden como director el 10 jul 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Caroline Wendy Godwin como director el 10 jul 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 jun 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Michael Pickford como director el 01 ene 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Edward Barnes como director el 31 dic 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 ago 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Renuncia del auditor | 2 páginas | AUD | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alexander Douglas Alway como director el 11 feb 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alexander Douglas Alway como director el 11 feb 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2016 au 31 dic 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2015 | 1 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSH SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Tower Place West Tower Place EC3R 5BU London 1 United Kingdom |
| 187854670001 | ||||||||||
| GODWIN, Caroline Wendy | Director | Bowling Hill Chipping Sodbury BS37 6JX Bristol Hillside Court | United Kingdom | British | 224445640001 | |||||||||
| PICKFORD, James Michael | Director | Bowling Hill Chipping Sodbury BS37 6JX Bristol Hillside Court | United Kingdom | British | 223405040001 | |||||||||
| CLARK, Anne Rosemary | Secretario | Glengarry 2 Ridgeway Road BS41 9EU Long Ashton North Somerset | British | 152529010001 | ||||||||||
| DAVIS, Helen Beatrice | Secretario | 3 Tollbar Close Potterne SN10 5PD Devizes Wiltshire | British | 77716400001 | ||||||||||
| HAYWARD, Michael David | Secretario | 21 Jubilee Drive Bredon GL20 7QJ Tewkesbury Gloucestershire | British | 61397720001 | ||||||||||
| HODGES, Dawn Jeanette | Secretario | Tower Place West EC3R 5BU London 1 England | 203692000001 | |||||||||||
| ROXBURGH, Malcolm Stuart | Secretario | The Steppings Bosbury Road Cradley WR13 5JA Malvern Worcestershire | British | 7549820001 | ||||||||||
| ALWAY, Alexander Douglas | Director | Bowling Hill Chipping Sodbury BS37 6JX Bristol Hillside Court | England | British | 54126880001 | |||||||||
| ALWAY, Alexander Douglas | Director | Lismore Cheltenham Road Bisley GL6 7BJ Stroud Gloucestershire | England | British | 54126880001 | |||||||||
| ANDREWS, Timothy Lloyd | Director | 4 The Hop Gardens Aldington WR11 5UB Evesham Worcestershire | British | 55942820001 | ||||||||||
| BARNES, Paul Edward | Director | Tower Place West EC3R 5BU London 1 England | England | British | 176370590001 | |||||||||
| BARTON, Philip Andrew | Director | Church Road Yate BS37 5JB Bristol Fromeforde House Avon | England | British | 12624970004 | |||||||||
| CARTER, Robert Ross | Director | 48 Albert Park Road WR14 1HP Malvern Worcestershire | British | 94795980002 | ||||||||||
| CLARK, Anne Rosemary | Director | Glengarry 2 Ridgeway Road BS41 9EU Long Ashton North Somerset | England | British | 152529010001 | |||||||||
| CLARKE, Colin Raymond | Director | Westward House Hanley Swan WR8 0DN Worcester | England | British | 11242610001 | |||||||||
| CLARKE, Susan Margaret | Director | Westward House Hanley Swan WR8 0DN Worcester | United Kingdom | British | 62400990001 | |||||||||
| CLAYDEN, Paul Francis | Director | Tower Place West EC3R 5BU London 1 England | United Kingdom | British | 176795590001 | |||||||||
| EGERTON, Simon David | Director | Drayton House 62 Hall Green WR14 3QX Malvern Worcestershire | British | 11428940003 | ||||||||||
| HARDING, John Trevor | Director | Martindale Bridgewater Road BS25 1NN Sidcot North Somerset | England | British | 99783690002 | |||||||||
| HAYWARD, Michael David | Director | 21 Jubilee Drive Bredon GL20 7QJ Tewkesbury Gloucestershire | England | British | 61397720001 | |||||||||
| JAMES, Barrie Stuart | Director | 3 Allsebrook Gardens Badsey WR11 5HJ Evesham Worcestershire | British | 47100390002 | ||||||||||
| JENKINS, Brian Edward | Director | Oaklands Picken End Hanley Swan WR8 0DQ Worcester Worcestershire | British | 11428950001 | ||||||||||
| NEVITT, Mark Christopher | Director | Stockcross RG20 8LH Newbury Wenlock House Berkshire | England | British | 138144910001 | |||||||||
| RICHMOND, Charles Keenan | Director | 10 Earlsdon Road Hanbury Park WR2 4PF Worcester Hereford & Worcestershire | British | 16688990002 | ||||||||||
| ROXBURGH, Kay Vanessa | Director | The Steppings, Bosbury Road WR13 5JA Cradley Malvern Worcestershire | United Kingdom | British | 110138100001 | |||||||||
| ROXBURGH, Malcolm Stuart | Director | The Steppings Bosbury Road Cradley WR13 5JA Malvern Worcestershire | England | British | 7549820001 | |||||||||
| WILLIS, James | Director | Walkwood Farm Morton Lane Walkwood B97 5QA Redditch Worcestershire | England | British | 16677940002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelf Limited | 06 abr 2016 | Bowling Hill Chipping Sodbury BS37 6JX Bristol Hillside Court England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Jelf Group Plc | 06 abr 2016 | Bowling Hill BS37 6JX Chipping Sodbury Hillside Court Bristol United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 12 feb 2010 Entregado el 18 feb 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 02 abr 2008 Entregado el 09 abr 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 24 jun 2003 Entregado el 28 jun 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee & debenture by the company and kelquota limited | Creado el 13 mar 1998 Entregado el 20 mar 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the loan agreement (as therein defined) or otherwise | |
Breve descripción The f/h property k/a 24 belle vue terrace malvern, 8 church green east redditch west midlands, 15 foregate street worcester (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0