CWAE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CWAE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01428938 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CWAE LIMITED?
- (7499) /
¿Dónde se encuentra CWAE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington Guildford Surrey Gu31lr |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CWAE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GEOFFREY ROBERTS ASSOCIATES LIMITED | 13 jun 1979 | 13 jun 1979 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CWAE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 28 feb 2010 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CWAE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jeremy Stevenson como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Esther Clothier como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Jeremy Stevenson como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Jeremy Stevenson como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Hughes como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Hughes como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Hughes como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr James David Lousada el 27 jun 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr David John Hughes el 27 jun 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr David John Hughes el 27 jun 2011 | 2 páginas | CH03 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Deepak Malhotra como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David John Hughes como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David John Hughes como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr James David Lousada como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Francis Hetterich como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 nov 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Helen Glennie como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2010 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Troy Christensen el 11 jun 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Francis Paul Hetterich como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Deepak Malhotra como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Helen Glennie como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CWAE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOTHIER, Esther | Secretario | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 162189220001 | |||||||
| STEVENSON, Jeremy | Secretario | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 161855910001 | |||||||
| CHRISTENSEN, Troy | Director | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington Guildford Surrey Gu31lr | Australia | American | 130789730002 | |||||
| LOUSADA, James David | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | England | British | 152222000001 | |||||
| COLQUHOUN, Anne Therese | Secretario | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | British | 28396500005 | ||||||
| EVANS, Fiona Maria | Secretario | 85 Ravensmede Way Chiswick W4 1TQ London | British | 49259690002 | ||||||
| GLENNIE, Helen Margaret | Secretario | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington Guildford Surrey Gu31lr | 149249660001 | |||||||
| HUGHES, David John | Secretario | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 157430760002 | |||||||
| MALHOTRA, Deepak Kumar | Secretario | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington Guildford Surrey Gu31lr | British | 69554640002 | ||||||
| MILLS, John Michael | Secretario | 33 Peplins Way AL9 7UR Brookmans Park Hertfordshire | British | 42268710001 | ||||||
| OSBORNE, Sarah Louise | Secretario | Flat 4 75 Madeley Road Ealing W5 2LT London | British | 45501330001 | ||||||
| COLQUHOUN, Anne Therese | Director | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | United Kingdom | British | 28396500005 | |||||
| CREIGHTON, Thomas Hugh | Director | Apple Acre High Road CR5 3QR Chipstead Surrey | England | British | 157727790001 | |||||
| EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey | Director | The Croft Chalfont Lane Chorleywood WD3 5PP Rickmansworth Hertfordshire | England | British | 49678170001 | |||||
| ETHERIDGE, Hugh Charles | Director | 5 Springfield Place BA1 5RA Bath Avon | United Kingdom | British | 1491130002 | |||||
| GLENNIE, Helen Margaret | Director | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington Guildford Surrey Gu31lr | United Kingdom | British | 137615160001 | |||||
| HETTERICH, Francis Paul | Director | The Guildway, Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Constellation House Surrey United Kingdom | United States | American | 147054340001 | |||||
| HODGES, Nigel Ian | Director | Sonning House 2 Canns Lane TA6 6QF North Petherton Somerset | British | 75692570001 | ||||||
| HUGHES, David John | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | 157415150002 | |||||
| HUNTLEY, Peter William | Director | 95 Meadowburn Bishopbriggs G64 3LX Glasgow | Australian | 46387640001 | ||||||
| JOHNSTON, Ian Andrew Hill | Director | 15 Caroline Terrace SW1W 8JT London | British | 1785700001 | ||||||
| KLEIN, David | Director | 45 Princes Road The Alberts TW10 6DQ Richmond Surrey | American | 119928070001 | ||||||
| MALHOTRA, Deepak Kumar | Director | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington Guildford Surrey Gu31lr | United Kingdom | British | 69554640002 | |||||
| MILLS, John Michael | Director | 33 Peplins Way AL9 7UR Brookmans Park Hertfordshire | British | 42268710001 | ||||||
| MORGAN, Alistair Mclauchlan | Director | 43 Lauderdale Drive Petersham TW10 7BS Richmond Surrey | British | 1785720001 | ||||||
| PETERS, Richard David | Director | Rose Cottage, Upper House Lane Shamley Green GU5 0SX Guildford Surrey | United Kingdom | British | 60630980002 | |||||
| ROBERTS, Geoffrey Michael | Director | 28 Cheyne Walk SW3 London | British | 31382110001 | ||||||
| STEVENS, David John | Director | 42 Burghley Road Wimbledon SW19 5HN London | British | 56704240001 | ||||||
| STEVENSON, Jeremy Alexander | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | 161846280001 | |||||
| TAUTZ, Helen Jane | Director | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | United Kingdom | British | 37564540001 |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0