INPOST DISTRIBUTION LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | INPOST DISTRIBUTION LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01430241 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
- Comercio al por mayor de otros productos intermedios (46760) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
| Dirección de la sede social | Moray House 23-35 Great Titchfield Street W1W 7PA London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MENZIES DISTRIBUTION LIMITED | 06 ago 2001 | 06 ago 2001 |
| JOHN MENZIES DISTRIBUTION LIMITED | 28 ene 1998 | 28 ene 1998 |
| NEWSRIDERS LIMITED | 29 jul 1985 | 29 jul 1985 |
| GOLDEN ACORN PUBLISHING COMPANY LIMITED(THE) | 15 jun 1979 | 15 jun 1979 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 28 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 19 may 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 02 jun 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 19 may 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Mr Michael Brian Rouse como director el 27 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Neil Oliver Kuschel como director el 26 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 28 dic 2024 | 66 páginas | AA | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Moray House, 23-25 Great Titchfield Street London W1W 7PA England a Moray House 23-35 Great Titchfield Street London W1W 7PA el 25 jun 2025 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed menzies distribution LIMITED\certificate issued on 25/06/25 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Unit E, Twelvetrees Business Park Twelvetrees Crescent London E3 3JG England a Moray House, 23-25 Great Titchfield Street London W1W 7PA el 25 jun 2025 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 may 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Neil Kuschel como director el 15 oct 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Gregory John Michael como director el 15 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 dic 2023 | 48 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 014302410013 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 62 páginas | AA | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Gregory John Michael el 07 sept 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Registro de la carga 014302410013, creada el 01 ago 2022 | 26 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 4 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 18 páginas | MA | ||||||||||||||
Registro de la carga 014302410012, creada el 22 jul 2022 | 72 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 01 ene 2022 | 60 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 may 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 014302410011 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||||||
Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 014302410008 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||||||
Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 014302410008 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 014302410004 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCCOURT, Paul Raymond Patrick | Director | Great Titchfield Street W1W 7PA London Moray House 23-35 England | Scotland | British | 183278190001 | |||||
| ROUSE, Michael Brian | Director | Great Titchfield Street W1W 7PA London Moray House 23-35 England | England | British | 343342430001 | |||||
| ANDERSON, Charles Adair | Secretario | Ravensheugh TD7 5LS Selkirk | British | 44142970001 | ||||||
| GEDDES, John Francis Alexander | Secretario | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | British | 103057020004 | ||||||
| KIRKWOOD, George | Secretario | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | British | 107652330001 | ||||||
| MULHOLLAND, Eric | Secretario | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | 152434850001 | |||||||
| MULHOLLAND, Eric | Secretario | 81 Auchingane EH10 7HU Edinburgh | British | 984680001 | ||||||
| TURNBULL, David Alistair | Secretario | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | 166629600001 | |||||||
| ANDERSON, Charles Adair | Director | Ravensheugh TD7 5LS Selkirk | United Kingdom | British | 44142970001 | |||||
| BELL, Paula | Director | Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh 2 Scotland | Scotland | British | 116712890002 | |||||
| BENNETT, James Douglas Scott | Director | The Well House 3 Easter Belmont Road EH12 6EX Edinburgh | British | 365550003 | ||||||
| BLACK, Forsyth Rutherford | Director | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 188546240002 | |||||
| BLAND, Catherine Mary | Director | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | Scotland | British | 153744340002 | |||||
| BOYLE, Thomas | Director | 26 Dreghorn Loan EH13 0DE Edinburgh | Irish | 107652260002 | ||||||
| CALLAGHAN, Iain Mills | Director | 10 Kings Cramond Gamekeepers Road EH4 6RL Edinburgh Midlothian | British | 145895140001 | ||||||
| CASSIE, Mark Stephen | Director | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | Scotland | British | 161586010001 | |||||
| COOKE, David Michael | Director | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | England | British | 146398580001 | |||||
| COYLE, Francis John | Director | 1 Struan Place KY11 1NF Inverkeithing Fife | Scotland | British | 54147130001 | |||||
| DOLLMAN, Paul Bernard | Director | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | Scotland | British | 1230000002 | |||||
| DOLLMAN, Paul Bernard | Director | 36 Garscube Terrace EH12 6BN Edinburgh | Scotland | British | 1230000002 | |||||
| DYSON, Jane Allison | Director | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | United Kingdom | British | 103858670002 | |||||
| JENKINSON, Dermot Julian | Director | Mersington House Greenlaw TD10 6UL Duns Berwickshire | Scotland | British | 681840002 | |||||
| KIRKWOOD, George | Director | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | British | 107652330001 | ||||||
| KUSCHEL, Neil Oliver | Director | Great Titchfield Street W1W 7PA London Moray House 23-35 England | England | British | 328820160001 | |||||
| MACDONALD, Patrick James | Director | 30 Royal Terrace EH7 5AH Edinburgh | Scotland | British | 90055380002 | |||||
| MACKAY, David James | Director | 4 East Harbour Road KY11 3EA Charlestown Fife | Scotland | British | 681850002 | |||||
| MCINTOSH, David Dennis | Director | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | Scotland | British | 85826730002 | |||||
| MELLON, Christina | Director | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | Scotland | British | 139986280001 | |||||
| MICHAEL, Gregory John | Director | 2 Redheughs Rigg South Gyle EH12 9DQ Edinburgh Verdant Scotland | England | British | 221854770002 | |||||
| MITCHELL, Alexander | Director | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | United Kingdom | British | 139998290001 | |||||
| MORTON, David Emerson | Director | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | Scotland | British | 13180890002 | |||||
| NOEL-PATON, Frederick Ranald, The Hon | Director | Easter Dunbarnie Bridge Of Earn PH2 9ED Perth Perthshire | British | 21482560001 | ||||||
| SMITH, Martyn Robert | Director | 12/2 Mcdonald Road EH7 4LZ Edinburgh | British | 65137160006 | ||||||
| SPEIRS, David William Ogden | Director | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | Scotland | Scottish | 129856460001 | |||||
| WARD, John | Director | 9a Mossgreen KY4 8BU Crossgates Fife | British | 84407440002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menzies Distribution Holdings Limited | 04 sept 2018 | Whitehall Quay LS1 4BF Leeds 3 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| John Menzies Plc | 06 abr 2016 | Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh 2 Scotland Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Menzies Group Holdings Limited | 06 abr 2016 | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0