OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01431111 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED?
| Dirección de la sede social | c/o CK CHARTERED ACCOUNTANTS Castle Court 2 Castlegate Way DY1 4RH Dudley West Midlands |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CABLE AND WIRELESS (COMPUTER SYSTEMS) LIMITED | 08 ago 1994 | 08 ago 1994 |
| CABLE AND WIRELESS (PENSION SERVICES) LIMITED | 19 abr 1994 | 19 abr 1994 |
| SPACE-TIME SYSTEMS (HOLDINGS) LIMITED | 01 oct 1985 | 01 oct 1985 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2012 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 mar 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 mar 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 mar 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2010 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 mar 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Susan Lesley Harris el 23 feb 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Matthew Harris el 23 feb 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Michael John Harris el 23 feb 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Dr Claire Louise Brown el 23 feb 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Susan Lesley Harris el 23 feb 2011 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Appleford Meadows School Lane Appleford Abingdon Oxfordshire OX14 4NY el 21 feb 2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2009 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 mar 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Susan Lesley Harris el 01 mar 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Michael John Harris el 01 mar 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Matthew Harris el 01 mar 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Susan Lesley Harris el 01 mar 2010 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Dr Claire Louise Brown el 01 mar 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Susan Lesley Harris el 01 oct 2009 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Michael John Harris el 01 oct 2009 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRIS, Susan Lesley | Secretario | c/o Ck Chartered Accountants Castlegate Way DY1 4RH Dudley Castle Court 2 West Midlands United Kingdom | British | 77295200001 | ||||||
| BROWN, Claire Louise, Dr | Director | c/o Ck Chartered Accountants Castlegate Way DY1 4RH Dudley Castle Court 2 West Midlands United Kingdom | England | British | 114831110001 | |||||
| HARRIS, Matthew David | Director | c/o Ck Chartered Accountants Castlegate Way DY1 4RH Dudley Castle Court 2 West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 114732130001 | |||||
| HARRIS, Michael John | Director | c/o Ck Chartered Accountants Castlegate Way DY1 4RH Dudley Castle Court 2 West Midlands United Kingdom | England | British | 174529110001 | |||||
| HARRIS, Susan Lesley | Director | c/o Ck Chartered Accountants Castlegate Way DY1 4RH Dudley Castle Court 2 West Midlands United Kingdom | England | British | 77295200001 | |||||
| CLAYDON, Kenneth Keith | Secretario | 1 Parr House 12 Beaulieu Avenue E16 1TS London | British | 60709330001 | ||||||
| LOWE, Hilary Anne | Secretario | 40 Mill Lane Cheshunt EN8 0JH Hertfordshire | British | 95034760001 | ||||||
| RADCLIFFE, Peter Howard | Secretario | Carlton House Gildingwells S81 8AU Worksop Notts | British | 4790650001 | ||||||
| WELLARD, Tracey Lee | Secretario | 21 Davenport Road Albany Park DA14 4PN Sidcup Kent | British | 11445390001 | ||||||
| WINDRIDGE, Susan Doreen | Secretario | The Ferns 157 Southwood Lane N6 5TA London | British | 6617760002 | ||||||
| CARTWRIGHT, Stacey Lee | Director | 34 Roedean Crescent SW15 5JU London | United Kingdom | British | 150700660001 | |||||
| CASSONI, Maria Luisa | Director | 125 Providence Square Bermondsey Wall West SE1 2ED London | England | British | 74583340001 | |||||
| CLAYDON, Kenneth Keith | Director | 1 Parr House 12 Beaulieu Avenue E16 1TS London | British | 60709330001 | ||||||
| COLEMAN, Kieran Mark | Director | 13 Chelverton Road Putney SW15 1RN London | Irish | 111282900001 | ||||||
| COPPOCK, Kenneth Francis | Director | Oving House Loudhams Wood Lane HP8 4AP Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 78528960001 | ||||||
| COUNCELL, Derek John | Director | 11 Gainsborough Gardens NW3 1BJ London | United Kingdom | British | 34891830003 | |||||
| DOYLE, David Colin | Director | 19 Belsize Park Gardens NW3 4JG London | Australian | 70583800002 | ||||||
| GILLESPIE, Joseph Norman, Dr | Director | 11 Claremont Road TN1 1SY Tunbridge Wells Kent | British | 29694610001 | ||||||
| GRATTON, Paul Robert | Director | The Hall Somersal Herbert DE6 5PD Ashbourne Derbyshire | United Kingdom | British | 47117090003 | |||||
| JACK, James White | Director | Azalea Cottage Alderton Drive HP4 1NA Little Gaddesden Hertfordshire | England | British | 191658610001 | |||||
| KIBBEY, Jane Celia | Director | 54 Beltran Road SW6 3AJ London | British | 10924800001 | ||||||
| MAYNARD, Peter Martin | Director | The Old Rectory, Rectory Road Woodham Walter CM9 6RD Maldon Essex | United Kingdom | British | 153259670001 | |||||
| MYERS, Andrew Colin | Director | 70 Reddown Road CR5 1AL Coulsdon Surrey | British | 11837680001 | ||||||
| NANCARROW, Mark James St John | Director | Tetley House Marchington ST14 8LG Uttoxeter Staffordshire | British | 105319950001 | ||||||
| O BRIEN, Conor John Anthony | Director | Midgham Park Farm Midgham RG7 5UG Reading Berkshire | British | 72690550001 | ||||||
| OLSEN, Rodney James | Director | Hawthorne House 1 Upper Terrace Hampstead NW3 6RH London | New Zealander | 13009620005 | ||||||
| PAKENHAM-WALSH, Patrick Douglas | Director | Orchard Cottage Lythe Hill Park GU27 3BD Haslemere Surrey | British | 1703230001 | ||||||
| PATE, Thomas | Director | 19 Canford Road SW11 6PA London | British | 21537620001 | ||||||
| SUTCLIFFE, James Harry | Director | Sans Souci South View Road HA5 3YD Pinner Middlesex | United Kingdom | British | 57721650001 | |||||
| SYDOW, Karl Gordon | Director | 17 Lonsdale Place N1 1EL London | Usa | 8553020001 |
¿Tiene OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and debenture | Creado el 05 dic 1991 Entregado el 18 dic 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción See form 395 ref M621C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creado el 14 oct 1991 Entregado el 01 nov 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter dated 11/10/91 | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 01 may 1991 Entregado el 17 may 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Series of debentures | Creado el 02 jul 1987 Entregado el 06 jul 1987 | Satisfecho en su totalidad | ||
Transacciones
| ||||
| Series of debentures | Creado el 02 jul 1986 Entregado el 02 jul 1986 | Satisfecho en su totalidad | ||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 01 abr 1982 Entregado el 08 abr 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital with all fixtures (incl trade fixtures) & fittings, plant machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 22 oct 1981 Entregado el 23 oct 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums that the chargees may be called upon to pay in connection with a lease dated 25TH february, 1981, or pursuant to an undertaking in a letter dated 22ND october 1981 | |
Breve descripción Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0