OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED

OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaOXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01431111
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o CK CHARTERED ACCOUNTANTS
    Castle Court 2
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    West Midlands
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CABLE AND WIRELESS (COMPUTER SYSTEMS) LIMITED08 ago 199408 ago 1994
    CABLE AND WIRELESS (PENSION SERVICES) LIMITED19 abr 199419 abr 1994
    SPACE-TIME SYSTEMS (HOLDINGS) LIMITED01 oct 198501 oct 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 20 mar 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 mar 2014

    Estado de capital el 27 mar 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2012

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 20 mar 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Déclaration annuelle établie au 20 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2011

    4 páginasAA

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2010

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 20 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cambio de datos del director Susan Lesley Harris el 23 feb 2011

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Matthew Harris el 23 feb 2011

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Michael John Harris el 23 feb 2011

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Dr Claire Louise Brown el 23 feb 2011

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Susan Lesley Harris el 23 feb 2011

    1 páginasCH03

    Domicilio social registrado cambiado de Appleford Meadows School Lane Appleford Abingdon Oxfordshire OX14 4NY el 21 feb 2011

    1 páginasAD01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2009

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 20 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del director Susan Lesley Harris el 01 mar 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Michael John Harris el 01 mar 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Matthew Harris el 01 mar 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Susan Lesley Harris el 01 mar 2010

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Dr Claire Louise Brown el 01 mar 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Susan Lesley Harris el 01 oct 2009

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director Michael John Harris el 01 oct 2009

    3 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HARRIS, Susan Lesley
    c/o Ck Chartered Accountants
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    Castle Court 2
    West Midlands
    United Kingdom
    Secretario
    c/o Ck Chartered Accountants
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    Castle Court 2
    West Midlands
    United Kingdom
    British77295200001
    BROWN, Claire Louise, Dr
    c/o Ck Chartered Accountants
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    Castle Court 2
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    c/o Ck Chartered Accountants
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    Castle Court 2
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish114831110001
    HARRIS, Matthew David
    c/o Ck Chartered Accountants
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    Castle Court 2
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    c/o Ck Chartered Accountants
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    Castle Court 2
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish114732130001
    HARRIS, Michael John
    c/o Ck Chartered Accountants
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    Castle Court 2
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    c/o Ck Chartered Accountants
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    Castle Court 2
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish174529110001
    HARRIS, Susan Lesley
    c/o Ck Chartered Accountants
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    Castle Court 2
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    c/o Ck Chartered Accountants
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    Castle Court 2
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish77295200001
    CLAYDON, Kenneth Keith
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    Secretario
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    British60709330001
    LOWE, Hilary Anne
    40 Mill Lane
    Cheshunt
    EN8 0JH Hertfordshire
    Secretario
    40 Mill Lane
    Cheshunt
    EN8 0JH Hertfordshire
    British95034760001
    RADCLIFFE, Peter Howard
    Carlton House
    Gildingwells
    S81 8AU Worksop
    Notts
    Secretario
    Carlton House
    Gildingwells
    S81 8AU Worksop
    Notts
    British4790650001
    WELLARD, Tracey Lee
    21 Davenport Road
    Albany Park
    DA14 4PN Sidcup
    Kent
    Secretario
    21 Davenport Road
    Albany Park
    DA14 4PN Sidcup
    Kent
    British11445390001
    WINDRIDGE, Susan Doreen
    The Ferns
    157 Southwood Lane
    N6 5TA London
    Secretario
    The Ferns
    157 Southwood Lane
    N6 5TA London
    British6617760002
    CARTWRIGHT, Stacey Lee
    34 Roedean Crescent
    SW15 5JU London
    Director
    34 Roedean Crescent
    SW15 5JU London
    United KingdomBritish150700660001
    CASSONI, Maria Luisa
    125 Providence Square
    Bermondsey Wall West
    SE1 2ED London
    Director
    125 Providence Square
    Bermondsey Wall West
    SE1 2ED London
    EnglandBritish74583340001
    CLAYDON, Kenneth Keith
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    Director
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    British60709330001
    COLEMAN, Kieran Mark
    13 Chelverton Road
    Putney
    SW15 1RN London
    Director
    13 Chelverton Road
    Putney
    SW15 1RN London
    Irish111282900001
    COPPOCK, Kenneth Francis
    Oving House Loudhams Wood Lane
    HP8 4AP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Director
    Oving House Loudhams Wood Lane
    HP8 4AP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British78528960001
    COUNCELL, Derek John
    11 Gainsborough Gardens
    NW3 1BJ London
    Director
    11 Gainsborough Gardens
    NW3 1BJ London
    United KingdomBritish34891830003
    DOYLE, David Colin
    19 Belsize Park Gardens
    NW3 4JG London
    Director
    19 Belsize Park Gardens
    NW3 4JG London
    Australian70583800002
    GILLESPIE, Joseph Norman, Dr
    11 Claremont Road
    TN1 1SY Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    11 Claremont Road
    TN1 1SY Tunbridge Wells
    Kent
    British29694610001
    GRATTON, Paul Robert
    The Hall
    Somersal Herbert
    DE6 5PD Ashbourne
    Derbyshire
    Director
    The Hall
    Somersal Herbert
    DE6 5PD Ashbourne
    Derbyshire
    United KingdomBritish47117090003
    JACK, James White
    Azalea Cottage
    Alderton Drive
    HP4 1NA Little Gaddesden
    Hertfordshire
    Director
    Azalea Cottage
    Alderton Drive
    HP4 1NA Little Gaddesden
    Hertfordshire
    EnglandBritish191658610001
    KIBBEY, Jane Celia
    54 Beltran Road
    SW6 3AJ London
    Director
    54 Beltran Road
    SW6 3AJ London
    British10924800001
    MAYNARD, Peter Martin
    The Old Rectory, Rectory Road
    Woodham Walter
    CM9 6RD Maldon
    Essex
    Director
    The Old Rectory, Rectory Road
    Woodham Walter
    CM9 6RD Maldon
    Essex
    United KingdomBritish153259670001
    MYERS, Andrew Colin
    70 Reddown Road
    CR5 1AL Coulsdon
    Surrey
    Director
    70 Reddown Road
    CR5 1AL Coulsdon
    Surrey
    British11837680001
    NANCARROW, Mark James St John
    Tetley House
    Marchington
    ST14 8LG Uttoxeter
    Staffordshire
    Director
    Tetley House
    Marchington
    ST14 8LG Uttoxeter
    Staffordshire
    British105319950001
    O BRIEN, Conor John Anthony
    Midgham Park Farm
    Midgham
    RG7 5UG Reading
    Berkshire
    Director
    Midgham Park Farm
    Midgham
    RG7 5UG Reading
    Berkshire
    British72690550001
    OLSEN, Rodney James
    Hawthorne House
    1 Upper Terrace Hampstead
    NW3 6RH London
    Director
    Hawthorne House
    1 Upper Terrace Hampstead
    NW3 6RH London
    New Zealander13009620005
    PAKENHAM-WALSH, Patrick Douglas
    Orchard Cottage Lythe Hill Park
    GU27 3BD Haslemere
    Surrey
    Director
    Orchard Cottage Lythe Hill Park
    GU27 3BD Haslemere
    Surrey
    British1703230001
    PATE, Thomas
    19 Canford Road
    SW11 6PA London
    Director
    19 Canford Road
    SW11 6PA London
    British21537620001
    SUTCLIFFE, James Harry
    Sans Souci South View Road
    HA5 3YD Pinner
    Middlesex
    Director
    Sans Souci South View Road
    HA5 3YD Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritish57721650001
    SYDOW, Karl Gordon
    17 Lonsdale Place
    N1 1EL London
    Director
    17 Lonsdale Place
    N1 1EL London
    Usa8553020001

    ¿Tiene OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee and debenture
    Creado el 05 dic 1991
    Entregado el 18 dic 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    See form 395 ref M621C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 18 dic 1991Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 1994Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 29 abr 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 14 oct 1991
    Entregado el 01 nov 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter dated 11/10/91
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Rober Fleming & Co. Limited
    Transacciones
    • 01 nov 1991Registro de un cargo (395)
    • 29 abr 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 01 may 1991
    Entregado el 17 may 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Robert Fleming & Co Limited
    Transacciones
    • 17 may 1991Registro de un cargo (395)
    • 29 abr 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Series of debentures
    Creado el 02 jul 1987
    Entregado el 06 jul 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Transacciones
    • 06 jul 1987Registro de una carga
    Series of debentures
    Creado el 02 jul 1986
    Entregado el 02 jul 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Transacciones
    • 02 jul 1986Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 01 abr 1982
    Entregado el 08 abr 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital with all fixtures (incl trade fixtures) & fittings, plant machinery.
    Personas con derecho
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transacciones
    • 08 abr 1982Registro de una carga
    • 29 abr 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 22 oct 1981
    Entregado el 23 oct 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums that the chargees may be called upon to pay in connection with a lease dated 25TH february, 1981, or pursuant to an undertaking in a letter dated 22ND october 1981
    Breve descripción
    Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • (3) the Cardinal Investment Trust Limited
    • (4) Alliance Investment Company Limited
    • (1) the Foreign & Colonial Investment Trust Company Limited
    • (2) General Investors and Trustees Limited
    Transacciones
    • 23 oct 1981Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0