HEALTHCALL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHEALTHCALL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01437517
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HEALTHCALL LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra HEALTHCALL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Cavendish House Lakpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HEALTHCALL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    AIR CALL (HOLDINGS) LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    GNOMECROFT LIMITED16 jul 197916 jul 1979

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HEALTHCALL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HEALTHCALL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Carl Michael Brown como director el 29 nov 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Collison como secretario el 29 nov 2018

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 13 nov 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 13 nov 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Notification de Hcms Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC02

    Cese del nombramiento de John Henry Whitehead como director el 12 jun 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Carl Michael Brown como director el 12 jun 2017

    2 páginasAP01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    5 páginasAA

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Declaración de confirmación presentada el 13 nov 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    14 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    20 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cese del nombramiento de Richard Mark Preece como director el 16 feb 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Richard Mark Preece como director el 14 ene 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr David Collison como secretario el 31 dic 2015

    2 páginasAP03

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 ene 2016 au 31 dic 2015

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Timothy Mark Pethick como director el 31 dic 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Victoria Haynes como secretario el 01 dic 2015

    1 páginasTM02

    Domicilio social registrado cambiado de Enbrook Park Sandgate Folkestone Kent CT20 3SE a Cavendish House Lakpur Court Staffordshire Technology Park Stafford ST18 0FX el 04 dic 2015

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 13 nov 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 nov 2015

    Estado de capital el 13 nov 2015

    • Capital: GBP 186,580.15
    SH01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    capital

    Resolución de eliminación de derechos de suscripción preferente

    RES11
    capital

    Resoluciones

    Transaction summary 08/09/2015
    RES13

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ene 2015

    4 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de HEALTHCALL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COLLISON, David
    Lakpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    United Kingdom
    Secretario
    Lakpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    United Kingdom
    204255070001
    COLLISON, David
    44 Lowther Road
    SW13 9NU London
    England
    Secretario
    44 Lowther Road
    SW13 9NU London
    England
    British34835160001
    DAVIES, John
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Secretario
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    158562750001
    HAYNES, Victoria
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Secretario
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    British182412280001
    HOWARD, Nigel Peter
    86 Rewley Road
    OX1 2RQ Oxford
    Secretario
    86 Rewley Road
    OX1 2RQ Oxford
    British124147420001
    NGONDONGA, Taguma
    Basing View
    RG21 4EA Basingstoke
    Fanum House
    Hampshire
    United Kingdom
    Secretario
    Basing View
    RG21 4EA Basingstoke
    Fanum House
    Hampshire
    United Kingdom
    171613130001
    ROBERTS THOMAS, Caroline Emma
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    Secretario
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    BritishCompany Secretary76032450005
    SPINK, David
    2 Monkswood
    West End Silverstone
    NN12 8TG Towcester
    Northamptonshire
    Secretario
    2 Monkswood
    West End Silverstone
    NN12 8TG Towcester
    Northamptonshire
    British34518140003
    BOOTY, Stephen Martin
    South Lodge
    Guildford Road
    KT24 5QE Effingham
    Surrey
    Director
    South Lodge
    Guildford Road
    KT24 5QE Effingham
    Surrey
    EnglandBritishDirector147928010001
    BROWN, Carl Michael
    Lakpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    United Kingdom
    Director
    Lakpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant232841280001
    BURNS, Robert Ian
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector36584260002
    ELLIS, Martyn Anthony
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    Director
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    EnglandBritishGroup Finance Director95749550002
    GIBSON, Darryn Stanley
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomNew ZealanderCompany Director177930490001
    HENCHEY, Maurice David
    Hamels Mead
    Braughing
    SG9 9ND Buntingford
    Hertfordshire
    Director
    Hamels Mead
    Braughing
    SG9 9ND Buntingford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director17815290002
    HOWARD, Nigel Peter
    86 Rewley Road
    OX1 2RQ Oxford
    Director
    86 Rewley Road
    OX1 2RQ Oxford
    BritishCompany Director124147420001
    HOWARD, Stuart Michael
    Enbrook Park
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Enbrook Park
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director160271430001
    IVERS, John Joseph
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    Director
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director77692980002
    JEWITT, Justin Allan Spaven, Professor
    The Stables
    89 Aston End Road Aston
    SG2 7EY Stevenage
    Hertfordshire
    Director
    The Stables
    89 Aston End Road Aston
    SG2 7EY Stevenage
    Hertfordshire
    EnglandBritishGroup Chief Executive39701670001
    LYON, David Oliver
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishGroup Finance Director51084280003
    PAGE, Stephen Robert
    Oak Tree House
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    Director
    Oak Tree House
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    EnglandBritishManaging Director257896700001
    PETHICK, Timothy Mark
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director172197670001
    PREECE, Richard Mark
    Lakpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    United Kingdom
    Director
    Lakpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director97531900001
    ROBERTS THOMAS, Caroline Emma
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    Director
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    BritishCompany Secretary76032450005
    SPINK, David
    2 Monkswood
    West End Silverstone
    NN12 8TG Towcester
    Northamptonshire
    Director
    2 Monkswood
    West End Silverstone
    NN12 8TG Towcester
    Northamptonshire
    BritishCompany Director34518140003
    STEVENS, Geoffrey Robert
    Beech House
    3 Millhouses Court
    S11 9HZ Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    Beech House
    3 Millhouses Court
    S11 9HZ Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director57380020001
    WHITEHEAD, John Henry
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant182872850002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HEALTHCALL LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Hcms Limited
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    06 abr 2016
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House England And Wales
    Número de registro3446369
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para HEALTHCALL LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    13 nov 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene HEALTHCALL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental deed
    Creado el 29 jul 1998
    Entregado el 06 ago 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined) under or pursuant to the secured documents (as defined) or on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 06 ago 1998Registro de un cargo (395)
    • 18 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 30 mar 1998
    Entregado el 17 abr 1998
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All moneys and obligations and liabilities due or to become due from the company and each group company (as defined) to hcms limited ("the parent") under or pursuant to the secured documents (as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hcms Limited
    Transacciones
    • 17 abr 1998Registro de un cargo (395)
    Supplemental deed
    Creado el 30 mar 1998
    Entregado el 15 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined) under or pursuant to the secured documents (as defined) or on account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 15 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 18 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 may 1994
    Entregado el 15 jun 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 15 jun 1994Registro de un cargo (395)
    • 17 jul 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Creado el 02 mar 1990
    Entregado el 08 mar 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from healthcall group PLC. To the chargee under the terms of the facility agreement dated 20/12/89 and this debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland and/or the Banks as Defined.
    Transacciones
    • 08 mar 1990Registro de una carga
    • 16 mar 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Creado el 23 feb 1990
    Entregado el 07 mar 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from healthcall group PLC. To the chargee, under the terms of the mezzanine loan agreement and the "security documents" as defined
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Intermediate Capital Group Limited and/or the Mezzanine Lenders.
    Transacciones
    • 07 mar 1990Registro de una carga
    • 16 mar 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 31 oct 1986
    Entregado el 05 nov 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge on all book debts and other debts owing to the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 05 nov 1986Registro de una carga
    A registered charge
    Creado el 14 sept 1985
    Entregado el 14 sept 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Transacciones
    • 14 sept 1985Registro de una carga
    Series of debentures
    Creado el 17 jul 1985
    Entregado el 24 jul 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Personas con derecho
    • S H Halltrustee for the Debenture Holder
    • W M Hoffman
    Transacciones
    • 24 jul 1985Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0