HEALTHCALL LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | HEALTHCALL LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01437517 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HEALTHCALL LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra HEALTHCALL LIMITED?
Dirección de la sede social | Cavendish House Lakpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HEALTHCALL LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
AIR CALL (HOLDINGS) LIMITED | 31 dic 1979 | 31 dic 1979 |
GNOMECROFT LIMITED | 16 jul 1979 | 16 jul 1979 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HEALTHCALL LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HEALTHCALL LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Carl Michael Brown como director el 29 nov 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de David Collison como secretario el 29 nov 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 nov 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 nov 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Notification de Hcms Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de John Henry Whitehead como director el 12 jun 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Mr Carl Michael Brown como director el 12 jun 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 nov 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 14 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 20 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Mark Preece como director el 16 feb 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Mr Richard Mark Preece como director el 14 ene 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Mr David Collison como secretario el 31 dic 2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 31 ene 2016 au 31 dic 2015 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy Mark Pethick como director el 31 dic 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Victoria Haynes como secretario el 01 dic 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Enbrook Park Sandgate Folkestone Kent CT20 3SE a Cavendish House Lakpur Court Staffordshire Technology Park Stafford ST18 0FX el 04 dic 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 nov 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ene 2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de HEALTHCALL LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLISON, David | Secretario | Lakpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House United Kingdom | 204255070001 | |||||||
COLLISON, David | Secretario | 44 Lowther Road SW13 9NU London England | British | 34835160001 | ||||||
DAVIES, John | Secretario | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | 158562750001 | |||||||
HAYNES, Victoria | Secretario | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | British | 182412280001 | ||||||
HOWARD, Nigel Peter | Secretario | 86 Rewley Road OX1 2RQ Oxford | British | 124147420001 | ||||||
NGONDONGA, Taguma | Secretario | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire United Kingdom | 171613130001 | |||||||
ROBERTS THOMAS, Caroline Emma | Secretario | 5 Broomsleigh Street NW6 1QQ London | British | Company Secretary | 76032450005 | |||||
SPINK, David | Secretario | 2 Monkswood West End Silverstone NN12 8TG Towcester Northamptonshire | British | 34518140003 | ||||||
BOOTY, Stephen Martin | Director | South Lodge Guildford Road KT24 5QE Effingham Surrey | England | British | Director | 147928010001 | ||||
BROWN, Carl Michael | Director | Lakpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House United Kingdom | England | British | Accountant | 232841280001 | ||||
BURNS, Robert Ian | Director | 6 Netherfield Road AL5 2AG Harpenden Hertfordshire | England | British | Director | 36584260002 | ||||
ELLIS, Martyn Anthony | Director | Beaconsfield Road AL10 8HU Hatfield Beaconsfield Court Hertfordshire | England | British | Group Finance Director | 95749550002 | ||||
GIBSON, Darryn Stanley | Director | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | United Kingdom | New Zealander | Company Director | 177930490001 | ||||
HENCHEY, Maurice David | Director | Hamels Mead Braughing SG9 9ND Buntingford Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 17815290002 | ||||
HOWARD, Nigel Peter | Director | 86 Rewley Road OX1 2RQ Oxford | British | Company Director | 124147420001 | |||||
HOWARD, Stuart Michael | Director | Enbrook Park CT20 3SE Folkestone 2 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 160271430001 | ||||
IVERS, John Joseph | Director | Beaconsfield Road AL10 8HU Hatfield Beaconsfield Court Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 77692980002 | ||||
JEWITT, Justin Allan Spaven, Professor | Director | The Stables 89 Aston End Road Aston SG2 7EY Stevenage Hertfordshire | England | British | Group Chief Executive | 39701670001 | ||||
LYON, David Oliver | Director | 41 Park Avenue North AL5 2EE Harpenden Hertfordshire | England | British | Group Finance Director | 51084280003 | ||||
PAGE, Stephen Robert | Director | Oak Tree House Berry Lane WD3 5EY Chorleywood Hertfordshire | England | British | Managing Director | 257896700001 | ||||
PETHICK, Timothy Mark | Director | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 172197670001 | ||||
PREECE, Richard Mark | Director | Lakpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House United Kingdom | England | British | Company Director | 97531900001 | ||||
ROBERTS THOMAS, Caroline Emma | Director | 5 Broomsleigh Street NW6 1QQ London | British | Company Secretary | 76032450005 | |||||
SPINK, David | Director | 2 Monkswood West End Silverstone NN12 8TG Towcester Northamptonshire | British | Company Director | 34518140003 | |||||
STEVENS, Geoffrey Robert | Director | Beech House 3 Millhouses Court S11 9HZ Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | Finance Director | 57380020001 | ||||
WHITEHEAD, John Henry | Director | Beaconsfield Road AL10 8HU Hatfield Beaconsfield House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 182872850002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HEALTHCALL LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcms Limited | 06 abr 2016 | Lakhpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para HEALTHCALL LIMITED?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
13 nov 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene HEALTHCALL LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Supplemental deed | Creado el 29 jul 1998 Entregado el 06 ago 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined) under or pursuant to the secured documents (as defined) or on any account whatsoever | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creado el 30 mar 1998 Entregado el 17 abr 1998 | Pendiente | Cantidad garantizada All moneys and obligations and liabilities due or to become due from the company and each group company (as defined) to hcms limited ("the parent") under or pursuant to the secured documents (as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Supplemental deed | Creado el 30 mar 1998 Entregado el 15 abr 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined) under or pursuant to the secured documents (as defined) or on account whatsoever | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 31 may 1994 Entregado el 15 jun 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Composite guarantee & debenture | Creado el 02 mar 1990 Entregado el 08 mar 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from healthcall group PLC. To the chargee under the terms of the facility agreement dated 20/12/89 and this debenture | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Composite guarantee & debenture | Creado el 23 feb 1990 Entregado el 07 mar 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from healthcall group PLC. To the chargee, under the terms of the mezzanine loan agreement and the "security documents" as defined | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fixed and floating charge | Creado el 31 oct 1986 Entregado el 05 nov 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed charge on all book debts and other debts owing to the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 14 sept 1985 Entregado el 14 sept 1985 | Satisfecho en su totalidad | ||
Transacciones
| ||||
Series of debentures | Creado el 17 jul 1985 Entregado el 24 jul 1985 | Satisfecho en su totalidad | ||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0