BEPCO AGRI LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBEPCO AGRI LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01440643
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BEPCO AGRI LIMITED?

    • Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y suministros agrícolas (46610) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra BEPCO AGRI LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BEPCO AGRI LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BEPCO (UK) LIMITED05 abr 199105 abr 1991
    MIFFLIN TRADING LIMITED30 jul 197930 jul 1979

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BEPCO AGRI LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para BEPCO AGRI LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BEPCO AGRI LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 17 dic 2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Déclaration annuelle établie au 20 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 jul 2014

    Estado de capital el 16 jul 2014

    • Capital: GBP 301,000
    SH01

    Cuentas preparadas hasta el 30 sept 2013

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 20 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 jun 2013

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 27 jun 2013

    SH01

    Cuentas preparadas hasta el 30 sept 2012

    17 páginasAA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed bepco (uk) LIMITED\certificate issued on 01/02/13
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name01 feb 2013

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 31 ene 2013

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Cese del nombramiento de Keith Palmer como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Amanda Wood como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Keith Palmer como secretario

    1 páginasTM02

    legacy

    3 páginasMG02

    Exercice comptable en cours raccourci du 31 dic 2012 au 30 sept 2012

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Edward Salter como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 20 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Salvo Mazzotta como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Giorgio Fioranelli como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Pascal Vanhalst como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Bernard De Meester como director

    2 páginasAP01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2011

    16 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de BEPCO AGRI LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WOOD, Amanda
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Secretario
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    174129600001
    DE MEESTER, Bernard Stephan
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Director
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    BelgiumBelgian168959600001
    VANHALST, Pascal
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Director
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    BelgiumBelgian168959780001
    BAINTON, Adrian Richard
    2 Oak Drive
    Burghfield Common
    RG7 3JF Reading
    Berkshire
    Secretario
    2 Oak Drive
    Burghfield Common
    RG7 3JF Reading
    Berkshire
    British14830800001
    FRY, Wendy Kristina
    14 Comfrey Close
    RG40 5YN Wokingham
    Berkshire
    Secretario
    14 Comfrey Close
    RG40 5YN Wokingham
    Berkshire
    British51725180001
    HOW, David Alfred George
    Michaelmas Fair
    Ashdon
    CB10 2JE Saffron Walden
    Essex
    Secretario
    Michaelmas Fair
    Ashdon
    CB10 2JE Saffron Walden
    Essex
    British36176510001
    MIFFLIN, Marion Geraldine
    The Arles
    16 Greenfield Drive
    HR5 3AD Kington
    Herefordshire
    Secretario
    The Arles
    16 Greenfield Drive
    HR5 3AD Kington
    Herefordshire
    British14318020001
    PALMER, Keith
    Bute House
    Hill Lane
    WR10 3HU Elmley Castle
    Worcestershire
    Secretario
    Bute House
    Hill Lane
    WR10 3HU Elmley Castle
    Worcestershire
    British79386550001
    STREATFIELD, Paul Richard
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    Secretario
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    British49339260001
    ANGEL, Jeremy
    50 Meole Rise
    SY3 9JF Shrewsbury
    Salop
    Director
    50 Meole Rise
    SY3 9JF Shrewsbury
    Salop
    British71195330001
    ASKHAM, Francis Guy Lewis
    Spinney Corner Church Lane
    Braishfield
    SO51 0QH Romsey
    Hampshire
    Director
    Spinney Corner Church Lane
    Braishfield
    SO51 0QH Romsey
    Hampshire
    United KingdomBritish15237500001
    BAINTON, Adrian Richard
    2 Oak Drive
    Burghfield Common
    RG7 3JF Reading
    Berkshire
    Director
    2 Oak Drive
    Burghfield Common
    RG7 3JF Reading
    Berkshire
    EnglandBritish14830800001
    BENCE, John Albert
    25 Oakdene
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    Director
    25 Oakdene
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish69524150001
    BLACK, Stephen
    Les Vielles Terres
    Havelet
    GY1 1AZ St Peter Port
    Guernsey
    Director
    Les Vielles Terres
    Havelet
    GY1 1AZ St Peter Port
    Guernsey
    British73554610001
    BRENTNALL, Trevor Alan
    Dolloways House
    Howbourne Lane
    TN22 4DR Buxted
    East Sussex
    Director
    Dolloways House
    Howbourne Lane
    TN22 4DR Buxted
    East Sussex
    British39686000001
    BRETT, Jamie
    Cwmma Green Cottage
    Brilley
    HR3 6JP Whitney On Wye
    Herefordshire
    Director
    Cwmma Green Cottage
    Brilley
    HR3 6JP Whitney On Wye
    Herefordshire
    British77234080001
    BREWIN, Peter Ronald
    Nutwood House
    The Street
    TN15 0QE Plaxtol
    Sevenoaks Kent
    Director
    Nutwood House
    The Street
    TN15 0QE Plaxtol
    Sevenoaks Kent
    British45850380001
    BROWN, Robert Martin
    81 Browning Road
    Grantley Park Church Crookham
    GU52 0YY Fleet
    Hampshire
    Director
    81 Browning Road
    Grantley Park Church Crookham
    GU52 0YY Fleet
    Hampshire
    British75375360001
    FIORANELLI, Giorgio
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Director
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    ItalyItalian163032950001
    GIORDANO, Amanda Jayne
    Maesmellan
    New Radnor
    LD8 2TN Presteigne
    Powys
    Director
    Maesmellan
    New Radnor
    LD8 2TN Presteigne
    Powys
    British14318030001
    HEYNEKER, Gerardus James
    24 Fox Lane
    Oakley
    RG23 7BB Basingstoke
    Hampshire
    Director
    24 Fox Lane
    Oakley
    RG23 7BB Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritish16423710001
    HOW, David Alfred George, Mr.
    Michaelmas Fair
    Ashdon
    CB10 2JE Saffron Walden
    Essex
    Director
    Michaelmas Fair
    Ashdon
    CB10 2JE Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritish21860001
    HOWAT, James Anthony
    Lea Farmhouse
    Bishops Offley
    ST21 6EU Stafford
    Director
    Lea Farmhouse
    Bishops Offley
    ST21 6EU Stafford
    UkBritish41852290001
    LITWINOWICZ, Leszek Richard
    72 Rosemary Hill Road
    Streetly
    B74 4HJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    72 Rosemary Hill Road
    Streetly
    B74 4HJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish70815770002
    MAZZOTTA, Salvo
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Director
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    UsaItalian163043060001
    MIDDLETON, Trevor
    High House
    Old Warwick Road
    CV35 7AA Rowington
    Warwickshire
    Director
    High House
    Old Warwick Road
    CV35 7AA Rowington
    Warwickshire
    EnglandBritish221486370001
    MIFFLIN, Marion Geraldine
    The Arles
    16 Greenfield Drive
    HR5 3AD Kington
    Herefordshire
    Director
    The Arles
    16 Greenfield Drive
    HR5 3AD Kington
    Herefordshire
    British14318020001
    MIFFLIN, Philip George Thomas
    The Arles
    16 Greenfield Drive
    HR5 3AD Kington
    Herefordshire
    Director
    The Arles
    16 Greenfield Drive
    HR5 3AD Kington
    Herefordshire
    British14318070001
    PALMER, Keith
    Bute House
    Hill Lane
    WR10 3HU Elmley Castle
    Worcestershire
    Director
    Bute House
    Hill Lane
    WR10 3HU Elmley Castle
    Worcestershire
    EnglandBritish79386550001
    SALTER, Edward John
    Devon Road
    WV1 4BE Wolverhampton
    14
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    Devon Road
    WV1 4BE Wolverhampton
    14
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish87426020002
    STREATFIELD, Paul Richard
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    Director
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    British49339260001
    WILLIAMS, Ian Ralph
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    Director
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    British19140250001

    ¿Tiene BEPCO AGRI LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 19 feb 2007
    Entregado el 22 feb 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Kbc Bank Nv
    Transacciones
    • 22 feb 2007Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 17 oct 2002
    Entregado el 29 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The f/h property k/a or being unit 2 hatton gardens industrial estate kington herefordshire HR5 3RB. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 29 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 22 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 17 oct 2002
    Entregado el 29 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 29 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 22 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Trust debenture
    Creado el 17 oct 2002
    Entregado el 23 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company as an obligor to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Close Investment Partners Limited
    Transacciones
    • 23 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 22 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 12 ene 1998
    Entregado el 27 ene 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to midland bank PLC including all monies, obligations and liabilities, due owing or incurred under or pursuant to the secured documents (as defined) and irrevocably and unconditionally guarantees the due performance by each other company of all it's obligations under or pursuant to the secured documents to which it is a party
    Breve descripción
    For full details of all charged assets please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 27 ene 1998Registro de un cargo (395)
    • 29 oct 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 05 abr 1991
    Entregado el 09 abr 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding uncalled capital. Those mentioned above).
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 09 abr 1991Registro de una carga
    • 02 feb 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 26 ene 1989
    Entregado el 03 feb 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 03 feb 1989Registro de una carga
    • 21 ago 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge on book debts
    Creado el 21 ago 1986
    Entregado el 28 ago 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge on all book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 28 ago 1986Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 27 sept 1984
    Entregado el 05 oct 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a facility letter dated 9/7/84 and the guarantee dated 17/8/84
    Breve descripción
    F/H land comprising of 0.59 an acre (0.238 hectares) or thereabouts together with the premises erected thereon unit 2,hatton garden industrial estate, kington in the county of hereford & worcester.
    Personas con derecho
    • English Industrial Estates Corporation.
    Transacciones
    • 05 oct 1984Registro de una carga
    • 21 dic 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0