KELLY'S KITCHEN LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | KELLY'S KITCHEN LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01450319 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de KELLY'S KITCHEN LIMITED?
- (9999) /
¿Dónde se encuentra KELLY'S KITCHEN LIMITED?
Dirección de la sede social | 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KELLY'S KITCHEN LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
KELLYS KITCHEN LIMITED | 16 ene 1985 | 16 ene 1985 |
BERRYPAY LIMITED | 22 nov 1983 | 22 nov 1983 |
CARDROME LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
BABVISION LIMITED | 25 sept 1979 | 25 sept 1979 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de KELLY'S KITCHEN LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2008 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para KELLY'S KITCHEN LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 17 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cambio de datos del director Guy Paul Cuthbert Parsons el 03 feb 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Paul Victor Harvey el 03 feb 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Grant David Hearn el 03 feb 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Jon William Mortimore el 03 feb 2010 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Jon William Mortimore el 03 feb 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 05 nov 2009 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008 | 3 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 5 páginas | 363a | ||||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007 | 3 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | 288c | ||||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006 | 3 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | 288c | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | 288c | ||||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2005 | 3 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2004 | 3 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a |
¿Quiénes son los directivos de KELLY'S KITCHEN LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORTIMORE, Jon William | Secretario | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | British | Company Director | 93906210001 | |||||
A G SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||
HARVEY, Paul Victor | Director | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 116809270002 | ||||
HEARN, Grant David | Director | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | England | British | Company Director | 88628480002 | ||||
MORTIMORE, Jon William | Director | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 93906210001 | ||||
PARSONS, Guy Paul Cuthbert | Director | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 102187770002 | ||||
HICKS, Christopher Michael | Secretario | Valpy Cottage 3 St Andrews Road RG4 7PH Reading Berkshire | British | Accountant | 53932930001 | |||||
JACKSON, Kevin David | Secretario | Field House 147 Main Street Sutton Bonington LE12 5PE Loughborough | British | Director | 141586330001 | |||||
MASON, Timothy Charles | Secretario | 231 Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | British | 12314170002 | ||||||
MATHEWS, Benedict John Spurway | Secretario | 39 Lower Teddington Road KT1 4HQ Hampton Wick Flat 3 Surrey | British | 42217530001 | ||||||
MILLS, John Michael | Secretario | 33 Peplins Way AL9 7UR Brookmans Park Hertfordshire | British | 42268710001 | ||||||
MITCHLEY, Simon Colin | Secretario | 8 Priory Road IG10 1AF Loughton Essex | British | Company Secretary | 36355940001 | |||||
SMALL, Jeremy Peter | Secretario | Cherry Trees West Heath GU24 0JQ Pirbright Surrey | British | 67168210001 | ||||||
TAUTZ, Helen Jane | Secretario | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | British | 37564540001 | ||||||
WILSON, Paul James | Secretario | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | 767650001 | ||||||
FORTE NOMINEES LIMITED | Secretario corporativo | 166 High Holborn WC1V 6TT London | 42198970001 | |||||||
CLACK, Peter Melvyn | Director | 37 Keswick Road Great Bookham KT23 4BQ Leatherhead Surrey | British | Financial Director | 7668050002 | |||||
EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey | Director | The Croft Chalfont Lane Chorleywood WD3 5PP Rickmansworth Hertfordshire | England | British | Solicitor Company Secretary | 49678170001 | ||||
HICKS, Christopher Michael | Director | Valpy Cottage 3 St Andrews Road RG4 7PH Reading Berkshire | British | Accountant | 53932930001 | |||||
JACKSON, Kevin David | Director | Field House 147 Main Street Sutton Bonington LE12 5PE Loughborough | England | British | Director | 141586330001 | ||||
MILLS, John Michael | Director | 33 Peplins Way AL9 7UR Brookmans Park Hertfordshire | British | Chartered Secretary | 42268710001 | |||||
MONNICKENDAM, Anthony Louis | Director | Auburn House 39 High Street MK46 4EB Olney Buckinghamshire | United Kingdom | British | Managing Director | 1013880003 | ||||
SMITH, Peter David | Director | Grantchester Portesbery Hill Drive GU15 3TP Camberley Surrey | British | Managing Director | 21114610001 | |||||
STEVENS, David John | Director | 42 Burghley Road Wimbledon SW19 5HN London | British | Group Legal Director | 56704240001 | |||||
TAUTZ, Helen Jane | Director | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | United Kingdom | British | Cs | 37564540001 | ||||
TURL, Simon Charles | Director | Arden House Eastwell Road LE14 4SS Scalford Leicestershire | British | Director | 80261230001 | |||||
TURNER, Harry | Director | Shepherds Cottage The Vale Golf & Country Club Bishampton Fields WR10 2LZ Bishampton Near Pershore Worcestershire | England | British | Chief Operating Officer | 166789700001 | ||||
WILSON, Paul James | Director | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | Company Secretary | 767650001 | |||||
FORTE (UK) LIMITED | Director corporativo | 166 High Holborn WC1V 6TT London | 42204690001 | |||||||
TRAVELREST SERVICES LIMITED | Director corporativo | Parklands Court 24 Parklands Birmingham Great Park Rubery B45 9PZ Birmingham West Midlands | 42204690005 |
¿Tiene KELLY'S KITCHEN LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Mortgage | Creado el 10 mar 1987 Entregado el 27 mar 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 19/12/85 | |
Breve descripción All that piece or parcel of land k/a black cat bungalow restaurant and filling station great north road chawston roxton parish bedfordshire t/no bd 70603 & bd 92124. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 15 ago 1986 Entregado el 02 sept 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the the terms of a debenture | |
Breve descripción L/Hold land on the south east side of rykneld street, fradley, staffordshire title no. Sf 223429. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 02 jul 1986 Entregado el 23 jul 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descripción Piece or parcel of f/h land adjoining lawlors of wellingborough (formerly seamarks garage) a 45 higham road little irchester county of northampton. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 17 jun 1986 Entregado el 23 jun 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descripción F/H piece or parcel of land having a frontage to brook street, brentwood county of essex together with the messvage or dwellinghouse erected thereon or on some dart thereof k/a 65 brook street, brentwood, county of essex. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 10 ene 1986 Entregado el 14 ene 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descripción All that piece or parcel of land at fradley inthe county of stafford. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 23 dic 1985 Entregado el 09 ene 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 19/12/85 | |
Breve descripción All that piece or parcel of land situate in the parish of coddenham in the county of suffolk comprising 5.80 acres or therabouts. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 19 dic 1985 Entregado el 09 ene 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 19/12/85 | |
Breve descripción Part of land adjoining sanders lodge rushden northamptonshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 19 dic 1985 Entregado el 06 ene 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Charge | Creado el 27 may 1980 Entregado el 13 jun 1980 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £400,000 and further sums to be advanced to cerlana limited and all other monies hereby secured | |
Breve descripción Land at upper rainham road, hornchurch in the london borough of havering together with eardrome thereon (see doc M19). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0