KELLY'S KITCHEN LIMITED

KELLY'S KITCHEN LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKELLY'S KITCHEN LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01450319
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KELLY'S KITCHEN LIMITED?

    • (9999) /

    ¿Dónde se encuentra KELLY'S KITCHEN LIMITED?

    Dirección de la sede social
    100 Barbirolli Square
    Manchester
    M2 3AB
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KELLY'S KITCHEN LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    KELLYS KITCHEN LIMITED16 ene 198516 ene 1985
    BERRYPAY LIMITED22 nov 198322 nov 1983
    CARDROME LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    BABVISION LIMITED25 sept 197925 sept 1979

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KELLY'S KITCHEN LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KELLY'S KITCHEN LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Resoluciones

    Resolutions
    17 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación del Memorándum y/o Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resoluciones

    Re sect 175 12/03/2010
    RES13

    Cambio de datos del director Guy Paul Cuthbert Parsons el 03 feb 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Paul Victor Harvey el 03 feb 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Grant David Hearn el 03 feb 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Jon William Mortimore el 03 feb 2010

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Jon William Mortimore el 03 feb 2010

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 dic 2009

    Estado de capital el 03 dic 2009

    • Capital: GBP 415,223
    SH01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    3 páginasAA

    legacy

    5 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    3 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288c

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006

    3 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288c

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2005

    3 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2004

    3 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de KELLY'S KITCHEN LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MORTIMORE, Jon William
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Secretario
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    BritishCompany Director93906210001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    HARVEY, Paul Victor
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Director
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant116809270002
    HEARN, Grant David
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Director
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director88628480002
    MORTIMORE, Jon William
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Director
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director93906210001
    PARSONS, Guy Paul Cuthbert
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Director
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director102187770002
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Secretario
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    BritishAccountant53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Secretario
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    BritishDirector141586330001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Secretario
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British12314170002
    MATHEWS, Benedict John Spurway
    39 Lower Teddington Road
    KT1 4HQ Hampton Wick
    Flat 3
    Surrey
    Secretario
    39 Lower Teddington Road
    KT1 4HQ Hampton Wick
    Flat 3
    Surrey
    British42217530001
    MILLS, John Michael
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    Secretario
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    British42268710001
    MITCHLEY, Simon Colin
    8 Priory Road
    IG10 1AF Loughton
    Essex
    Secretario
    8 Priory Road
    IG10 1AF Loughton
    Essex
    BritishCompany Secretary36355940001
    SMALL, Jeremy Peter
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    Secretario
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    British67168210001
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Secretario
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    British37564540001
    WILSON, Paul James
    47 Wordsworth Drive
    SM3 8HE Cheam
    Surrey
    Secretario
    47 Wordsworth Drive
    SM3 8HE Cheam
    Surrey
    British767650001
    FORTE NOMINEES LIMITED
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    Secretario corporativo
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    42198970001
    CLACK, Peter Melvyn
    37 Keswick Road
    Great Bookham
    KT23 4BQ Leatherhead
    Surrey
    Director
    37 Keswick Road
    Great Bookham
    KT23 4BQ Leatherhead
    Surrey
    BritishFinancial Director7668050002
    EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    Director
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritishSolicitor Company Secretary49678170001
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Director
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    BritishAccountant53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Director
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    EnglandBritishDirector141586330001
    MILLS, John Michael
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    Director
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    BritishChartered Secretary42268710001
    MONNICKENDAM, Anthony Louis
    Auburn House
    39 High Street
    MK46 4EB Olney
    Buckinghamshire
    Director
    Auburn House
    39 High Street
    MK46 4EB Olney
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishManaging Director1013880003
    SMITH, Peter David
    Grantchester Portesbery Hill Drive
    GU15 3TP Camberley
    Surrey
    Director
    Grantchester Portesbery Hill Drive
    GU15 3TP Camberley
    Surrey
    BritishManaging Director21114610001
    STEVENS, David John
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    Director
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    BritishGroup Legal Director56704240001
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Director
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    United KingdomBritishCs37564540001
    TURL, Simon Charles
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    Director
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    BritishDirector80261230001
    TURNER, Harry
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    Director
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritishChief Operating Officer166789700001
    WILSON, Paul James
    47 Wordsworth Drive
    SM3 8HE Cheam
    Surrey
    Director
    47 Wordsworth Drive
    SM3 8HE Cheam
    Surrey
    BritishCompany Secretary767650001
    FORTE (UK) LIMITED
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    Director corporativo
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    42204690001
    TRAVELREST SERVICES LIMITED
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    Director corporativo
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    42204690005

    ¿Tiene KELLY'S KITCHEN LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage
    Creado el 10 mar 1987
    Entregado el 27 mar 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 19/12/85
    Breve descripción
    All that piece or parcel of land k/a black cat bungalow restaurant and filling station great north road chawston roxton parish bedfordshire t/no bd 70603 & bd 92124.
    Personas con derecho
    • Petrofina (UK) Limited
    Transacciones
    • 27 mar 1987Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 15 ago 1986
    Entregado el 02 sept 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the the terms of a debenture
    Breve descripción
    L/Hold land on the south east side of rykneld street, fradley, staffordshire title no. Sf 223429.
    Personas con derecho
    • Petrofina (UK) Limited
    Transacciones
    • 02 sept 1986Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 02 jul 1986
    Entregado el 23 jul 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    Piece or parcel of f/h land adjoining lawlors of wellingborough (formerly seamarks garage) a 45 higham road little irchester county of northampton.
    Personas con derecho
    • Petrofina (UK) Limited
    Transacciones
    • 23 jul 1986Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 17 jun 1986
    Entregado el 23 jun 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    F/H piece or parcel of land having a frontage to brook street, brentwood county of essex together with the messvage or dwellinghouse erected thereon or on some dart thereof k/a 65 brook street, brentwood, county of essex.
    Personas con derecho
    • Petrofina (UK) Limited
    Transacciones
    • 23 jun 1986Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 10 ene 1986
    Entregado el 14 ene 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    All that piece or parcel of land at fradley inthe county of stafford.
    Personas con derecho
    • Petrofina (UK) Limited
    Transacciones
    • 14 ene 1986Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 23 dic 1985
    Entregado el 09 ene 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 19/12/85
    Breve descripción
    All that piece or parcel of land situate in the parish of coddenham in the county of suffolk comprising 5.80 acres or therabouts.
    Personas con derecho
    • Petrofina (UK) Limited
    Transacciones
    • 09 ene 1986Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 19 dic 1985
    Entregado el 09 ene 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 19/12/85
    Breve descripción
    Part of land adjoining sanders lodge rushden northamptonshire.
    Personas con derecho
    • Petrofina (UK) Limited
    Transacciones
    • 09 ene 1986Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 19 dic 1985
    Entregado el 06 ene 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Petrofina (UK) Limited
    Transacciones
    • 06 ene 1986Registro de una carga
    Charge
    Creado el 27 may 1980
    Entregado el 13 jun 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £400,000 and further sums to be advanced to cerlana limited and all other monies hereby secured
    Breve descripción
    Land at upper rainham road, hornchurch in the london borough of havering together with eardrome thereon (see doc M19).
    Personas con derecho
    • Tesco Stores Limited
    Transacciones
    • 13 jun 1980Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0