SIG TRADING LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SIG TRADING LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01451007 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SIG TRADING LIMITED?
- Otros trabajos de acabado y terminación de edificios (43390) / Construcción
- Agentes involucrados en la venta de madera y materiales de construcción (46130) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra SIG TRADING LIMITED?
| Dirección de la sede social | Adsetts House 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SIG TRADING LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CPD DISTRIBUTION PLC | 14 dic 1999 | 14 dic 1999 |
| ROSKEL PLC | 30 mar 1988 | 30 mar 1988 |
| ROSKEL HOLDING CO., LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
| ROSKEL PROPERTY CO., LIMITED | 27 sept 1979 | 27 sept 1979 |
| SHOOTBERRY LIMITED | 27 sept 1979 | 27 sept 1979 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SIG TRADING LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SIG TRADING LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 08 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 22 jun 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 08 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SIG TRADING LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital el 20 dic 2025
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 15 dic 2025
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de David Ian Hope como director el 31 oct 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 55 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 20 dic 2024
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Howard Paul Luft como director el 20 nov 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 26 páginas | MA | ||||||||||||||
Registro de la carga 014510070010, creada el 25 oct 2024 | 25 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Registro de la carga 014510070009, creada el 25 oct 2024 | 39 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 52 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Hewitt Burnley como director el 01 sept 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Philip William Arthur Johns como director el 25 ago 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Ian Jackson como director el 25 ago 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 55 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr David Ian Hope como director el 14 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Richard Hewitt Burnley como director el 14 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SIG TRADING LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATKINS, Andrew | Secretario | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | 281611790001 | |||||||
| ASHTON, Richard Ian | Director | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | 271608130002 | |||||
| JACKSON, Ian | Director | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | 186473820002 | |||||
| LODGE, Christopher David | Director | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | England | British | 189424350001 | |||||
| LUFT, Howard Paul | Director | S9 1XH Sheffield Adssets House, 16 Europa View England England | United Kingdom | British | 330411860001 | |||||
| DOSANJH, Kulbinder Kaur | Secretario | Eastbourne Terrace W2 6LG London 10 United Kingdom | 263760110001 | |||||||
| JORDAN, Christopher | Secretario | 16 Mead Rise Edgbaston B15 3SD Birmingham | British | 9841450001 | ||||||
| MONRO, Richard Charles | Secretario | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | British | 59480370001 | ||||||
| SWYNNERTON, John Ralph | Secretario | 30 Bents Road S11 9RJ Sheffield South Yorkshire | British | 2646260001 | ||||||
| APPLETON, George | Director | 21 New Garden Street ST17 4DB Stafford Staffordshire | British | 79234540001 | ||||||
| BARCLAY, Robert | Director | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | United Kingdom | British | 124856170002 | |||||
| BOWERS, Malcolm | Director | Myrefield Cottage Lea Lane Millhouse Green S30 6NN Sheffield South Yorkshire | British | 31716030001 | ||||||
| BURNLEY, Richard Hewitt | Director | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | 124856160001 | |||||
| DAVIES, Gareth Wyn | Director | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | England | British | 109674760001 | |||||
| DOSANJH, Kulbinder Kaur | Director | Eastbourne Terrace W2 6LG London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 231199720001 | |||||
| ENRIGHT, John Christopher | Director | 18 Barleyfield Way Houghton Regis LU5 5ER Dunstable Bedfordshire | United Kingdom | British | 37832720001 | |||||
| FITZPATRICK, David Antony Stephen | Director | 10 Ibbetson Oval Churwell LS27 7RY Leeds West Yorkshire | British | 74715850001 | ||||||
| FORRESTER, William Wilson | Director | Coombs Hay 16 Burre Close DE45 1GD Bakewell Derbyshire | England | British | 27743040001 | |||||
| FORTIN, Richard Chalmers Gordon | Director | 5 Dealtry Road Putney SW15 6NL London | British | 31479720001 | ||||||
| FOTHERINGHAM, Colin George Ewing | Director | Pond View Drain Lane Holme On Spalding Moor YO43 4DQ York East Yorkshire | United Kingdom | British | 82642480001 | |||||
| FRANCIS, Stephen Ronald William | Director | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | 205102630002 | |||||
| GEORGE, Victoria Anne | Director | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | 134024500001 | |||||
| HARRIS, Roger David | Director | Blandford Cottage Weston Green Road KT7 0HZ Thames Ditton Surrey | British | 10929020002 | ||||||
| HOPE, David Ian | Director | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | 310229620001 | |||||
| HUDSON, Jonathan Adrian | Director | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | United Kingdom | British | 27743810004 | |||||
| JACKSON, Ian | Director | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | 186473820002 | |||||
| JOHNS, Philip William Arthur | Director | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | 269367530001 | |||||
| JORDAN, Christopher | Director | 16 Mead Rise Edgbaston B15 3SD Birmingham | British | 9841450001 | ||||||
| KEARNEY-CROFT, Katharina Helen Marie | Director | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | England | British | 291529900001 | |||||
| MADDOCK, Nicholas William | Director | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | England | British | 171817240004 | |||||
| MANDER, Andrew | Director | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | England | British | 40579430008 | |||||
| MONRO, Richard Charles | Director | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | 59480370001 | |||||
| MYATT, Richard Geoffrey | Director | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | England | British | 172018060003 | |||||
| NAPTIN, Martin Alexander | Director | 5 The Crofts Hatchwarren RG22 4RE Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | 74715950001 | |||||
| PARTRIDGE, Brian Joseph | Director | Andira 8 Thruffle Way Bar Hill CB3 8TR Cambridge Cambridgeshire | England | British | 10934160001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SIG TRADING LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sig Plc | 06 abr 2016 | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0