SIG TRADING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSIG TRADING LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01451007
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SIG TRADING LIMITED?

    • Otros trabajos de acabado y terminación de edificios (43390) / Construcción
    • Agentes involucrados en la venta de madera y materiales de construcción (46130) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra SIG TRADING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Adsetts House 16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SIG TRADING LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CPD DISTRIBUTION PLC14 dic 199914 dic 1999
    ROSKEL PLC30 mar 198830 mar 1988
    ROSKEL HOLDING CO., LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    ROSKEL PROPERTY CO., LIMITED27 sept 197927 sept 1979
    SHOOTBERRY LIMITED27 sept 197927 sept 1979

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SIG TRADING LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2025
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SIG TRADING LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta08 jun 2026
    Próxima declaración de confirmación vence22 jun 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta08 jun 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SIG TRADING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de eliminación de derechos de suscripción preferente

    RES11
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Estado de capital el 20 dic 2025

    • Capital: GBP 300
    3 páginasSH19

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancel share premium 15/12/2025
    RES13

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 15 dic 2025

    • Capital: GBP 300
    3 páginasSH01

    Cese del nombramiento de David Ian Hope como director el 31 oct 2025

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024

    55 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2025 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de eliminación de derechos de suscripción preferente

    RES11
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 20 dic 2024

    • Capital: GBP 200
    3 páginasSH01

    Nombramiento de Mr Howard Paul Luft como director el 20 nov 2024

    2 páginasAP01

    Memorándum y Estatutos

    26 páginasMA

    Registro de la carga 014510070010, creada el 25 oct 2024

    25 páginasMR01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Registro de la carga 014510070009, creada el 25 oct 2024

    39 páginasMR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023

    52 páginasAA

    Cese del nombramiento de Richard Hewitt Burnley como director el 01 sept 2024

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Philip William Arthur Johns como director el 25 ago 2023

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Ian Jackson como director el 25 ago 2023

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022

    55 páginasAA

    Nombramiento de Mr David Ian Hope como director el 14 jun 2023

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Richard Hewitt Burnley como director el 14 jun 2023

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2023 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de SIG TRADING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WATKINS, Andrew
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Secretario
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    281611790001
    ASHTON, Richard Ian
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Director
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritish271608130002
    JACKSON, Ian
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Director
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritish186473820002
    LODGE, Christopher David
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Director
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    EnglandBritish189424350001
    LUFT, Howard Paul
    S9 1XH Sheffield
    Adssets House, 16 Europa View
    England
    England
    Director
    S9 1XH Sheffield
    Adssets House, 16 Europa View
    England
    England
    United KingdomBritish330411860001
    DOSANJH, Kulbinder Kaur
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    Secretario
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    263760110001
    JORDAN, Christopher
    16 Mead Rise
    Edgbaston
    B15 3SD Birmingham
    Secretario
    16 Mead Rise
    Edgbaston
    B15 3SD Birmingham
    British9841450001
    MONRO, Richard Charles
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Secretario
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    British59480370001
    SWYNNERTON, John Ralph
    30 Bents Road
    S11 9RJ Sheffield
    South Yorkshire
    Secretario
    30 Bents Road
    S11 9RJ Sheffield
    South Yorkshire
    British2646260001
    APPLETON, George
    21 New Garden Street
    ST17 4DB Stafford
    Staffordshire
    Director
    21 New Garden Street
    ST17 4DB Stafford
    Staffordshire
    British79234540001
    BARCLAY, Robert
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Director
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    United KingdomBritish124856170002
    BOWERS, Malcolm
    Myrefield Cottage
    Lea Lane Millhouse Green
    S30 6NN Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    Myrefield Cottage
    Lea Lane Millhouse Green
    S30 6NN Sheffield
    South Yorkshire
    British31716030001
    BURNLEY, Richard Hewitt
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Director
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritish124856160001
    DAVIES, Gareth Wyn
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Director
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    EnglandBritish109674760001
    DOSANJH, Kulbinder Kaur
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    Director
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish231199720001
    ENRIGHT, John Christopher
    18 Barleyfield Way
    Houghton Regis
    LU5 5ER Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    18 Barleyfield Way
    Houghton Regis
    LU5 5ER Dunstable
    Bedfordshire
    United KingdomBritish37832720001
    FITZPATRICK, David Antony Stephen
    10 Ibbetson Oval
    Churwell
    LS27 7RY Leeds
    West Yorkshire
    Director
    10 Ibbetson Oval
    Churwell
    LS27 7RY Leeds
    West Yorkshire
    British74715850001
    FORRESTER, William Wilson
    Coombs Hay
    16 Burre Close
    DE45 1GD Bakewell
    Derbyshire
    Director
    Coombs Hay
    16 Burre Close
    DE45 1GD Bakewell
    Derbyshire
    EnglandBritish27743040001
    FORTIN, Richard Chalmers Gordon
    5 Dealtry Road
    Putney
    SW15 6NL London
    Director
    5 Dealtry Road
    Putney
    SW15 6NL London
    British31479720001
    FOTHERINGHAM, Colin George Ewing
    Pond View Drain Lane
    Holme On Spalding Moor
    YO43 4DQ York
    East Yorkshire
    Director
    Pond View Drain Lane
    Holme On Spalding Moor
    YO43 4DQ York
    East Yorkshire
    United KingdomBritish82642480001
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Director
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritish205102630002
    GEORGE, Victoria Anne
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Director
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritish134024500001
    HARRIS, Roger David
    Blandford Cottage
    Weston Green Road
    KT7 0HZ Thames Ditton
    Surrey
    Director
    Blandford Cottage
    Weston Green Road
    KT7 0HZ Thames Ditton
    Surrey
    British10929020002
    HOPE, David Ian
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Director
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritish310229620001
    HUDSON, Jonathan Adrian
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Director
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    United KingdomBritish27743810004
    JACKSON, Ian
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Director
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritish186473820002
    JOHNS, Philip William Arthur
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Director
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritish269367530001
    JORDAN, Christopher
    16 Mead Rise
    Edgbaston
    B15 3SD Birmingham
    Director
    16 Mead Rise
    Edgbaston
    B15 3SD Birmingham
    British9841450001
    KEARNEY-CROFT, Katharina Helen Marie
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Director
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    EnglandBritish291529900001
    MADDOCK, Nicholas William
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Director
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    EnglandBritish171817240004
    MANDER, Andrew
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Director
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    EnglandBritish40579430008
    MONRO, Richard Charles
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Director
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritish59480370001
    MYATT, Richard Geoffrey
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Director
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    EnglandBritish172018060003
    NAPTIN, Martin Alexander
    5 The Crofts
    Hatchwarren
    RG22 4RE Basingstoke
    Hampshire
    Director
    5 The Crofts
    Hatchwarren
    RG22 4RE Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritish74715950001
    PARTRIDGE, Brian Joseph
    Andira 8 Thruffle Way
    Bar Hill
    CB3 8TR Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    Andira 8 Thruffle Way
    Bar Hill
    CB3 8TR Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritish10934160001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de SIG TRADING LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    06 abr 2016
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro00998314
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0