BANNER HOMES SOUTHERN LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BANNER HOMES SOUTHERN LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01453522 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BANNER HOMES SOUTHERN LIMITED?
- Construcción de edificios domésticos (41202) / Construcción
¿Dónde se encuentra BANNER HOMES SOUTHERN LIMITED?
| Dirección de la sede social | Cala House 54 The Causeway TW18 3AX Staines Upon Thames Surrey |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BANNER HOMES SOUTHERN LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BANNER HOMES (WESSEX) LIMITED | 17 abr 2002 | 17 abr 2002 |
| BANNER HOMES (MIDLANDS) LTD. | 22 ene 1991 | 22 ene 1991 |
| DEBENTURE SECURITIES LIMITED | 11 oct 1979 | 11 oct 1979 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BANNER HOMES SOUTHERN LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BANNER HOMES SOUTHERN LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 12 oct 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 26 oct 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 12 oct 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BANNER HOMES SOUTHERN LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Mr Thomas Marshall Nicholson como director el 15 dic 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cambio de datos del director Mr Michael Daniel Rice el 03 dic 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Neil John Stoddart como director el 01 sept 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2024 | 6 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Michael Daniel Rice como director el 30 jun 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas no auditadas abreviadas presentadas hasta el 31 dic 2022 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 6 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Neil John Stoddart el 03 mar 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 6 páginas | AA | ||
Cancelación total de la carga 014535220073 | 1 páginas | MR04 | ||
Cese del nombramiento de John Graham Gunn Reid como director el 31 oct 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Kevin Whitaker como director el 01 ago 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 jun 2018 au 31 dic 2018 | 1 páginas | AA01 | ||
Nombramiento de Mr Neil John Stoddart como director el 30 abr 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de BANNER HOMES SOUTHERN LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDGE SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 52-54 Rose Street AB10 1HA Aberdeen Johnstone House Aberdeenshire Scotland |
| 187436120001 | ||||||||||
| NICHOLSON, Thomas Marshall | Director | 5 Mid New Cultins EH11 4DU Edinburgh Adam House United Kingdom | United Kingdom | British | 288471310001 | |||||||||
| RICE, Michael Daniel | Director | 5 Mid New Cultins EH11 4DU Edinburgh Adam House United Kingdom | United Kingdom | Irish | 337720630002 | |||||||||
| WHITAKER, Kevin | Director | 5 Mid New Cultins EH11 4DU Edinburgh Adam House Mid Lothian United Kingdom | United Kingdom | British | 97371590006 | |||||||||
| BARNARD, Patricia Angela | Secretario | Chimneypot Lodge Station Road RG9 1BB Henley On Thames Oxfordshire | British | 62665070002 | ||||||||||
| WALBOURN, Richard | Secretario | 54 The Causeway TW18 3AX Staines Upon Thames Cala House Surrey | British | 95240170002 | ||||||||||
| WERTH, Richard Graham | Secretario | Heathbourne Cottage Heathbourne Road Bushey Heath WD23 1PA Watford Hertfordshire | British | 2672540003 | ||||||||||
| BAILEY, Neville John Trevor | Director | 6 Mill End Close Pretwood HP16 0AP Great Missenden Bucks | England | British | 35550140006 | |||||||||
| BAILEY, Neville John Trevor | Director | 6 Mill End Close Pretwood HP16 0AP Great Missenden Bucks | England | British | 35550140006 | |||||||||
| BAILEY, Neville John Trevor | Director | 44 Parish Piece Holmer Green HP15 6SP High Wycombe Buckinghamshire | British | 35550140002 | ||||||||||
| BANFIELD, Geoffrey Piers | Director | Leycester House Farm Chesterton Road CV33 9NJ Harbury Warwickshire | England | British | 154389760001 | |||||||||
| BANFIELD, Geoffrey Piers | Director | 30 Inglethorpe Street SW6 6NT London | United Kingdom | British | 64984700002 | |||||||||
| BIGGS, Gary | Director | 4 Whitlet Close GU9 7XR Farnham Surrey | British | 124653240001 | ||||||||||
| BROWN, Alan Duke | Director | 54 The Causeway TW18 3AX Staines-Upon-Thames Cala House Surrey United Kingdom | England | British | 32640750005 | |||||||||
| COULON, Marcel John | Director | Half Hidden West Lane HP27 9PF Bledlow Buckinghamshire | United Kingdom | British | 62665340002 | |||||||||
| CROSSLEY, Stuart James | Director | Metcalfe Farm Village Lane Hedgerley SL2 3UY Slough Buckinghamshire | United Kingdom | British | 43489110001 | |||||||||
| CULL, David Geoffrey Maurice | Director | The Old Bank House High Street HP8 4QA Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 84076630002 | ||||||||||
| CUNNINGHAM, Graham Alan | Director | 54 The Causeway TW18 3AX Staines-Upon-Thames Cala House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 111786580001 | |||||||||
| DENNIS, Nicola Michelle | Director | 4 Guildford Drive SO53 3PT Chandlers Ford Hampshire | United Kingdom | British | 107182600001 | |||||||||
| DINEEN, Alastair | Director | Fir Road Ashurst SO40 7AZ Southampton 5 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 136495790001 | |||||||||
| GABB, Colin | Director | 23 Little Fryth RG40 3RN Wokingham Berkshire | England | British | 87309290001 | |||||||||
| KELLY, John Bernard | Director | 32 Saint Swithin Way SP10 4NU Andover Hampshire | British | 81602130001 | ||||||||||
| KENNEDY, John Anthony | Director | 21 Wildcroft Drive Russley Green RG40 3HY Wokingham Berkshire | England | British | 39630330003 | |||||||||
| KENNEDY, John Anthony | Director | 21 Wildcroft Drive Russley Green RG40 3HY Wokingham Berkshire | England | British | 39630330003 | |||||||||
| MURRAIN, Geoffrey | Director | 71a Preston Crowmarsh OX10 6SL Wallingford Oxfordshire | England | British | 65415940001 | |||||||||
| REID, John Graham Gunn | Director | 54 The Causeway TW18 3AX Staines-Upon-Thames Cala House Surrey United Kingdom | Scotland | British | 54537790003 | |||||||||
| RICHARDS, Alan Kenneth | Director | 9 Darwin Avenue BH23 2JA Christchurch Dorset | British | 83259820001 | ||||||||||
| SMITH, Allen William | Director | Langton House Brislands Lane Four Marks GU34 5AD Alton Hampshire | England | British | 39354960001 | |||||||||
| SMITH, Richard Anthony | Director | Wren Cottage Hillbury Road Alderholt SP6 3BH Fordingbridge Hampshire | British | 94945820001 | ||||||||||
| STODDART, Neil John | Director | 5 Mid New Cultins EH11 4DU Edinburgh Adam House Mid Lothian United Kingdom | Scotland | British | 83091000050 | |||||||||
| STRATFORD, Elaine | Director | 56 Pheasant Drive Downley HP13 5JW High Wycombe Buckinghamshire | United Kingdom | British | 97839630001 | |||||||||
| WALBOURN, Richard Alexander | Director | 54 The Causeway TW18 3AX Staines Upon Thames Cala House Surrey | United Kingdom | British | 95240170003 | |||||||||
| WERTH, Richard Graham | Director | Heathbourne Cottage Heathbourne Road Bushey Heath WD23 1PA Watford Hertfordshire | England | British | 2672540003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BANNER HOMES SOUTHERN LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banner Homes Limited | 06 abr 2016 | 54 The Causeway TW18 3AX Staines Cala House Surrey United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0