CHIEFTAIN GROUP LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CHIEFTAIN GROUP LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01455149 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
- fabricación de otros productos de metal n.c.o.p. (25990) / Industrias manufactureras
- Otras instalaciones de construcción (43290) / Construcción
- Otras actividades especializadas de construcción n.c.p. (43999) / Construcción
¿Dónde se encuentra CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Dirección de la sede social | c/o C/O REDHALL GROUP PLC Unit 3 Calder Close WF4 3BA Wakefield West Yorkshire England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CHIEFTAIN GROUP P.L.C. | 11 ago 1987 | 11 ago 1987 |
| CHIEFTAIN INSULATION LIMITED | 18 oct 1979 | 18 oct 1979 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 30 sept 2018 au 31 mar 2019 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 abr 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Registro de la carga 014551490013, creada el 24 ene 2019 | 46 páginas | MR01 | ||||||||||
Registro de la carga 014551490012, creada el 24 ene 2019 | 45 páginas | MR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Russell David Haworth el 10 ene 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Wayne Pearson como director el 03 nov 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Russell David Haworth como director el 03 nov 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Simon Philip Comer el 09 ago 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher John Kelly como secretario el 01 jul 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Philip Comer como secretario el 02 jul 2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher John Kelly como director el 29 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Philip Comer como director el 02 jul 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 abr 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Philip Brierley como director el 31 mar 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Wayne Pearson como director el 19 mar 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2017 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2016 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 abr 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O C/O Redhall Group Plc 1 Red Hall Court Wakefield West Yorkshire WF1 2UN a C/O C/O Redhall Group Plc Unit 3 Calder Close Wakefield West Yorkshire WF4 3BA el 05 ago 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2015 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 abr 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMER, Simon Philip | Secretario | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | 248241940001 | |||||||
| COMER, Simon Philip | Director | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | United Kingdom | British | 206088760003 | |||||
| HAWORTH, Russell David | Director | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 201533400002 | |||||
| ELLIOTT, Stanley, Fcma | Secretario | 12 Killiebrigs Heddon On The Wall NE15 0DD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 7203790001 | ||||||
| KELLY, Christopher John | Secretario | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | 187596050001 | |||||||
| LEWIS-JONES, Christopher | Secretario | Monks Lane Acton CW5 8LE Nantwich The Smithy Cheshire | British | 134974090001 | ||||||
| ADAMS, Laurence George | Director | 15 Rolley Way Castlefields NE42 5FH Prudhoe Northumberland | England | British | 87979230002 | |||||
| BRIERLEY, Philip | Director | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 54808010002 | |||||
| CORBISHLEY, Michael | Director | Overidge Farm Beckside Cartmel LA11 7SP Grange-Over-Sands Cumbria | England | British | 101553180002 | |||||
| COULSON, William Andrew | Director | 40 Holly Avenue Jesmond NE2 2PY Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 36723860001 | |||||
| CUTCHIE, Anthony William | Director | 68 Davison Avenue NE26 3SU Whitley Bay Tyne & Wear | United Kingdom | British | 45955990001 | |||||
| DAWSON, John Frederic | Director | Park Dale LS29 6LW Menston 1 West Yorkshire | British | 8366360002 | ||||||
| ELLIOTT, Stanley, Fcma | Director | 12 Killiebrigs Heddon On The Wall NE15 0DD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 7203790001 | ||||||
| FLEETWOOD, Christopher John | Director | 4 The Meadows DL10 7DU Richmond North Yorkshire | United Kingdom | British | 1718030001 | |||||
| FOSTER, Robert Simon | Director | Aish TQ10 9JG South Brent Stamford Devon | England | British | 134973970001 | |||||
| GOODENOUGH, Anthony | Director | Bakery Drive Grange Park TS19 0SN Stockton-On-Tees 1 Cleveland | England | British | 139196050001 | |||||
| IREDALE, George Henry Cecil | Director | Redmays 14 North Lodge Lambton Park DH3 4AZ Chester Le Street County Durham | British | 141871680001 | ||||||
| JACKSON, David James | Director | 10 Stone Rings Close HG2 9HZ Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 62867720010 | |||||
| JESTER, Tony | Director | 6 Cranbourne Drive TS10 2SP Redcar Cleveland | England | British | 107694130001 | |||||
| JOHNSON, Raymond | Director | 1 Colville Court DH9 6UW East Stanley County Durham | England | British | 266049760001 | |||||
| KELLY, Christopher John | Director | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 188444350001 | |||||
| LEWIS-JONES, Christopher | Director | Monks Lane Acton CW5 8LE Nantwich The Smithy Cheshire | England | British | 134974090001 | |||||
| MARTINDALE, Stephen Richard | Director | Am Waldeck 14 FOREIGN 34537 Bad Wildungen Germany | Germany | British | 77194110002 | |||||
| O'KANE, John Peter | Director | Station Lane Burton Leonard HG3 3RU Harrogate Holly Cottage North Yorkshire | United Kingdom | Irish | 106172200001 | |||||
| OLIVER, Malcolm William | Director | 12c Burtree Lane DL3 0XQ Darlington County Durham | England | British | 143300760001 | |||||
| PEARSON, Wayne | Director | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 212154420001 | |||||
| PENDLETON, Alan George | Director | 12 Harrop Road Hale WA15 9BX Altrincham Cheshire | British | 30248370001 | ||||||
| PRICE, Anthony Hall | Director | Irton CA19 1UZ Holmrook Mecklin Cumbria | England | British | 134973860001 | |||||
| SHIPPEN, Kenneth | Director | 14 Rectory Park NE61 2SZ Morpeth Northumberland | British | 67917400001 | ||||||
| SHUTTLEWORTH, Richard Peter | Director | c/o C/O Redhall Group Plc Red Hall Court WF1 2UN Wakefield 1 West Yorkshire England | England | British | 58727820002 | |||||
| TAYLOR, William Platt | Director | Ryton House Mainsforth DL17 9AA Ferryhill County Durham | British | 7203810001 | ||||||
| WARDLE, Peter | Director | 14 Brandling Park Jesmond NE2 4RR Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 73518260002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redhall Group Plc | 06 abr 2016 | Calder Close Durkar WF4 3BA Wakefield Unit 3 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CHIEFTAIN GROUP LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 24 ene 2019 Entregado el 29 ene 2019 | Pendiente | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 24 ene 2019 Entregado el 29 ene 2019 | Pendiente | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 24 dic 2015 Entregado el 02 ene 2016 | Pendiente | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 21 ene 2011 Entregado el 28 ene 2011 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 30 abr 2009 Entregado el 09 may 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee & debenture | Creado el 28 may 2004 Entregado el 17 jun 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Chattel mortgage | Creado el 09 sept 1996 Entregado el 12 sept 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Dean smith & grace model 20SB surfacing and boring lathe 29IN swing serial no 28803 richards model PR2N horizontal facing and boring machine serial no 28803 atlas copco model GA708 packaged rotary screw air compressor serial no 753329 and 753330 for further details please see form 395. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 01 ago 1996 Entregado el 13 ago 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Premises at bath street walker newcastle upon tyne tyne and wear t/no:- ty 7137. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee and debenture | Creado el 02 nov 1994 Entregado el 11 nov 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee and debenture | Creado el 26 ago 1992 Entregado el 09 sept 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción See doc ref M593C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee & debenture | Creado el 20 ene 1988 Entregado el 05 feb 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 03 jun 1985 Entregado el 11 jun 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All that land at arrow close, killingwood north tyneside, tyne & wear with the factory premises t/n ty 157748. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee & debenture | Creado el 21 sept 1984 Entregado el 28 sept 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or sheaffer fabrications limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0