CHIEFTAIN GROUP LIMITED

CHIEFTAIN GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCHIEFTAIN GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01455149
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CHIEFTAIN GROUP LIMITED?

    • fabricación de otros productos de metal n.c.o.p. (25990) / Industrias manufactureras
    • Otras instalaciones de construcción (43290) / Construcción
    • Otras actividades especializadas de construcción n.c.p. (43999) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra CHIEFTAIN GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o C/O REDHALL GROUP PLC
    Unit 3 Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    West Yorkshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CHIEFTAIN GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CHIEFTAIN GROUP P.L.C.11 ago 198711 ago 1987
    CHIEFTAIN INSULATION LIMITED18 oct 197918 oct 1979

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CHIEFTAIN GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CHIEFTAIN GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Exercice comptable précédent prolongé du 30 sept 2018 au 31 mar 2019

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 25 abr 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Registro de la carga 014551490013, creada el 24 ene 2019

    46 páginasMR01

    Registro de la carga 014551490012, creada el 24 ene 2019

    45 páginasMR01

    Cambio de datos del director Mr Russell David Haworth el 10 ene 2019

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Wayne Pearson como director el 03 nov 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Russell David Haworth como director el 03 nov 2018

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Mr Simon Philip Comer el 09 ago 2018

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Christopher John Kelly como secretario el 01 jul 2018

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Simon Philip Comer como secretario el 02 jul 2018

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Christopher John Kelly como director el 29 jun 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Simon Philip Comer como director el 02 jul 2018

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 25 abr 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Philip Brierley como director el 31 mar 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Wayne Pearson como director el 19 mar 2018

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2017

    8 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2016

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 25 abr 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O C/O Redhall Group Plc 1 Red Hall Court Wakefield West Yorkshire WF1 2UN a C/O C/O Redhall Group Plc Unit 3 Calder Close Wakefield West Yorkshire WF4 3BA el 05 ago 2016

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2015

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 abr 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 abr 2016

    Estado de capital el 29 abr 2016

    • Capital: GBP 450,925
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de CHIEFTAIN GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COMER, Simon Philip
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Secretario
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    248241940001
    COMER, Simon Philip
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Director
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish206088760003
    HAWORTH, Russell David
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Director
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish201533400002
    ELLIOTT, Stanley, Fcma
    12 Killiebrigs
    Heddon On The Wall
    NE15 0DD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secretario
    12 Killiebrigs
    Heddon On The Wall
    NE15 0DD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British7203790001
    KELLY, Christopher John
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Secretario
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    187596050001
    LEWIS-JONES, Christopher
    Monks Lane
    Acton
    CW5 8LE Nantwich
    The Smithy
    Cheshire
    Secretario
    Monks Lane
    Acton
    CW5 8LE Nantwich
    The Smithy
    Cheshire
    British134974090001
    ADAMS, Laurence George
    15 Rolley Way
    Castlefields
    NE42 5FH Prudhoe
    Northumberland
    Director
    15 Rolley Way
    Castlefields
    NE42 5FH Prudhoe
    Northumberland
    EnglandBritish87979230002
    BRIERLEY, Philip
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Director
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish54808010002
    CORBISHLEY, Michael
    Overidge Farm Beckside
    Cartmel
    LA11 7SP Grange-Over-Sands
    Cumbria
    Director
    Overidge Farm Beckside
    Cartmel
    LA11 7SP Grange-Over-Sands
    Cumbria
    EnglandBritish101553180002
    COULSON, William Andrew
    40 Holly Avenue
    Jesmond
    NE2 2PY Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    40 Holly Avenue
    Jesmond
    NE2 2PY Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish36723860001
    CUTCHIE, Anthony William
    68 Davison Avenue
    NE26 3SU Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Director
    68 Davison Avenue
    NE26 3SU Whitley Bay
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish45955990001
    DAWSON, John Frederic
    Park Dale
    LS29 6LW Menston
    1
    West Yorkshire
    Director
    Park Dale
    LS29 6LW Menston
    1
    West Yorkshire
    British8366360002
    ELLIOTT, Stanley, Fcma
    12 Killiebrigs
    Heddon On The Wall
    NE15 0DD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    12 Killiebrigs
    Heddon On The Wall
    NE15 0DD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British7203790001
    FLEETWOOD, Christopher John
    4 The Meadows
    DL10 7DU Richmond
    North Yorkshire
    Director
    4 The Meadows
    DL10 7DU Richmond
    North Yorkshire
    United KingdomBritish1718030001
    FOSTER, Robert Simon
    Aish
    TQ10 9JG South Brent
    Stamford
    Devon
    Director
    Aish
    TQ10 9JG South Brent
    Stamford
    Devon
    EnglandBritish134973970001
    GOODENOUGH, Anthony
    Bakery Drive
    Grange Park
    TS19 0SN Stockton-On-Tees
    1
    Cleveland
    Director
    Bakery Drive
    Grange Park
    TS19 0SN Stockton-On-Tees
    1
    Cleveland
    EnglandBritish139196050001
    IREDALE, George Henry Cecil
    Redmays
    14 North Lodge Lambton Park
    DH3 4AZ Chester Le Street
    County Durham
    Director
    Redmays
    14 North Lodge Lambton Park
    DH3 4AZ Chester Le Street
    County Durham
    British141871680001
    JACKSON, David James
    10 Stone Rings Close
    HG2 9HZ Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    10 Stone Rings Close
    HG2 9HZ Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish62867720010
    JESTER, Tony
    6 Cranbourne Drive
    TS10 2SP Redcar
    Cleveland
    Director
    6 Cranbourne Drive
    TS10 2SP Redcar
    Cleveland
    EnglandBritish107694130001
    JOHNSON, Raymond
    1 Colville Court
    DH9 6UW East Stanley
    County Durham
    Director
    1 Colville Court
    DH9 6UW East Stanley
    County Durham
    EnglandBritish266049760001
    KELLY, Christopher John
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Director
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish188444350001
    LEWIS-JONES, Christopher
    Monks Lane
    Acton
    CW5 8LE Nantwich
    The Smithy
    Cheshire
    Director
    Monks Lane
    Acton
    CW5 8LE Nantwich
    The Smithy
    Cheshire
    EnglandBritish134974090001
    MARTINDALE, Stephen Richard
    Am Waldeck 14
    FOREIGN 34537 Bad Wildungen
    Germany
    Director
    Am Waldeck 14
    FOREIGN 34537 Bad Wildungen
    Germany
    GermanyBritish77194110002
    O'KANE, John Peter
    Station Lane
    Burton Leonard
    HG3 3RU Harrogate
    Holly Cottage
    North Yorkshire
    Director
    Station Lane
    Burton Leonard
    HG3 3RU Harrogate
    Holly Cottage
    North Yorkshire
    United KingdomIrish106172200001
    OLIVER, Malcolm William
    12c Burtree Lane
    DL3 0XQ Darlington
    County Durham
    Director
    12c Burtree Lane
    DL3 0XQ Darlington
    County Durham
    EnglandBritish143300760001
    PEARSON, Wayne
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Director
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish212154420001
    PENDLETON, Alan George
    12 Harrop Road
    Hale
    WA15 9BX Altrincham
    Cheshire
    Director
    12 Harrop Road
    Hale
    WA15 9BX Altrincham
    Cheshire
    British30248370001
    PRICE, Anthony Hall
    Irton
    CA19 1UZ Holmrook
    Mecklin
    Cumbria
    Director
    Irton
    CA19 1UZ Holmrook
    Mecklin
    Cumbria
    EnglandBritish134973860001
    SHIPPEN, Kenneth
    14 Rectory Park
    NE61 2SZ Morpeth
    Northumberland
    Director
    14 Rectory Park
    NE61 2SZ Morpeth
    Northumberland
    British67917400001
    SHUTTLEWORTH, Richard Peter
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Red Hall Court
    WF1 2UN Wakefield
    1
    West Yorkshire
    England
    Director
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Red Hall Court
    WF1 2UN Wakefield
    1
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish58727820002
    TAYLOR, William Platt
    Ryton House
    Mainsforth
    DL17 9AA Ferryhill
    County Durham
    Director
    Ryton House
    Mainsforth
    DL17 9AA Ferryhill
    County Durham
    British7203810001
    WARDLE, Peter
    14 Brandling Park
    Jesmond
    NE2 4RR Newcastle Upon Tyne
    Director
    14 Brandling Park
    Jesmond
    NE2 4RR Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish73518260002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CHIEFTAIN GROUP LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Redhall Group Plc
    Calder Close
    Durkar
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    England
    06 abr 2016
    Calder Close
    Durkar
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    England
    No
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro263995
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene CHIEFTAIN GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 24 ene 2019
    Entregado el 29 ene 2019
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Downing LLP (As Security Trustee)
    Transacciones
    • 29 ene 2019Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 24 ene 2019
    Entregado el 29 ene 2019
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • (1) 1798 Volantis Fund Limited and (2) 1798 Volantis Catalyst Fund Limited
    Transacciones
    • 29 ene 2019Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 24 dic 2015
    Entregado el 02 ene 2016
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Alphagen Volantis Catalyst Fund Limited
    • Alphagen Volantis Fund Limited
    Transacciones
    • 02 ene 2016Registro de una carga (MR01)
    Debenture
    Creado el 21 ene 2011
    Entregado el 28 ene 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 28 ene 2011Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 30 abr 2009
    Entregado el 09 may 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 09 may 2009Registro de un cargo (395)
    • 11 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creado el 28 may 2004
    Entregado el 17 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 20 ago 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 09 sept 1996
    Entregado el 12 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Dean smith & grace model 20SB surfacing and boring lathe 29IN swing serial no 28803 richards model PR2N horizontal facing and boring machine serial no 28803 atlas copco model GA708 packaged rotary screw air compressor serial no 753329 and 753330 for further details please see form 395.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 sept 1996Registro de un cargo (395)
    • 11 jul 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 ago 1996
    Entregado el 13 ago 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Premises at bath street walker newcastle upon tyne tyne and wear t/no:- ty 7137. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 ago 1996Registro de un cargo (395)
    • 20 ago 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 02 nov 1994
    Entregado el 11 nov 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 nov 1994Registro de un cargo (395)
    • 20 ago 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 26 ago 1992
    Entregado el 09 sept 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    See doc ref M593C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 sept 1992Registro de un cargo (395)
    • 20 ago 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 20 ene 1988
    Entregado el 05 feb 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 feb 1988Registro de una carga
    • 20 ago 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 03 jun 1985
    Entregado el 11 jun 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that land at arrow close, killingwood north tyneside, tyne & wear with the factory premises t/n ty 157748.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 jun 1985Registro de una carga
    • 20 ago 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 21 sept 1984
    Entregado el 28 sept 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or sheaffer fabrications limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 28 sept 1984Registro de una carga
    • 20 ago 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0