BREVIS MARKETING SERVICES LIMITED

BREVIS MARKETING SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBREVIS MARKETING SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01457020
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BREVIS MARKETING SERVICES LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra BREVIS MARKETING SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o MOTIVCOM PLC
    Avalon House Breckland
    Linford Wood
    MK14 6LD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BREVIS MARKETING SERVICES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para BREVIS MARKETING SERVICES LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BREVIS MARKETING SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Estado de capital el 08 oct 2015

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2014

    1 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 06 mar 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 mar 2015

    Estado de capital el 10 mar 2015

    • Capital: GBP 70,000
    SH01

    Nombramiento de Sebastien Raymond De Tramasure como director el 21 nov 2014

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Sebastien Desire Paul Godet como director el 21 nov 2014

    3 páginasAP01

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resoluciones

    The restriction of capital is hereby revoked and deleted 21/11/2014
    RES13

    Cese del nombramiento de David Christopher Lebond como director el 21 nov 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Murray Sylvester como director el 21 nov 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nigel Phillip Cooper como director el 20 nov 2014

    1 páginasTM01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2013

    1 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 06 mar 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 mar 2014

    Estado de capital el 07 mar 2014

    • Capital: GBP 70,000
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2012

    1 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 06 mar 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2011

    1 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 06 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Nigel Phillip Cooper el 27 may 2011

    2 páginasCH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2010

    1 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de * Rockingham Drive Linford Wood Milton Keynes Buckinghamshire MK14 6LY* el 21 mar 2011

    1 páginasAD01

    ¿Quiénes son los directivos de BREVIS MARKETING SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HOCKEN, Susan Ann
    7 The Knoll
    Ealing
    W13 8HZ London
    Secretario
    7 The Knoll
    Ealing
    W13 8HZ London
    British9833560001
    DE TRAMASURE, Sebastien Raymond
    c/o Motivcom Plc
    Breckland
    Linford Wood
    MK14 6LD Milton Keynes
    Avalon House
    Buckinghamshire
    Director
    c/o Motivcom Plc
    Breckland
    Linford Wood
    MK14 6LD Milton Keynes
    Avalon House
    Buckinghamshire
    FranceFrenchChief Finacial Officer172688760001
    GODET, Sebastien Desire Paul
    c/o Motivcom Plc
    Breckland
    Linford Wood
    MK14 6LD Milton Keynes
    Avalon House
    Buckinghamshire
    Director
    c/o Motivcom Plc
    Breckland
    Linford Wood
    MK14 6LD Milton Keynes
    Avalon House
    Buckinghamshire
    FranceFrenchGift Market Ceo193534940001
    HOCKEN, Susan Ann
    7 The Knoll
    Ealing
    W13 8HZ London
    Director
    7 The Knoll
    Ealing
    W13 8HZ London
    EnglandBritishChartered Accountant9833560001
    ARMSTRONG, David Frank
    2 Mayfield Close
    KT12 5PR Walton On Thames
    Surrey
    Secretario
    2 Mayfield Close
    KT12 5PR Walton On Thames
    Surrey
    British7390540001
    BASHAM, David
    Garden Cottage
    The Green
    NN13 5JX Turweston
    Northamptonshire
    Secretario
    Garden Cottage
    The Green
    NN13 5JX Turweston
    Northamptonshire
    BritishCompany Director83199820001
    ARMSTRONG, David Frank
    2 Mayfield Close
    KT12 5PR Walton On Thames
    Surrey
    Director
    2 Mayfield Close
    KT12 5PR Walton On Thames
    Surrey
    United KingdomBritishTravel Executive7390540001
    BASHAM, David
    Garden Cottage
    The Green
    NN13 5JX Turweston
    Northamptonshire
    Director
    Garden Cottage
    The Green
    NN13 5JX Turweston
    Northamptonshire
    BritishCompany Director83199820001
    BRENCHLEY, William Ian
    Manor House Farm
    Beckerings Park Lidlington
    MK43 0RA Bedford
    Director
    Manor House Farm
    Beckerings Park Lidlington
    MK43 0RA Bedford
    BritishTravel Executive7390550001
    COOPER, Nigel Phillip
    c/o Motivcom Plc
    Breckland
    Linford Wood
    MK14 6LD Milton Keynes
    Avalon House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    c/o Motivcom Plc
    Breckland
    Linford Wood
    MK14 6LD Milton Keynes
    Avalon House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector241240690001
    FISHER, John
    8 The Chestnuts
    Radley Road
    OX14 3YN Abingdon
    Oxfordshire
    Director
    8 The Chestnuts
    Radley Road
    OX14 3YN Abingdon
    Oxfordshire
    BritishMarketing75380310001
    LEBOND, David Christopher
    The Oaks
    2 Noah's Court Gardens
    SG138FD Hertford
    Hertfordshire
    Director
    The Oaks
    2 Noah's Court Gardens
    SG138FD Hertford
    Hertfordshire
    EnglandBritishManaging Director59555260003
    MOY, Anthony Gibson
    The Grange Dingley Road
    Great Bowden
    LE16 7ET Market Harborough
    Leicestershire
    Director
    The Grange Dingley Road
    Great Bowden
    LE16 7ET Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritishCompany Director62053990001
    SYLVESTER, John Murray
    Barnett House
    Barnett Way Bierton
    HP22 5DN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    Barnett House
    Barnett Way Bierton
    HP22 5DN Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector58011420002
    THOMAS, Diane Margaret
    32 Cotney Croft
    SG2 9PT Stevenage
    Hertfordshire
    Director
    32 Cotney Croft
    SG2 9PT Stevenage
    Hertfordshire
    BritishAccountant57501550001
    THOMAS, Diane Margaret
    32 Cotney Croft
    SG2 9PT Stevenage
    Hertfordshire
    Director
    32 Cotney Croft
    SG2 9PT Stevenage
    Hertfordshire
    BritishAccountant57501550001
    TULLETT, Andrew John
    Twin Oaks
    Buckland Common
    PH23 6NQ Tring
    Hertfordshire
    Director
    Twin Oaks
    Buckland Common
    PH23 6NQ Tring
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector111975800001

    ¿Tiene BREVIS MARKETING SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 17 abr 2003
    Entregado el 25 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 25 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 27 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 22 abr 1998
    Entregado el 25 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 25 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 02 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 oct 1996
    Entregado el 22 oct 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 22 oct 1996Registro de un cargo (395)
    • 02 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 31 ago 1993
    Entregado el 06 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H-239 st albans road watford hertfordshire together with all fixtures and fittings and the benefits of all rights licences and goodwill.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 06 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 20 abr 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 03 feb 1986
    Entregado el 17 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever not exceeding sterling pounds 40000
    Breve descripción
    All moneys neweratanry time hereqbtes standing to the credit of any account (5) of the company with the bouls desingnated barclays bauls PLC re breins marketing services limited.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 feb 1986Registro de una carga
    • 14 abr 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 20 ago 1981
    Entregado el 26 ago 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H 178 st albans road watford herts.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 26 ago 1981Registro de una carga
    • 14 abr 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0