PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED

PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01458009
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CHARTWELL LAND INVESTMENTS LIMITED09 ago 198809 ago 1988
    CHARTWELL INVESTMENT LIMITED18 abr 198818 abr 1988
    WOOLWORTH PROPERTIES (GROUP INVESTMENT) LIMITED30 ene 198730 ene 1987
    COMPSTONE LIMITED31 oct 197931 oct 1979

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2022

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Estado de capital el 07 dic 2022

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Virginia Warr como director el 03 nov 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Gavin Bergin como director el 03 nov 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jonathan Charles Mcnuff como director el 03 nov 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022

    4 páginasAA

    Cese del nombramiento de Charles John Middleton como director el 31 mar 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Virginia Warr como director el 18 mar 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Bruce Michael James como director el 31 dic 2021

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2021

    4 páginasAA

    Nombramiento de Mr Gavin Bergin como director el 29 mar 2021

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Nick Taunt como director el 05 oct 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Tom Robson como director el 11 sept 2020

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2020

    4 páginasAA

    Nombramiento de Josephine Hayman como director el 31 ene 2020

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Tom Robson como director el 31 ene 2020

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro8992198
    187856670001
    HAYMAN, Josephine
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish266797860001
    TAUNT, Nicholas Henry
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish275050860001
    CLIFTON, Sally Jane
    Braeside
    Old Micheldever Road
    SP11 7AF Longparish
    Hampshire
    Secretario
    Braeside
    Old Micheldever Road
    SP11 7AF Longparish
    Hampshire
    British77925190001
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Secretario
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    British61314280001
    LAWLEY, Anne Katharine
    25 Parkside
    17 Hamilton Road Ealing
    W5 2EG London
    Secretario
    25 Parkside
    17 Hamilton Road Ealing
    W5 2EG London
    British39298940001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretario
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    SHILLINGLAW, Gary Preston
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    Secretario
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    British66825690001
    STOKES, Martin Howard
    1 Hazel Grove
    SO22 4PQ Winchester
    Hampshire
    Secretario
    1 Hazel Grove
    SO22 4PQ Winchester
    Hampshire
    British7345750001
    AYRE, Timothy Andrew
    14 Ridgmont Road
    AL1 3AF St Albans
    Hertfordshire
    Director
    14 Ridgmont Road
    AL1 3AF St Albans
    Hertfordshire
    British1440830002
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritish32809050044
    BERGIN, Gavin Joseph
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish251327820001
    BLUNDELL, Roger Frederick Crawford
    Vineyard Hill Road
    SW19 7JL London
    61
    Director
    Vineyard Hill Road
    SW19 7JL London
    61
    EnglandBritish56525730002
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Director
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritish152497530001
    BURGESS, Richard John
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    Director
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)British35427700001
    CARTER, Colin James
    6 Hawthorn Close
    Firtree Road
    SM7 1ND Banstead
    Surrey
    Director
    6 Hawthorn Close
    Firtree Road
    SM7 1ND Banstead
    Surrey
    British39118310002
    CARTER, Simon Geoffrey
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Director
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritish78691990003
    COLEMAN, David Michael
    Downings 18 Uplands Way
    Riverhead
    TN13 3BW Sevenoaks
    Kent
    Director
    Downings 18 Uplands Way
    Riverhead
    TN13 3BW Sevenoaks
    Kent
    British2305220001
    CREEDY, Mark Peter
    18 The Broadwalk
    HA6 2XD Northwood
    Middlesex
    Director
    18 The Broadwalk
    HA6 2XD Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish11841300002
    CUTT, Michael Caslake
    Cedar House
    Coombe Lane Sunninghill
    SL5 7AT Ascot
    Berkshire
    Director
    Cedar House
    Coombe Lane Sunninghill
    SL5 7AT Ascot
    Berkshire
    British72423090001
    ELLIOTT, Mark Steven
    1 Elmwood
    AL8 6LD Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    1 Elmwood
    AL8 6LD Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish59140240001
    FLEMING, Keith
    Dairy Cottage, Church Barns
    Church Bank Road, East Stratton
    SO21 3XA Winchester
    Hampshire
    Director
    Dairy Cottage, Church Barns
    Church Bank Road, East Stratton
    SO21 3XA Winchester
    Hampshire
    British96487450002
    GARDEN, Ian Graham
    10 Prairie Street
    SW8 3PU London
    Director
    10 Prairie Street
    SW8 3PU London
    British64361460001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    HARTWELL, Terrance
    Brambledene
    231 Winchester Road
    SO53 2DX Chandlers Ford
    Hampshire
    Director
    Brambledene
    231 Winchester Road
    SO53 2DX Chandlers Ford
    Hampshire
    United KingdomBritish147043140001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Director
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    British51688320001
    JAMES, Bruce Michael
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish226746900001
    JONES, Alan Arnold
    Laurel Cottages
    Pump Meadow
    HP16 9EW Great Missenden
    Buckinghamshire
    Director
    Laurel Cottages
    Pump Meadow
    HP16 9EW Great Missenden
    Buckinghamshire
    British1440820003
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Director
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    LIGHT, Arthur Nicolas
    88 Peperharow Road
    GU7 2PN Godalming
    Surrey
    Director
    88 Peperharow Road
    GU7 2PN Godalming
    Surrey
    British851100001
    LINDSAY, Niall Gordon Brock
    Flat 4
    8 Edge Hill
    SW19 4LP London
    Director
    Flat 4
    8 Edge Hill
    SW19 4LP London
    British62950250002
    MARSH, John Charles
    25 Cambridge Street
    TN2 4SJ Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    25 Cambridge Street
    TN2 4SJ Tunbridge Wells
    Kent
    British59140360001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Project Sunrise Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 abr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security deposit deed
    Creado el 24 jul 1998
    Entregado el 31 jul 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under an agreement dated 7 july 1995
    Breve descripción
    £174,526.03.
    Personas con derecho
    • Stargas Nominees Limited
    Transacciones
    • 31 jul 1998Registro de un cargo (395)
    • 19 jun 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed legal charge
    Creado el 20 jun 1994
    Entregado el 21 jun 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the provisions of the principal agreement and under the terms of the legal charge
    Breve descripción
    F/H-17, 18 and 19 northbrook street newbury berkshire t/n-BK55827. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Somerfield Stores Limited
    Transacciones
    • 21 jun 1994Registro de un cargo (395)
    • 31 oct 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 dic 1988
    Entregado el 11 ene 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Sterling pounds 2000000 and all monies due or to be come due from the company and/or portswood developments limited to the chargee under the terms of an option agreement dated 23.12.88
    Breve descripción
    Land and buildings on the south side of bridge street dover kent title no k 621901 (part) title no k 476373 (whole).
    Personas con derecho
    • Co-Operative Retail Services Limited
    Transacciones
    • 11 ene 1989Registro de una carga
    • 01 oct 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 dic 1988
    Entregado el 11 ene 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Sterling pounds 1500000 and all other monies due or to be come due from the company to the chargee under the terms of an option agreement dated 23.12.88
    Breve descripción
    Land and buildings on the south side of bridge street dover kent title no k 621901.
    Personas con derecho
    • Co-Operative Retail Services Limited
    Transacciones
    • 11 ene 1989Registro de una carga
    • 01 oct 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security
    Creado el 14 nov 1986
    Entregado el 25 nov 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Various subjects shown on the form 395 refer for details.
    Personas con derecho
    • John G Mc Gregor (Holdings)
    Transacciones
    • 25 nov 1986Registro de una carga
    • 11 oct 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0