PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01458009 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CHARTWELL LAND INVESTMENTS LIMITED | 09 ago 1988 | 09 ago 1988 |
| CHARTWELL INVESTMENT LIMITED | 18 abr 1988 | 18 abr 1988 |
| WOOLWORTH PROPERTIES (GROUP INVESTMENT) LIMITED | 30 ene 1987 | 30 ene 1987 |
| COMPSTONE LIMITED | 31 oct 1979 | 31 oct 1979 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2022 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Estado de capital el 07 dic 2022
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Virginia Warr como director el 03 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gavin Bergin como director el 03 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jonathan Charles Mcnuff como director el 03 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Charles John Middleton como director el 31 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Virginia Warr como director el 18 mar 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Bruce Michael James como director el 31 dic 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2021 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Gavin Bergin como director el 29 mar 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaraci ón de confirmación presentada el 30 sept 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Nick Taunt como director el 05 oct 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Tom Robson como director el 11 sept 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2020 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Josephine Hayman como director el 31 ene 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Tom Robson como director el 31 ene 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| HAYMAN, Josephine | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 266797860001 | |||||||||
| TAUNT, Nicholas Henry | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 275050860001 | |||||||||
| CLIFTON, Sally Jane | Secretario | Braeside Old Micheldever Road SP11 7AF Longparish Hampshire | British | 77925190001 | ||||||||||
| EKPO, Ndiana | Secretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
| ENOCH, Simon Jocelyn | Secretario | 38 Chiddingstone Street Fulham SW6 3TG London | British | 61314280001 | ||||||||||
| LAWLEY, Anne Katharine | Secretario | 25 Parkside 17 Hamilton Road Ealing W5 2EG London | British | 39298940001 | ||||||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Secretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
| SHILLINGLAW, Gary Preston | Secretario | Wynsdale 9 Monkshanger GU9 8BU Farnham Surrey | British | 66825690001 | ||||||||||
| STOKES, Martin Howard | Secretario | 1 Hazel Grove SO22 4PQ Winchester Hampshire | British | 7345750001 | ||||||||||
| AYRE, Timothy Andrew | Director | 14 Ridgmont Road AL1 3AF St Albans Hertfordshire | British | 1440830002 | ||||||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 32809050044 | |||||||||
| BERGIN, Gavin Joseph | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 251327820001 | |||||||||
| BLUNDELL, Roger Frederick Crawford | Director | Vineyard Hill Road SW19 7JL London 61 | England | British | 56525730002 | |||||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Director | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||||||
| BURGESS, Richard John | Director | 54 Manor Road SM2 7AG Cheam Surrey | United Kingdom ( England ) (Gb-Eng) | British | 35427700001 | |||||||||
| CARTER, Colin James | Director | 6 Hawthorn Close Firtree Road SM7 1ND Banstead Surrey | British | 39118310002 | ||||||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 170891060001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Director | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||||||
| COLEMAN, David Michael | Director | Downings 18 Uplands Way Riverhead TN13 3BW Sevenoaks Kent | British | 2305220001 | ||||||||||
| CREEDY, Mark Peter | Director | 18 The Broadwalk HA6 2XD Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 11841300002 | |||||||||
| CUTT, Michael Caslake | Director | Cedar House Coombe Lane Sunninghill SL5 7AT Ascot Berkshire | British | 72423090001 | ||||||||||
| ELLIOTT, Mark Steven | Director | 1 Elmwood AL8 6LD Welwyn Garden City Hertfordshire | England | British | 59140240001 | |||||||||
| FLEMING, Keith | Director | Dairy Cottage, Church Barns Church Bank Road, East Stratton SO21 3XA Winchester Hampshire | British | 96487450002 | ||||||||||
| GARDEN, Ian Graham | Director | 10 Prairie Street SW8 3PU London | British | 64361460001 | ||||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| HARTWELL, Terrance | Director | Brambledene 231 Winchester Road SO53 2DX Chandlers Ford Hampshire | United Kingdom | British | 147043140001 | |||||||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Director | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||||||
| JAMES, Bruce Michael | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 226746900001 | |||||||||
| JONES, Alan Arnold | Director | Laurel Cottages Pump Meadow HP16 9EW Great Missenden Buckinghamshire | British | 1440820003 | ||||||||||
| JONES, Andrew Marc | Director | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| LIGHT, Arthur Nicolas | Director | 88 Peperharow Road GU7 2PN Godalming Surrey | British | 851100001 | ||||||||||
| LINDSAY, Niall Gordon Brock | Director | Flat 4 8 Edge Hill SW19 4LP London | British | 62950250002 | ||||||||||
| MARSH, John Charles | Director | 25 Cambridge Street TN2 4SJ Tunbridge Wells Kent | British | 59140360001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project Sunrise Limited | 06 abr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
¿Tiene PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Security deposit deed | Creado el 24 jul 1998 Entregado el 31 jul 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under an agreement dated 7 july 1995 | |
Breve descripción £174,526.03. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed legal charge | Creado el 20 jun 1994 Entregado el 21 jun 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the provisions of the principal agreement and under the terms of the legal charge | |
Breve descripción F/H-17, 18 and 19 northbrook street newbury berkshire t/n-BK55827. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 23 dic 1988 Entregado el 11 ene 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Sterling pounds 2000000 and all monies due or to be come due from the company and/or portswood developments limited to the chargee under the terms of an option agreement dated 23.12.88 | |
Breve descripción Land and buildings on the south side of bridge street dover kent title no k 621901 (part) title no k 476373 (whole). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 23 dic 1988 Entregado el 11 ene 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Sterling pounds 1500000 and all other monies due or to be come due from the company to the chargee under the terms of an option agreement dated 23.12.88 | |
Breve descripción Land and buildings on the south side of bridge street dover kent title no k 621901. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 14 nov 1986 Entregado el 25 nov 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Various subjects shown on the form 395 refer for details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0