JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED

JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaJAMES BUDGETT SUGARS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01472422
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    JAMES BUDGETT & SON LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    LEGIBUS SEVENTY-TWO LIMITED11 ene 198011 ene 1980

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 19 mar 2014

    7 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 19 mar 2013

    6 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de Ccw Recovery Solutions Llp Jaeger House 5 Clanricarde Gardens Tunbridge Wells Kent TN1 1PE el 28 nov 2012

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de 229 Crown Street Liverpool Merseyside L8 7RF United Kingdom el 28 mar 2012

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    4 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 19 mar 2012

    • Capital: GBP 1.00
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación del Memorándum y/o Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Cancellation of share premium account and / or capital redemption reserve 19/03/2012
    RES13

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2010

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2009

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 may 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Stephen Heslop como director

    1 páginasTM01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    8 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas190

    legacy

    1 páginas353

    legacy

    1 páginas287

    ¿Quiénes son los directivos de JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    NEWMAN, David Paul
    6 Pear Tree Hill
    Salfords
    RH1 5EG Redhill
    Surrey
    Secretario
    6 Pear Tree Hill
    Salfords
    RH1 5EG Redhill
    Surrey
    British19717140001
    MCDONOUGH, Michael John
    2 Cathedral Close
    SK16 5RN Dukinfield
    Cheshire
    Director
    2 Cathedral Close
    SK16 5RN Dukinfield
    Cheshire
    United KingdomBritish21094260001
    BARRELL, Simon Gregory
    11 Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    Hertfordshire
    Secretario
    11 Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    Hertfordshire
    British41674130001
    FRIER, Alan Leslie
    45 Blackmore Road
    Kelvedon Common
    CM15 0AZ Brentwood
    Essex
    Secretario
    45 Blackmore Road
    Kelvedon Common
    CM15 0AZ Brentwood
    Essex
    British2828040001
    GREGORY, Neil Ralph
    45 Roman Road
    CM4 9AA Ingatestone
    Essex
    Secretario
    45 Roman Road
    CM4 9AA Ingatestone
    Essex
    British9184890001
    HUTCHINSON, Katherine Anna
    52 Pentney Road
    SW12 0NY London
    Secretario
    52 Pentney Road
    SW12 0NY London
    British9289720002
    MACFARLANE, David
    Churchfields House
    Codicote
    SG4 8TH Hitchin
    Hertfordshire
    Secretario
    Churchfields House
    Codicote
    SG4 8TH Hitchin
    Hertfordshire
    British67838620001
    MARCUS, Anthony Herbert Mervyn
    43 Elm Park Mansions
    Park Walk
    SW10 0AW London
    Secretario
    43 Elm Park Mansions
    Park Walk
    SW10 0AW London
    British32970002
    MOORE, Jane Alison
    5 Flag House
    47 Brunswick Court
    SE1 3LH London
    Secretario
    5 Flag House
    47 Brunswick Court
    SE1 3LH London
    British65320720002
    WITHERS, Gavin David
    1 Eversleigh Road
    EN5 1NE Barnet
    Hertfordshire
    Secretario
    1 Eversleigh Road
    EN5 1NE Barnet
    Hertfordshire
    British70079100001
    BARRATT, David
    12 Leeward Quay
    Sovereign Harbour
    BN23 5UD Eastbourne
    Sussex
    Director
    12 Leeward Quay
    Sovereign Harbour
    BN23 5UD Eastbourne
    Sussex
    EnglandBritish17037520008
    BARRELL, Simon Gregory
    11 Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    Hertfordshire
    Director
    11 Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    Hertfordshire
    British41674130001
    BRADY, John Patrick, Dr
    Waterstown House
    IRISH Sallins
    Co Kildare
    Ireland
    Director
    Waterstown House
    IRISH Sallins
    Co Kildare
    Ireland
    Irish80642440001
    CAMFIELD, Lee Mark, Mr.
    Waterloo Farm
    Mill Lane
    HP22 4PH Wingrave
    Buckinghamshire
    Director
    Waterloo Farm
    Mill Lane
    HP22 4PH Wingrave
    Buckinghamshire
    EnglandBritish98252290001
    DILGER, David John
    Lauriston Cenacle Grove
    Killiney Hill Road
    Killiney
    Co Dublin
    Ireland
    Director
    Lauriston Cenacle Grove
    Killiney Hill Road
    Killiney
    Co Dublin
    Ireland
    Irish74455510001
    FINK, Stanley, Lord
    13 The Broadwalk
    HA6 2XF Northwood
    Middlesex
    Director
    13 The Broadwalk
    HA6 2XF Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish118515860001
    FOSTER, Peter David
    70 Chignal Road
    CM1 2JB Chelmsford
    Essex
    Director
    70 Chignal Road
    CM1 2JB Chelmsford
    Essex
    British25037710001
    GIBSON, John Frederick
    Dipley Road
    Hartley Witney
    RG27 8JP Hook
    Old Orchard House
    Director
    Dipley Road
    Hartley Witney
    RG27 8JP Hook
    Old Orchard House
    EnglandBritish128842240001
    HEAPHY, William Anthony
    10 Eaton Brae
    Orwell Road
    Dublin 6
    Ireland
    Director
    10 Eaton Brae
    Orwell Road
    Dublin 6
    Ireland
    Irish17037540001
    HESLOP, Stephen
    Aberlyn
    KY11 3DP Charlestown
    Fyfe
    Director
    Aberlyn
    KY11 3DP Charlestown
    Fyfe
    ScotlandBritish153863130001
    JANSSIS, Joseph Charles
    14 Carlton Road
    RH1 2BX Redhill
    Surrey
    Director
    14 Carlton Road
    RH1 2BX Redhill
    Surrey
    United KingdomBritish38048490001
    KINDER, John Martineau
    55 Thornhill Square
    N1 1BE London
    Director
    55 Thornhill Square
    N1 1BE London
    United KingdomBritish1578300001
    MUGUIRO SARTORIUS, Rafael
    14 Alexander Square
    SW3 2AX London
    Director
    14 Alexander Square
    SW3 2AX London
    United KingdomSpanish58967780003
    MURPHY, Gerard Martin, Dr
    Treetops
    2 Moyleen Rise
    SL7 2DP Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    Treetops
    2 Moyleen Rise
    SL7 2DP Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish43480870002
    O'HANLON, Paul Anthony
    27 Theberton Street
    Islington
    N1 0QY London
    Director
    27 Theberton Street
    Islington
    N1 0QY London
    EnglandBritish2828050001
    SCOTT, Andrew Hillyer
    Lower Lye
    Holloway, East Knoyle
    SP3 6AQ Salisbury
    Wiltshire
    Director
    Lower Lye
    Holloway, East Knoyle
    SP3 6AQ Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish64012720001
    STONE, Michael John Christopher
    Ozleworth Park
    GL12 7QA Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    Director
    Ozleworth Park
    GL12 7QA Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    United KingdomBritish35563920001
    THOMAS, Christopher Owen
    22 Woodlands Road
    SW13 0JZ London
    Director
    22 Woodlands Road
    SW13 0JZ London
    EnglandBritish9213140002
    VESTERDAL, Niels
    51b Longridge Road
    SW5 9SF London
    Director
    51b Longridge Road
    SW5 9SF London
    United KingdomDanish66012460002
    WITHERS, Gavin David
    1 Eversleigh Road
    EN5 1NE Barnet
    Hertfordshire
    Director
    1 Eversleigh Road
    EN5 1NE Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish70079100001

    ¿Tiene JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed and floating charge
    Creado el 07 jul 2004
    Entregado el 23 jul 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transacciones
    • 23 jul 2004Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 07 jul 2004
    Entregado el 10 jul 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 10 jul 2004Registro de un cargo (395)

    ¿Tiene JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    20 mar 2012Inicio de la liquidación
    19 abr 2015Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Vincent John Green
    Ccw Recovery Solutions Llp Jaeger House
    5 Clanricarde Gardens
    TN1 1PE Tunbridge Wells
    Kent
    Profesional
    Ccw Recovery Solutions Llp Jaeger House
    5 Clanricarde Gardens
    TN1 1PE Tunbridge Wells
    Kent
    Mark Newman
    Ccw Recovery Solutions Llp Jaeger House
    5 Clanricarde Gardens
    TN1 1PE Tunbridge Wells
    Kent
    Profesional
    Ccw Recovery Solutions Llp Jaeger House
    5 Clanricarde Gardens
    TN1 1PE Tunbridge Wells
    Kent

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0